TURBOFLEX LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TURBOFLEX LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00839728 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TURBOFLEX LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o BIBBY TRANSMISSIONS Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TURBOFLEX LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour TURBOFLEX LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||||||
État du capital au 29 déc. 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 04 déc. 2017
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Carl Richard Christenson le 10 nov. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Varga en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Richard Ian Laws en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Penelope Turvey en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Nomination de Graham Varga en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TURBOFLEX LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWS, Richard Ian | Secrétaire | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | 182626840001 | |||||||
| CHRISTENSON, Carl Richard | Administrateur | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | United States | American | 110880800002 | |||||
| STORCH, Christian | Administrateur | 12 Preston Square Quincy Massachusetts Ma 02171 United States | United States | German | 126884910001 | |||||
| AGOCS, Stephen Francis | Secrétaire | 128 Upper Ferry Road Trenton New Jersey FOREIGN Usa | American | 34721300001 | ||||||
| BALDREY, Philip Nigel | Secrétaire | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | British | 44039650003 | ||||||
| BIRD, Thomas Joseph | Secrétaire | 1211 Karen Lane 19087 Radnor Pennsylvania Usa | Usa | 33616600001 | ||||||
| BUCKLEY, Deryck Stephen | Secrétaire | 9 Halifax Road Staincliffe WF13 4AA Dewsbury West Yorkshire | British | 47883800001 | ||||||
| COOPER, James Sidney William | Secrétaire | 11 The Croft Meriden CV7 7NQ Coventry | British | 33253280001 | ||||||
| FITZPATRICK, Stephen Joseph | Secrétaire | The Maltings Carlton-On-Trent NG23 6NS Newark Nottinghamshire | British | 204911280005 | ||||||
| HALE, Vivien Joan | Secrétaire | Keeley 12 Gables Meadow Holmer Green HP15 6RT High Wycombe Buckinghamshire | British | 56115110001 | ||||||
| HALLAM, Peter Leslie | Secrétaire | 25 Cambridge Road PE9 1BN Stamford Lincolnshire | British | 2258630001 | ||||||
| HARRISON, Brian | Secrétaire | 16 Briarwood Road GU21 1XD Woking Surrey | British | 13648350001 | ||||||
| TURVEY, Penelope Ann | Secrétaire | 182 High Street PE19 6SD Yelling Cambs | British | 103094630002 | ||||||
| VARGA, Graham | Secrétaire | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | British | 168160770001 | ||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||
| ABLITT, Ivor Geoffrey | Administrateur | 15 Tattershall Drive Market Deeping PE6 8BS Peterborough Cambridgeshire | British | 3848360001 | ||||||
| AGOCS, Stephen Francis | Administrateur | 128 Upper Ferry Road Trenton New Jersey FOREIGN Usa | American | 34721300001 | ||||||
| BALDREY, Philip Nigel | Administrateur | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | England | British | 44039650003 | |||||
| BUCKLEY, Deryck Stephen | Administrateur | 9 Halifax Road Staincliffe WF13 4AA Dewsbury West Yorkshire | British | 47883800001 | ||||||
| BURDETT, Roger Leonard | Administrateur | 2 Pennyfields Boulevard NG10 3QJ Long Eaton Nottinghamshire | British | 53792200005 | ||||||
| BURDETT, Roger | Administrateur | Yew Tree Cottage Mill Lane Lapworth B94 6HT Solihull West Midlands | British | 53792200004 | ||||||
| BURNS, Christopher Peter | Administrateur | Peters Farm Sulgrave Road Helmdon NN13 5QH Brackley Northamptonshire | British | 29017860001 | ||||||
| COOPER, James Sidney William | Administrateur | 11 The Croft Meriden CV7 7NQ Coventry | British | 33253280001 | ||||||
| FITZPATRICK, Stephen Joseph | Administrateur | The Maltings Carlton-On-Trent NG23 6NS Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | 204911280005 | |||||
| FOX, David John | Administrateur | 58 North End Road Quainton HP22 4BG Aylesbury Buckinghamshire | British | 4519410001 | ||||||
| HALE, Vivien Joan | Administrateur | Keeley 12 Gables Meadow Holmer Green HP15 6RT High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 56115110001 | |||||
| HERBAGE, Bernard Stanley | Administrateur | Tanglewood Lodge Sycamore Road HP6 6BB Amersham Buckinghamshire | British | 36629450001 | ||||||
| HOCKLEY, Donald Keith | Administrateur | 6 East Ridge SL8 5BX Bourne End Buckinghamshire | British | 13685820001 | ||||||
| KEITH, Percival Cleveland | Administrateur | 1 Turvey Close Aston Clinton HP22 5JG Aylesbury Buckinghamshire | American | 13648320001 | ||||||
| LEWIS, Brian | Administrateur | The Hyde Mountnessing Road Blackmore CM4 0NX Ingatestone Essex | British | 18905160001 | ||||||
| LOVE, Colin Wilson | Administrateur | 3 Andrews Way Raunds NN9 6RD Wellingborough Northamptonshire | British | 65767530002 | ||||||
| MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham | Administrateur | The Hatch Gaunts Common BH21 4JB Wimborne Dorset | England | English | 13447260001 | |||||
| MCKELLER, Lawson | Administrateur | 122 Sheerstock HP17 8EX Haddenham Buckinghamshire | British | 40188720001 | ||||||
| MIDSON, Anthony John | Administrateur | 27 Wymering Road HP21 9BP Aylesbury Buckinghamshire | British | 13685830001 | ||||||
| RODGER, David Anthony Hugh | Administrateur | Oaktrees Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | British | 89739630001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TURBOFLEX LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibby Transmissions Limited | 14 déc. 2016 | Cannon Way WF13 1EH Dewsbury Bibby Transmissions Ltd West Yorkshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TURBOFLEX LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 08 mars 2007 Livré le 10 mars 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 juil. 2000 Livré le 25 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 juil. 2000 Livré le 25 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the mezzanine documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge | Créé le 27 mars 1997 Livré le 08 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future sums, liabilities or obligations from time to time due, owing or incurred (actually or contingently) by chargeready limited (the principal borrower) or any other group company to the chargee as agent and security trustee for the beneficiaries (as defined) under or in connection with the facilities agreement (as defined) and/or any other senior finance document (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts patents buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over stocks shares or other securities | Créé le 11 févr. 1994 Livré le 28 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a mortgage debenture dated 28 may 1993 | |
Brèves mentions A specific charge over all stocks shares or other securities in any subsidiary companies or any other company for the time being. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over credit balances | Créé le 01 oct. 1993 Livré le 21 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The sum of £32,500 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 83557997 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 28 mai 1993 Livré le 08 juin 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0