TURBOFLEX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTURBOFLEX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00839728
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TURBOFLEX LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TURBOFLEX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BIBBY TRANSMISSIONS
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TURBOFLEX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour TURBOFLEX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 déc. 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Revoke auth cap restrictions 04/12/2017
    RES13

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 04 déc. 2017

    • Capital: GBP 1,717,000
    3 pagesSH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 déc. 2015

    État du capital au 14 déc. 2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2014

    État du capital au 16 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Carl Richard Christenson le 10 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 déc. 2013

    État du capital au 19 déc. 2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Graham Varga en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Richard Ian Laws en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Penelope Turvey en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Graham Varga en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de TURBOFLEX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAWS, Richard Ian
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Secrétaire
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    182626840001
    CHRISTENSON, Carl Richard
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Administrateur
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    United StatesAmerican110880800002
    STORCH, Christian
    12 Preston Square
    Quincy
    Massachusetts Ma 02171
    United States
    Administrateur
    12 Preston Square
    Quincy
    Massachusetts Ma 02171
    United States
    United StatesGerman126884910001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Secrétaire
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    British44039650003
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Secrétaire
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    BUCKLEY, Deryck Stephen
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    Secrétaire
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    British47883800001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Secrétaire
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    FITZPATRICK, Stephen Joseph
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    British204911280005
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    British56115110001
    HALLAM, Peter Leslie
    25 Cambridge Road
    PE9 1BN Stamford
    Lincolnshire
    Secrétaire
    25 Cambridge Road
    PE9 1BN Stamford
    Lincolnshire
    British2258630001
    HARRISON, Brian
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    Secrétaire
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    British13648350001
    TURVEY, Penelope Ann
    182 High Street
    PE19 6SD Yelling
    Cambs
    Secrétaire
    182 High Street
    PE19 6SD Yelling
    Cambs
    British103094630002
    VARGA, Graham
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Secrétaire
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    British168160770001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secrétaire
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    ABLITT, Ivor Geoffrey
    15 Tattershall Drive
    Market Deeping
    PE6 8BS Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    15 Tattershall Drive
    Market Deeping
    PE6 8BS Peterborough
    Cambridgeshire
    British3848360001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish44039650003
    BUCKLEY, Deryck Stephen
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    British47883800001
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    British53792200005
    BURDETT, Roger
    Yew Tree Cottage Mill Lane
    Lapworth
    B94 6HT Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Yew Tree Cottage Mill Lane
    Lapworth
    B94 6HT Solihull
    West Midlands
    British53792200004
    BURNS, Christopher Peter
    Peters Farm
    Sulgrave Road Helmdon
    NN13 5QH Brackley
    Northamptonshire
    Administrateur
    Peters Farm
    Sulgrave Road Helmdon
    NN13 5QH Brackley
    Northamptonshire
    British29017860001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Administrateur
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    FITZPATRICK, Stephen Joseph
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish204911280005
    FOX, David John
    58 North End Road
    Quainton
    HP22 4BG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    58 North End Road
    Quainton
    HP22 4BG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British4519410001
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish56115110001
    HERBAGE, Bernard Stanley
    Tanglewood Lodge
    Sycamore Road
    HP6 6BB Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Tanglewood Lodge
    Sycamore Road
    HP6 6BB Amersham
    Buckinghamshire
    British36629450001
    HOCKLEY, Donald Keith
    6 East Ridge
    SL8 5BX Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    6 East Ridge
    SL8 5BX Bourne End
    Buckinghamshire
    British13685820001
    KEITH, Percival Cleveland
    1 Turvey Close
    Aston Clinton
    HP22 5JG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Turvey Close
    Aston Clinton
    HP22 5JG Aylesbury
    Buckinghamshire
    American13648320001
    LEWIS, Brian
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    Administrateur
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    British18905160001
    LOVE, Colin Wilson
    3 Andrews Way
    Raunds
    NN9 6RD Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    3 Andrews Way
    Raunds
    NN9 6RD Wellingborough
    Northamptonshire
    British65767530002
    MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    EnglandEnglish13447260001
    MCKELLER, Lawson
    122 Sheerstock
    HP17 8EX Haddenham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    122 Sheerstock
    HP17 8EX Haddenham
    Buckinghamshire
    British40188720001
    MIDSON, Anthony John
    27 Wymering Road
    HP21 9BP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    27 Wymering Road
    HP21 9BP Aylesbury
    Buckinghamshire
    British13685830001
    RODGER, David Anthony Hugh
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    Administrateur
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    British89739630001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TURBOFLEX LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    Bibby Transmissions Ltd
    West Yorkshire
    England
    14 déc. 2016
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    Bibby Transmissions Ltd
    West Yorkshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUk Companies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement158829
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TURBOFLEX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 mars 2007
    Livré le 10 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2000
    Livré le 25 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 25 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2000
    Livré le 25 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the mezzanine documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mithras Investment Trust,as Facility Agent for Itself and the Other Secured Parties,as Defined
    Transactions
    • 25 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and supplemental charge
    Créé le 27 mars 1997
    Livré le 08 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future sums, liabilities or obligations from time to time due, owing or incurred (actually or contingently) by chargeready limited (the principal borrower) or any other group company to the chargee as agent and security trustee for the beneficiaries (as defined) under or in connection with the facilities agreement (as defined) and/or any other senior finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts patents buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over stocks shares or other securities
    Créé le 11 févr. 1994
    Livré le 28 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a mortgage debenture dated 28 may 1993
    Brèves mentions
    A specific charge over all stocks shares or other securities in any subsidiary companies or any other company for the time being.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 01 oct. 1993
    Livré le 21 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £32,500 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 83557997 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 mai 1993
    Livré le 08 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0