F & W (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéF & W (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00840995
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de F & W (UK) LIMITED ?

    • Édition de livres (58110) / Information et communication

    Où se situe F & W (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de F & W (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    F&W MEDIA INTERNATIONAL LTD27 janv. 201127 janv. 2011
    DAVID & CHARLES LIMITED16 août 198916 août 1989
    DAVID & CHARLES PUBLISHERS PLC. 14 oct. 198514 oct. 1985

    Quels sont les derniers comptes de F & W (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour F & W (UK) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour F & W (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Satisfaction de la charge 008409950011 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Brunel House Forde Close Newton Abbot Devon TQ12 4PU à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 15 déc. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 nov. 2014

    LRESSP

    Inscription de la charge 008409950011, créée le 27 nov. 2014

    18 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2013 au 28 févr. 2014

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 avr. 2014

    État du capital au 29 avr. 2014

    • Capital: GBP 1,460,440
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed f&w media international LTD\certificate issued on 06/01/14
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name06 janv. 2014

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de * Brunel Hse. Forde Rd. Newton Abbot TQ12 4UB* le 23 oct. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de F & W (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOOT ANSTEY SECRETARIAL LIMITED
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    United Kingdom
    Secrétaire
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03485060
    116388540001
    DOMVILLE, Sara
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Administrateur
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    UsaBritishPresident Book Division114533660004
    NUSSBAUM, David
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Administrateur
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    UsaAmericanChairman & Ceo136460940003
    OGLE, James
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Administrateur
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    United StatesAmericanFinance136390690001
    GAISFORD, James Dominic
    Priors Court
    Sunnyfield
    EX5 3EW Broadclyst
    Devon
    Secrétaire
    Priors Court
    Sunnyfield
    EX5 3EW Broadclyst
    Devon
    BritishFinance Director154455640001
    MACKLIN, Peter Douglas
    16 Pridhams Way
    Exminster
    EX6 8TA Exeter
    Secrétaire
    16 Pridhams Way
    Exminster
    EX6 8TA Exeter
    BritishFinance Director45844150002
    NUSSBAUM, David
    The Pines
    11576 Roslyn Estates
    7
    New York
    United States
    Secrétaire
    The Pines
    11576 Roslyn Estates
    7
    New York
    United States
    AmericanChairman & Ceo136460940003
    PAGE, Neil Antony
    Orchard Way
    Belle Vue Road
    EX4 5BD Exeter
    Devon
    Secrétaire
    Orchard Way
    Belle Vue Road
    EX4 5BD Exeter
    Devon
    British14682630003
    PAGE, Neil Antony
    13 Colleton Mews
    EX2 4AH Exeter
    Devon
    Secrétaire
    13 Colleton Mews
    EX2 4AH Exeter
    Devon
    British14682630001
    ANGELAKIS, Michael
    24 Cedar Avenue
    Barrington 02806
    FOREIGN Ri Usa
    Administrateur
    24 Cedar Avenue
    Barrington 02806
    FOREIGN Ri Usa
    AmericanEquity Investor80875930001
    ARNETT, Mark Forrest
    913 Caitlin Drive
    Union
    Kentucky
    Usa
    Administrateur
    913 Caitlin Drive
    Union
    Kentucky
    Usa
    AmericanDirector71012410001
    BRADY, Peter
    42 Dukes Wood Drive
    SL9 7LR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    42 Dukes Wood Drive
    SL9 7LR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    UkBritishChartered Accountant8674650001
    DOMINGUEZ, Michael
    6 Alden Road
    Barrinton 02806
    FOREIGN Ri Usa
    Administrateur
    6 Alden Road
    Barrinton 02806
    FOREIGN Ri Usa
    AmericanEquity Investor80876040001
    GAISFORD, James Dominic
    Priors Court
    Sunnyfield
    EX5 3EW Broadclyst
    Devon
    Administrateur
    Priors Court
    Sunnyfield
    EX5 3EW Broadclyst
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director154455640001
    GODWIN, Lesley
    20 Hazelhurst
    BR3 5TL Beckenham
    Kent
    Administrateur
    20 Hazelhurst
    BR3 5TL Beckenham
    Kent
    BritishMarketing Director57640100001
    GRAY, Brian Charles
    109a Uxbridge Road
    Hampton Hill
    TW12 1SL Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    109a Uxbridge Road
    Hampton Hill
    TW12 1SL Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Accountant2277860001
    KENT, Stephen James
    19 Garden Place
    45208 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    Administrateur
    19 Garden Place
    45208 Cincinnati
    Ohio
    Usa
    AmericanDirector71012470001
    LOASBY, Nicholas
    40 Highweek Village
    TQ12 1QQ Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    40 Highweek Village
    TQ12 1QQ Newton Abbot
    Devon
    BritishChief Executive59003550001
    MACINNIS, Robert
    30 Oxbow Circle
    N. Andover, Ma
    01845
    Usa
    Administrateur
    30 Oxbow Circle
    N. Andover, Ma
    01845
    Usa
    UsaBusiness Executive108685160001
    MACKLIN, Peter Douglas
    16 Pridhams Way
    Exminster
    EX6 8TA Exeter
    Administrateur
    16 Pridhams Way
    Exminster
    EX6 8TA Exeter
    BritishFinance Director45844150002
    MCRAE, Stuart Neil
    Newstead Shaldon Road
    Teignharvey
    TQ12 4RS Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Newstead Shaldon Road
    Teignharvey
    TQ12 4RS Newton Abbot
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director2277940001
    MCRAE, Stuart Neil
    Newstead Shaldon Road
    Teignharvey
    TQ12 4RS Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Newstead Shaldon Road
    Teignharvey
    TQ12 4RS Newton Abbot
    Devon
    United KingdomBritishChairman2277940001
    MORRERO, Roger
    225 Commonwealth Ave Apartment 2
    Boston
    Ma 02116
    Usa
    Administrateur
    225 Commonwealth Ave Apartment 2
    Boston
    Ma 02116
    Usa
    UsaBusiness Executive108685230001
    NEWTON, Amanda Jane
    11 Gourders Lane
    Kingskerswell
    TQ12 5DZ Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    11 Gourders Lane
    Kingskerswell
    TQ12 5DZ Newton Abbot
    Devon
    BritishOperations Dir53316390001
    PAETKE, Ann Nicole
    44 Barton Road
    TQ1 4DP Torquay
    Devon
    Administrateur
    44 Barton Road
    TQ1 4DP Torquay
    Devon
    BritishMarketing Director29859790001
    PAGE, Neil Antony
    Orchard Way
    Belle Vue Road
    EX4 5BD Exeter
    Devon
    Administrateur
    Orchard Way
    Belle Vue Road
    EX4 5BD Exeter
    Devon
    United KingdomBritishDirector14682630003
    SAGE, Colin Arthur
    30 Whidborne Avenue
    TQ1 2PQ Torquay
    Devon
    Administrateur
    30 Whidborne Avenue
    TQ1 2PQ Torquay
    Devon
    BritishOperations Director54731310001
    SPENCE, Piers Macmillan
    1 Victoria Park Road
    EX2 4NT Exeter
    Devon
    Administrateur
    1 Victoria Park Road
    EX2 4NT Exeter
    Devon
    BritishPublisher50935610002
    STEWARD, David Howard
    470 East Galbraith Road
    Cincinnati
    45236
    Us
    Administrateur
    470 East Galbraith Road
    Cincinnati
    45236
    Us
    UsaExecutive107719080001
    STUBBS, Terence Keith
    Biddlecombe Ugbrooke
    Chudleigh
    TQ13 0AD Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Biddlecombe Ugbrooke
    Chudleigh
    TQ13 0AD Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritishManaging Director74026170002
    TOWNSEND, John Richard
    Fairlea Redwood Road
    EX10 9AB Sidmouth
    Devon
    Administrateur
    Fairlea Redwood Road
    EX10 9AB Sidmouth
    Devon
    BritishDirector3437700001

    F & W (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2014
    Livré le 02 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of rent deposit between the company and david and charles limited
    Créé le 19 mai 1998
    Livré le 09 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of the tenant to the chargee under a lease dated 19TH may 1998 and all other obligations under this deed
    Brèves mentions
    Sum of £21,500 plus vat and any other sums from time to time deposited in a separate designated deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Rank Nemo (Gc) Limited
    Transactions
    • 09 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 01 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 01 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 janv. 1997
    Livré le 28 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £450,000 and interest due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The f/h property k/a carriage house and brunel house forde road newton abbot devon t/n's DN160333 and DN118554.
    Personnes ayant droit
    • The Reader's Digest Association Limited
    Transactions
    • 28 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 21 janv. 1997
    Livré le 23 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property brunel house forde road newton abbot together with all buildings fixtures (inc.trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon fixed charge all present and future book and other debts all rental monies the goodwill of business at the property benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juin 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 17 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 21 janv. 1997
    Livré le 23 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a or being land and buildings on the north west side of forde road newton abbot t/no;-DN160333 together with all buildings and fixtures (inc.trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon all present and future book debts and rental monies the goodwill of the business at the property all present and future licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture deed
    Créé le 21 janv. 1997
    Livré le 23 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 12 juil. 1989
    Livré le 18 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/as carriage house, forde road, newton abbot, devon.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 17 mai 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 17 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 05 oct. 1983
    Livré le 19 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book and other debts. Floating charge over (see doc. M90).. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 19 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 22 sept. 1981
    Livré le 25 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H & l/h properties present & future with fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery goodwill & uncalled capital present & future undertaking all other property & assets present & future inc. Heritable property & assets in scotland. Fixed & floating charge (see doc M88).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 17 mai 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 31 juil. 1981
    Livré le 12 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Brunel house, newton abbot, devon.
    Personnes ayant droit
    • Phoenix Assurance Company Limited
    Transactions
    • 12 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    F & W (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 nov. 2014Commencement of winding up
    26 janv. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0