GLEN SALVESEN LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GLEN SALVESEN LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00841330 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GLEN SALVESEN LIMITED ?
| Adresse du siège social | Fisher House Michaelson Road PO BOX 4 LA14 1HR Barrow In Furness Cumbria |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GLEN SALVESEN LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour GLEN SALVESEN LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 11 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Paul Henry le 01 janv. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 14 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Shields en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Stuart Charles Kilpatrick en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Jonathan Procter Vick en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Justin Tyler en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 11 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Justin John Blakeney Tyler le 01 janv. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 12 pages | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 12 pages | AA | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GLEN SALVESEN LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICK, Jonathan Procter | Secrétaire | Fisher House Michaelson Road PO BOX 4 LA14 1HR Barrow In Furness Cumbria | British | 154037080001 | ||||||
| HENRY, Nicholas Paul | Administrateur | Fisher House Michaelson Road PO BOX 4 LA14 1HR Barrow In Furness Cumbria | England | British | 102250610003 | |||||
| KILPATRICK, Stuart Charles | Administrateur | Fisher House Michaelson Road PO BOX 4 LA14 1HR Barrow In Furness Cumbria | United Kingdom | British | 109536720001 | |||||
| CASEBOW, Ethel Annie | Secrétaire | The Priory Palgrave IP22 1AJ Diss Norfolk | British | 400640003 | ||||||
| MITCHELL, Reginald Arthur | Secrétaire | Jawton Tower Road BR6 0SG Orpington Kent | British | 23132170002 | ||||||
| ROPER, Stephen Dawson | Secrétaire | 89 Discovery Drive Kings Hill ME19 4DJ West Malling | British | 52304290002 | ||||||
| TYLER, Justin John Blakeney | Secrétaire | Fisher House Michaelson Road PO BOX 4 LA14 1HR Barrow In Furness Cumbria | British | 116694740001 | ||||||
| CASEBOW, Ethel Annie | Administrateur | The Priory Palgrave IP22 1AJ Diss Norfolk | British | 400640003 | ||||||
| EVERARD, Frederick Michael | Administrateur | Windy Ridge Blackhall Lane TN15 0HP Sevenoaks Kent | England | United Kingdom | 8637510001 | |||||
| EVERARD, William Derek | Administrateur | 4 Lee Terrace Blackheath SE3 9TZ London | England | British | 8079410001 | |||||
| SHIELDS, Michael John | Administrateur | 14 West Avenue LA13 9AX Barrow In Furness Cumbria | England | British | 12781030001 | |||||
| SHOTTON, Rosemary Ann | Administrateur | Pennis House Pennis Lane Fawkham DA3 8LZ Longfield Kent | United Kingdom | British | 55366380001 |
GLEN SALVESEN LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment in relation to M.V. 'supremity' | Créé le 28 sept. 2007 Livré le 16 oct. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti An amount not exceeding $50,400,000 and all other monies due or to become due | |
Brèves mentions All the right title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 13 févr. 2007 Livré le 02 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti An amount not exceeding $50,400,00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The insurances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 18 sept. 2006 Livré le 30 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti The aggregate from time ot time not exceeding $50,400,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right, title and interest, in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 08 mai 2006 Livré le 09 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due not exceeding $50,400,000 and all other monies payable to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right, title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 31 mars 2006 Livré le 13 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due not exceeding $50,400,000 and all other monies payable to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 31 mars 2006 Livré le 13 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due not exceeding $50,400,000 and all other monies payable to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0