GLEN SALVESEN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLEN SALVESEN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00841330
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLEN SALVESEN LIMITED ?

    • (7450) /

    Où se situe GLEN SALVESEN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GLEN SALVESEN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour GLEN SALVESEN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 avr. 2011

    État du capital au 07 avr. 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Paul Henry le 01 janv. 2011

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    14 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 02/02/2011
    RES13

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Cessation de la nomination de Michael Shields en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Stuart Charles Kilpatrick en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Jonathan Procter Vick en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Justin Tyler en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Justin John Blakeney Tyler le 01 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GLEN SALVESEN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VICK, Jonathan Procter
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    Secrétaire
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    British154037080001
    HENRY, Nicholas Paul
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    Administrateur
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    EnglandBritish102250610003
    KILPATRICK, Stuart Charles
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    Administrateur
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    United KingdomBritish109536720001
    CASEBOW, Ethel Annie
    The Priory
    Palgrave
    IP22 1AJ Diss
    Norfolk
    Secrétaire
    The Priory
    Palgrave
    IP22 1AJ Diss
    Norfolk
    British400640003
    MITCHELL, Reginald Arthur
    Jawton Tower Road
    BR6 0SG Orpington
    Kent
    Secrétaire
    Jawton Tower Road
    BR6 0SG Orpington
    Kent
    British23132170002
    ROPER, Stephen Dawson
    89 Discovery Drive
    Kings Hill
    ME19 4DJ West Malling
    Secrétaire
    89 Discovery Drive
    Kings Hill
    ME19 4DJ West Malling
    British52304290002
    TYLER, Justin John Blakeney
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    Secrétaire
    Fisher House Michaelson Road
    PO BOX 4
    LA14 1HR Barrow In Furness
    Cumbria
    British116694740001
    CASEBOW, Ethel Annie
    The Priory
    Palgrave
    IP22 1AJ Diss
    Norfolk
    Administrateur
    The Priory
    Palgrave
    IP22 1AJ Diss
    Norfolk
    British400640003
    EVERARD, Frederick Michael
    Windy Ridge
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Windy Ridge
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    EnglandUnited Kingdom8637510001
    EVERARD, William Derek
    4 Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    Administrateur
    4 Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    EnglandBritish8079410001
    SHIELDS, Michael John
    14 West Avenue
    LA13 9AX Barrow In Furness
    Cumbria
    Administrateur
    14 West Avenue
    LA13 9AX Barrow In Furness
    Cumbria
    EnglandBritish12781030001
    SHOTTON, Rosemary Ann
    Pennis House
    Pennis Lane Fawkham
    DA3 8LZ Longfield
    Kent
    Administrateur
    Pennis House
    Pennis Lane Fawkham
    DA3 8LZ Longfield
    Kent
    United KingdomBritish55366380001

    GLEN SALVESEN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment in relation to M.V. 'supremity'
    Créé le 28 sept. 2007
    Livré le 16 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An amount not exceeding $50,400,000 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    All the right title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 13 févr. 2007
    Livré le 02 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An amount not exceeding $50,400,00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The insurances.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 18 sept. 2006
    Livré le 30 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate from time ot time not exceeding $50,400,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest, in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 08 mai 2006
    Livré le 09 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due not exceeding $50,400,000 and all other monies payable to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 13 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due not exceeding $50,400,000 and all other monies payable to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 13 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due not exceeding $50,400,000 and all other monies payable to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0