CIRCAST ELECTRONICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCIRCAST ELECTRONICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00845942
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CIRCAST ELECTRONICS LIMITED ?

    • (3210) /

    Où se situe CIRCAST ELECTRONICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Langley House Park Road
    East Finchley
    N2 8EX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CIRCAST ELECTRONICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour CIRCAST ELECTRONICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    13 pages1.4

    legacy

    2 pages363a

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 déc. 2006

    20 pagesAA

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 31 mai 2007

    7 pages1.3

    legacy

    2 pages363a

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 déc. 2005

    22 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages395

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    13 pages1.1

    legacy

    2 pages288a

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 déc. 2004

    23 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    1 pages225

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    9 pages395

    Qui sont les dirigeants de CIRCAST ELECTRONICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    URRY, Michael Frederick
    49 Hercules Road
    NR6 5HQ Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    49 Hercules Road
    NR6 5HQ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director4310490001
    BAILEY, Richard John
    83 Millside
    NR12 9PB Stalham
    Norfolk
    Secrétaire
    83 Millside
    NR12 9PB Stalham
    Norfolk
    British103474740001
    BOTWRIGHT, Raymond Norman
    21 Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    21 Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    British1602200001
    BOTWRIGHT, Raymond Norman
    21 Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    21 Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    British1602200001
    SHEPHERD, Margaret Florence
    8 Meadow Close
    Lillington
    CV32 7AS Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    8 Meadow Close
    Lillington
    CV32 7AS Leamington Spa
    Warwickshire
    British30546510001
    BAILEY, Richard John
    83 Millside
    NR12 9PB Stalham
    Norfolk
    Administrateur
    83 Millside
    NR12 9PB Stalham
    Norfolk
    BritishManufacturing103474740001
    BENCH, Robert John
    41 Rawnsley Drive
    CV8 2NX Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    41 Rawnsley Drive
    CV8 2NX Kenilworth
    Warwickshire
    BritishSales Director10369240001
    BROMAGE, Philip Alan
    71 Rutherford Avenue
    ST5 4JD Newcastle
    Staffordshire
    Administrateur
    71 Rutherford Avenue
    ST5 4JD Newcastle
    Staffordshire
    BritishTechnical Director36244690003
    FISH, David
    237 Leamington Road
    CV3 6NB Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    237 Leamington Road
    CV3 6NB Coventry
    West Midlands
    BritishTechnical Director10369250001
    GEANEY, Bartholomew
    58 Stratford Road
    CV34 6AT Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    58 Stratford Road
    CV34 6AT Warwick
    Warwickshire
    BritishProduction Director10369270001
    HALL, Andrew Ralph
    36 Woodcote Lane
    Leek Wootton
    CV35 7QF Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    36 Woodcote Lane
    Leek Wootton
    CV35 7QF Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishEngineer10369280001
    JONES, Peter Melvyn
    Fernie Cottage Catthorpe
    Lutterworth
    LE17 6DB Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    Fernie Cottage Catthorpe
    Lutterworth
    LE17 6DB Leicester
    Leicestershire
    BritishQuality Director10369260001
    MCCLUE, William Alan
    Littlebrook
    Poulner Hill
    BH24 3HR Ringwood
    Hampshire
    Administrateur
    Littlebrook
    Poulner Hill
    BH24 3HR Ringwood
    Hampshire
    BritishPetroleum Engineer2121310001
    STACEY, Anthony Edward
    Appletree Cottage
    Manchester Road, Sway
    SO41 6AS Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Appletree Cottage
    Manchester Road, Sway
    SO41 6AS Lymington
    Hampshire
    BritishChartered Accountant68664990001

    CIRCAST ELECTRONICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 juin 2006
    Livré le 28 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aston Rothbury Factors Limited
    Transactions
    • 28 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 20 oct. 2004
    Livré le 05 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC (The Lender)
    Transactions
    • 05 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 2001
    Livré le 08 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 oct. 2001
    Livré le 08 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land and buildings on the west side of ramsey road, sydenham industrial estate, leamington spa, warwickshire t/ns WK54072 and WK179745.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 oct. 2001
    Livré le 08 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land and buildings at 14-18B highdown road, sydenham industrial estate, leamington spa, warwickshire t/n WK263786.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juil. 2001
    Livré le 03 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land and buildings known as 14-18B highdown road sydenham industrial estate leamington spa warwickshire title number WK263786.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 juil. 2001
    Livré le 03 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juil. 2001
    Livré le 03 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the west side of ramsey road sydenham industrial estate leamington spa warwickshire t/nos: WK54072 and WK179745.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 avr. 1998
    Livré le 07 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge over all discounted/other debts and all rights under any supply contract; floating charge over the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 07 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 1996
    Livré le 11 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a land and premises on the west side of ramsey road sydenham industrial estate leamington spa t/n WK54072 and WK179745 with the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 déc. 1996
    Livré le 06 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 1996
    Livré le 06 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 14 - 18B highdown road, sydenham industrial estate, leamington spa t/no: WK263786 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 juin 1994
    Livré le 07 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 07 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A credit agreement
    Créé le 15 sept. 1992
    Livré le 24 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £16346.70 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 24 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Schmid desmear and pummice cleaning line 7 section plus load and unload units, control panel etc together with the benefit of all contracts warranties and guarantees (see doc M195C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Excellon XL5 drilling & routing machine, serial no. 578: together with the benefit of all contracts, warranties & guarantees. (See doc M191C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Vision 105G auto optical inspection machine; serial no 58: together with the benefit of all contracts, warranties & guarantees. (See doc M193C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Mk vi b drilling machine with cnc 6 control serial no. 335; together with the benefit of all contracts, warranties & guarantees. (See doc m 192C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Black oxide line with micro etch aikain dip oxidation chamber (2M) cascade rinse hot air dryer & controls etc: together with the benefit of all contracts, warranties & guarantees (see doc M196C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fully automatic twin expansion transporter acid copper and tin/lead pattern plating plant with fume extraction hydro etch off line separation tanks rectifiers, jigs etc together with the benefit of all contracts warranties and guarantees (see doc m/94C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Automatic model 1024 resist laminator: serial no. 038: together with the benefit of all contracts, warranties & guarantees. (See doc m 197C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hot air levelling line comprising pretreatment by hibass hot air levelling by eyrex together with benefit of all contracts warranties and guarantees (see doc M133C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Tower type 3936 bare board test machine serial number 371125-89 together with the benefit of all contracts warranties and guarantees (see doc M132C).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 23 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery all intellectual property rights choses in action and claims.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CIRCAST ELECTRONICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juin 2006Date of meeting to approve CVA
    21 mai 2008Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan Simon
    Langley House Park Road
    N2 8EY London
    practitioner
    Langley House Park Road
    N2 8EY London
    2
    DateType
    09 févr. 2010Conclusion of winding up
    28 mai 2008Petition date
    17 juil. 2008Commencement of winding up
    17 mai 2010Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Norwich
    1st Floor Sol House St Katherines Street
    NN1 2QZ Northampton
    Northamptonshire
    practitioner
    1st Floor Sol House St Katherines Street
    NN1 2QZ Northampton
    Northamptonshire
    Alan Simon
    Langley House Park Road
    N2 8EY London
    practitioner
    Langley House Park Road
    N2 8EY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0