PROTECTION ONE (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROTECTION ONE (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00851729
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROTECTION ONE (UK) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PROTECTION ONE (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROTECTION ONE (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROTECTION ONE (UK) PLC01 oct. 199801 oct. 1998
    HAMBRO COUNTRYWIDE SECURITY PLC 01 mars 199101 mars 1991
    SECURITE (POOLE) LIMITED15 juin 196515 juin 1965

    Quels sont les derniers comptes de PROTECTION ONE (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PROTECTION ONE (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 02 avr. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium reduced 13/03/2012
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Nomination de Andrew Bowie en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Kaye en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Roberts en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de PROTECTION ONE (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Secrétaire
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishAccountant79364980002
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant79364980002
    BOWIE, Andrew
    Grimshaw Lane
    Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    Tyco Park
    Administrateur
    Grimshaw Lane
    Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    Tyco Park
    United KingdomBritishAccountant140054660001
    BARON, David Michael
    12 Ridgeway
    Wargrave
    RG10 8AS Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    12 Ridgeway
    Wargrave
    RG10 8AS Reading
    Berkshire
    British106082970001
    CANNON, Peter Charles
    4 Lipscombe Close
    Herriard
    RG25 2PT Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    4 Lipscombe Close
    Herriard
    RG25 2PT Basingstoke
    Hampshire
    British62431310001
    CURTIS, John Mark
    15 Reads Field
    GU34 5XA Four Marks
    Hampshire
    Secrétaire
    15 Reads Field
    GU34 5XA Four Marks
    Hampshire
    BritishFinance Dir77468380001
    GODFRAY, Terence William
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    Secrétaire
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    British63510007
    LAW, Shirley Gaik Heah
    1 Warwick Gardens
    IG1 4LE Ilford
    Essex
    Secrétaire
    1 Warwick Gardens
    IG1 4LE Ilford
    Essex
    British3393430001
    BARON, David Michael
    12 Ridgeway
    Wargrave
    RG10 8AS Reading
    Berkshire
    Administrateur
    12 Ridgeway
    Wargrave
    RG10 8AS Reading
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant106082970001
    BATES, Gregor John
    Beech Close
    KT24 5PQ Effingham
    6
    Surrey
    Administrateur
    Beech Close
    KT24 5PQ Effingham
    6
    Surrey
    EnglandBritishFinancial Controller136682970001
    CLARK, Alistair Roy
    9 Farmington
    GL54 3NQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    9 Farmington
    GL54 3NQ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector62529860003
    CLARK, David Colin
    2 Downs Valley
    Hartley
    DA3 7RA Longfield
    Kent
    Administrateur
    2 Downs Valley
    Hartley
    DA3 7RA Longfield
    Kent
    BritishSales Director74911270001
    COOMBER, Frederick Walter
    Copse Edge 34 Tollway
    Chineham
    RG24 8RJ Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Copse Edge 34 Tollway
    Chineham
    RG24 8RJ Basingstoke
    Hampshire
    BritishTechnician21527140001
    CURTIS, John Mark
    15 Reads Field
    GU34 5XA Four Marks
    Hampshire
    Administrateur
    15 Reads Field
    GU34 5XA Four Marks
    Hampshire
    BritishFinance Dir77468380001
    GILL, James
    Westwood House
    The Green Nettlebed
    RG9 5AX Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Westwood House
    The Green Nettlebed
    RG9 5AX Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishBusiness Development Director10119790001
    HILL, Harry Douglas
    Moat Hall
    Fordham
    CO6 3LU Colchester
    Essex
    Administrateur
    Moat Hall
    Fordham
    CO6 3LU Colchester
    Essex
    EnglandBritishEstate Agent2505480001
    HOBBS, Keith Raymond
    Benwhyles
    Medstead
    GU34 5EA Alton
    Administrateur
    Benwhyles
    Medstead
    GU34 5EA Alton
    United KingdomBritishAccountant707020001
    KANTER, Ralph Thomas Ludwig
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    Administrateur
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    United KingdomBritishCompany Director124153720001
    KAYE, David Leo
    Security House
    The Summit Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Security House
    The Summit Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant76947780002
    LAKE, Douglas T
    3742 Sw Clarion Park Drive
    Topeka Ks 66610
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    3742 Sw Clarion Park Drive
    Topeka Ks 66610
    FOREIGN Usa
    AmericanExecutive Vice President70472700001
    MACK, John Erick
    427 El Medico Avenue
    Pacific Palisades Ca 90272
    FOREIGN California Usa
    Administrateur
    427 El Medico Avenue
    Pacific Palisades Ca 90272
    FOREIGN California Usa
    AmericanCompany Director59915980001
    MACKENZIE, James M
    3229 Leticia Dr
    Hacienda Heights California
    FOREIGN 91745 Usa
    Administrateur
    3229 Leticia Dr
    Hacienda Heights California
    FOREIGN 91745 Usa
    AmericanDirector58758490001
    MALONE, Steven Robert
    18 The Drove
    SO50 7NW Horton Heath
    Hampshire
    Administrateur
    18 The Drove
    SO50 7NW Horton Heath
    Hampshire
    BritishTechnical Director59633580002
    MAY, John Michael
    Hill House
    Arkesden
    CB11 4EX Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Hill House
    Arkesden
    CB11 4EX Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishJt Man/Dir Hambro Countrywide4877650012
    MCNUTT, Alexander Samuel
    8 Wood Aven Drive
    Stewartfield
    G74 4UE East Kilbride
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Wood Aven Drive
    Stewartfield
    G74 4UE East Kilbride
    Lanarkshire
    BritishDirector113348780001
    MENZIES WILSON, Charles Napier
    Newport House Newport Lane
    Braishfield
    SO51 0PL Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Newport House Newport Lane
    Braishfield
    SO51 0PL Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritishOperationa Director46123720001
    NOWER, Michael Charles
    12 Pebmarsh Road
    Colne Engaine
    CO6 2HD Colchester
    Administrateur désigné
    12 Pebmarsh Road
    Colne Engaine
    CO6 2HD Colchester
    British900011170001
    NOWER, Michael Charles
    12 Pebmarsh Road
    Colne Engaine
    CO6 2HD Colchester
    Administrateur désigné
    12 Pebmarsh Road
    Colne Engaine
    CO6 2HD Colchester
    British900011170001
    OSTER, Christopher
    Sussex Square
    W2 6SS London
    76
    Administrateur
    Sussex Square
    W2 6SS London
    76
    EnglandAmericanDirector, Global Tax Emea140080370001
    ROBERTS, David Edward
    Security Hse The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Security Hse The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishDirector58549730004
    SEDGLEY, Robert Alan
    36 Litchfield Way
    Hampstead Garden Suburbs
    NW11 6NJ London
    Administrateur
    36 Litchfield Way
    Hampstead Garden Suburbs
    NW11 6NJ London
    BritishDirector68531240003
    VERMEULEN, Arie Hendrikus
    Bay Cottage
    Edwin Road
    KT24 6LN West Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Bay Cottage
    Edwin Road
    KT24 6LN West Horsley
    Surrey
    NetherlandDirector53326380001
    WYLES, Andrew Tobias Michael
    21 Bishops Court
    Bishops Bridge Road
    W2 6BE London
    Administrateur
    21 Bishops Court
    Bishops Bridge Road
    W2 6BE London
    BritishVenture Capitalist37020030001

    PROTECTION ONE (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of bank account
    Créé le 25 janv. 1999
    Livré le 02 févr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan notes
    Brèves mentions
    All right title and interest of the company in and to the deposit of us$4,999,987.66 Deposited in account number 140-01-06880630.
    Personnes ayant droit
    • Guy Vincent, Michael Anthony Parker and Andrew Macdonald Smithas Agents and Trustees for the Noteholders (As Defined)
    Transactions
    • 02 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 août 1996
    Livré le 28 août 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Single debenture
    Créé le 28 nov. 1994
    Livré le 12 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Bank Limited
    Transactions
    • 12 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General debenture (fixed and floating charge)
    Créé le 16 août 1994
    Livré le 02 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the counter indemnities of even date given by hambro countrywide security PLC to each of "the lenders" or in respect of cash advances or loan facilities made available by "the lenders" (whether jointly or severally) to hambro countrywide security PLC pursuant to the £1,000,000 8% secured redeemable loan notes of the company
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Apax Ventures Iv
    • Apax Funds Nominees Limited ("the Lenders") (Whether Jointly or Severally)
    • Hambro Countrywide PLC
    • Apax Ventures Iv International Partners L.P.
    Transactions
    • 02 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0