EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED

EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00852171
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 11th Floor the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT United Kingdom à 79 Caroline Street Birmingham B3 1UP le 11 déc. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 déc. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Garry Elliot Barnes le 12 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de The Colemore Building Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT England à 11th Floor the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT le 21 mars 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 5 Fleet Place London EC4M 7rd England à The Colemore Building Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT le 01 nov. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Nomination de Garry Elliot Barnes en tant qu'administrateur le 03 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Jonathon Colin Fyfe Crawford en tant que secrétaire le 12 sept. 2016

    2 pagesAP03

    Nomination de Jonathon Colin Fyfe Crawford en tant qu'administrateur le 12 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin William Donnelly en tant que secrétaire le 12 sept. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Geoffrey Damien Morgan en tant qu'administrateur le 12 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew William Hughes en tant que directeur le 12 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin William Donnelly en tant que directeur le 12 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CRAWFORD, Jonathon Colin Fyfe
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    214011710001
    BARNES, Garry Elliot
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    Administrateur
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    United KingdomBritishTreasurer215490920001
    CRAWFORD, Jonathon Colin Fyfe
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    Administrateur
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    United KingdomAustralianLawyer214009850001
    MORGAN, Geoffrey Damien
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    Administrateur
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Head Of Tax214010060001
    DONNELLY, Kevin William
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Secrétaire
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    UsaVice-President General Counsel73249300002
    FORREST, Arthur Thomas
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    British8427680001
    TRANTER, John
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    BritishDirector34350840002
    BEESON, Richard
    Percuil 24 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Percuil 24 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    BritishFinance Director44855910004
    BREADY, Richard Lawrence
    166 President Avenue
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    Administrateur
    166 President Avenue
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    UsaAmericanChairman And Chief Executive70952970001
    COONEY, Edward Joseph
    Kennedy Plaza
    02903 Providence
    50
    Ri
    Usa
    Administrateur
    Kennedy Plaza
    02903 Providence
    50
    Ri
    Usa
    UsaUnited StatesVice President And Treasurer161515520001
    DONNELLY, Kevin William
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Administrateur
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Massachusetts UsaUsaGeneral Counsel73249300002
    DONNELLY, Kevin William
    11 Foxhunt Trail
    Walpole
    Massachusetts
    02081
    Usa
    Administrateur
    11 Foxhunt Trail
    Walpole
    Massachusetts
    02081
    Usa
    AmericanVice-President General Counsel73249300001
    FITTON, Andrew Charles
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director7527160002
    FORREST, Arthur Thomas
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director8427680001
    HALL, Almon Charles
    50 Kennedy Plaza
    02903 Providence
    Nortek Inc.
    Rhode Island
    Usa
    Administrateur
    50 Kennedy Plaza
    02903 Providence
    Nortek Inc.
    Rhode Island
    Usa
    United States Of AmericaAmericanSenior Vice President And Cfo177890560001
    HUGHES, Matthew William, Mr.
    Exchange Street
    02903 Providence
    500
    Ri
    Usa
    Administrateur
    Exchange Street
    02903 Providence
    500
    Ri
    Usa
    UsaAmericanTreasurer203597150001
    MARTIN, Gary Trevor
    34 Beauport Home Farm Close
    TN37 7BW St Leonards-On-Sea
    East Sussex
    Administrateur
    34 Beauport Home Farm Close
    TN37 7BW St Leonards-On-Sea
    East Sussex
    United KingdomBritishManaging Director7625370002
    SAMS, Ian James
    Fircroft Way
    TN8 6EZ Edenbridge
    C/O Eaton-Williams Group Limited
    Kent
    England
    Administrateur
    Fircroft Way
    TN8 6EZ Edenbridge
    C/O Eaton-Williams Group Limited
    Kent
    England
    EnglandBritishManaging Director141142710002
    STAPLEY, Gerald Charles
    Huntersgay Stables Mill Lane Cottage
    Petworth Road Witley
    GU8 5LZ Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Huntersgay Stables Mill Lane Cottage
    Petworth Road Witley
    GU8 5LZ Godalming
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director57940460001
    TRANTER, John
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishFinance Director34350840002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Eaton-Williams Group Limited
    Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    11th Floor, The Colmore Building
    England
    06 avr. 2016
    Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    11th Floor, The Colmore Building
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 08 juin 1995
    Livré le 20 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a fircroft station road edenbridge fixed charge over all buildings and structures all goodwill and the proceeds of any claims of insurance all plant machinery and other chattels by way of floating charge all unnatached plant machinery and chattels and by way of assignment the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 08 juin 1995
    Livré le 20 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit b edenbridge industrial estate fircroft way edenbridge with all buildings and structures and any goodwill all plant machinery and other chattels the proceeds of any insurance claims by way of floating charge all unattached plant machginery chattels and goods and by way of lrgal assignment the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 08 juin 1995
    Livré le 20 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a harleigh station road t/n KI73142 edenbridge and by way of fixed charge all goodwill,all plant machinery and other chattels and the proceeds of any insurance claim and by way of floating charge all unattached plant machinery and other chattels and by way of legal assignment the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 08 juin 1995
    Livré le 20 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    "Wickham" station road TN8 6EE by way of fixed charge all buildings and structures,all goodwill,plant machinery and other chattels and the proceeds of any insurance claims and by way of floating charge all unattached plant machinery chattels and goods and by way of assignment the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 08 juin 1995
    Livré le 20 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a factory site on the west side of station road edenbridge t/n K470263 fixed charges over all buildings,goodwill,plant machinery and other chattels the proceeds of any insurance claims and by way of floating charge all unnatached plant machinery and goods and by way of assignment the rental sums.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 juin 1995
    Livré le 20 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 08 juin 1995
    Livré le 20 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Under the terms of the guarantee the credit agreement or any of the other financing documents mortgage debenture
    Créé le 03 août 1990
    Livré le 15 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee f/h property factory west side station road edenbridge t/no r 470 263 (plase seedoc 395/7 119/l/15/8 for full detaith)
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerceas Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries (As Detined)
    Transactions
    • 15 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1984
    Livré le 06 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1984Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 27 févr. 1984
    Livré le 03 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to be come due form the ealon-williams group limited investersto the on any account whietespever
    Brèves mentions
    Floaling charge over undertaking and allproperty and assets present and future iincluding bookdebts goodwill uncalled ca.
    Personnes ayant droit
    • Investers in Industry PLC
    Transactions
    • 03 mars 1984Enregistrement d'une charge

    EATON-WILLIAMS PRODUCTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 déc. 2019Commencement of winding up
    19 nov. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Roderick Graham Butcher
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    practitioner
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0