PARITY TRAINING LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARITY TRAINING LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00855309
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARITY TRAINING LTD ?

    • (7260) /

    Où se situe PARITY TRAINING LTD ?

    Adresse du siège social
    c/o HBJ GATELEY WAREING LLP
    111 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARITY TRAINING LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CRAVE LEARNING LTD22 mars 201022 mars 2010
    PARITY TRAINING LIMITED11 juil. 199511 juil. 1995
    BIS TRAINING LIMITED18 oct. 199318 oct. 1993
    BIS INFORMATION SYSTEMS LIMITED01 déc. 199101 déc. 1991
    BIS APPLIED SYSTEMS LIMITED27 juil. 196527 juil. 1965

    Quels sont les derniers comptes de PARITY TRAINING LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PARITY TRAINING LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PARITY TRAINING LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    12 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mai 2014

    12 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mai 2013

    14 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 mai 2012

    6 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 mai 2011

    9 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 mai 2011

    10 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    9 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 09 déc. 2010

    7 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    9 pages2.23B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 120 Moorgate London EC2M 6SS le 11 août 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    25 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Shivani Saxena en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Shivani Saxena en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Komal Anil Serai en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Komal Anil Seral en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Akhil Ahamad Malikso en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ajeit Saksena en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed crave learning LTD\certificate issued on 24/03/10
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Certificat de changement de nom

    Company name changed parity training LIMITED\certificate issued on 22/03/10
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Qui sont les dirigeants de PARITY TRAINING LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SERAL, Komal Anil
    308 Atrium Center
    Bank Street, Bur Dubai PO BOX 23271
    Dubai
    United Arab Emirates
    Secrétaire
    308 Atrium Center
    Bank Street, Bur Dubai PO BOX 23271
    Dubai
    United Arab Emirates
    British150879210001
    MALIKSO, Akhil Ahamad
    308 Atrium Center
    Bank Street, Bur Dubai PO BOX 23271
    Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    308 Atrium Center
    Bank Street, Bur Dubai PO BOX 23271
    Dubai
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesIndian150879180001
    SERAI, Komal Anil
    308 Atrium Center
    Bank Street, Bur Dubai PO BOX 23271
    Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    308 Atrium Center
    Bank Street, Bur Dubai PO BOX 23271
    Dubai
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesIndian150879510001
    BICHEMO, Tracey Lynne
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    Secrétaire
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    British16560470002
    FIRTH, David Samuel Peter
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    Secrétaire
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    British77398810001
    KELLY, Joseph Patrick
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    Secrétaire
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    British61057590001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Secrétaire
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    British93777900002
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Secrétaire
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    SAXENA, Shivani Raijv
    PO BOX 23271 Villa No 90
    Umm Sequim 2,Jumeirah
    Dubai
    Secrétaire
    PO BOX 23271 Villa No 90
    Umm Sequim 2,Jumeirah
    Dubai
    Indian136854990001
    WATKINSON, Ed
    Aberue
    Bridge Street
    YO51 9LA Boroughbridge
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Aberue
    Bridge Street
    YO51 9LA Boroughbridge
    North Yorkshire
    British106937690001
    BUXTON, Sarah Ann
    60 Vestry Road
    Camberwell
    ST5 8NX London
    Administrateur
    60 Vestry Road
    Camberwell
    ST5 8NX London
    British53538420001
    DAVIES, Paul, Eur Eng
    3 Govett Grove
    GU20 6EE Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    3 Govett Grove
    GU20 6EE Windlesham
    Surrey
    British37117320003
    FLANAGAN, Andrew Henry
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    Administrateur
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    British42787120001
    GORDON, George Michael Winston
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    British37797170001
    GRAHAM, George Malcolm Roger
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish36314420001
    GREENWAY, Barbara Anne
    74 St James Road
    KT6 4QN Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    74 St James Road
    KT6 4QN Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritish79191520001
    GUTTERRIDGE, David James
    26 Windsor Road
    Albrighton
    WV7 3PY Wolverhampton
    Staffordshire
    Administrateur
    26 Windsor Road
    Albrighton
    WV7 3PY Wolverhampton
    Staffordshire
    British36659360002
    HART, Michael John
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    Administrateur
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    British118672700001
    HINTON, Michael David
    Speedyburn House
    Station Road, Gifford
    EH41 4QL Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Speedyburn House
    Station Road, Gifford
    EH41 4QL Haddington
    East Lothian
    United KingdomBritish68615800001
    HUGHES, John Llewellyn Mostyn
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    Administrateur
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    UkBritish104248860001
    JARVIS, John Edwin
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    British62045640001
    JENNINGS, Keith Murray
    25 Jacaranda House
    Woburn Hill Park
    KT15 2NZ Addlestone
    Surrey
    Administrateur
    25 Jacaranda House
    Woburn Hill Park
    KT15 2NZ Addlestone
    Surrey
    British76560510001
    JONES, Howard
    Saperton Stoney Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DS Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Saperton Stoney Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DS Great Missenden
    Buckinghamshire
    British102344050001
    KELLY, Joseph Patrick
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    Administrateur
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    British61057590001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Administrateur
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    EnglandBritish93777900002
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Administrateur
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    MILLER, Ian Kenneth
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    Administrateur
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    United KingdomScottish89546660001
    MOORE, Heather Margaret
    42 Kevins Drive
    GU46 7TL Yateley
    Hampshire
    Administrateur
    42 Kevins Drive
    GU46 7TL Yateley
    Hampshire
    EnglandBritish79225220001
    O'DRISCOLL, Ian
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    Administrateur
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    British68202110001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    ORME, Ronald William
    5 Sheridans Road
    KT23 4RZ Gt Bookham
    Surrey
    Administrateur
    5 Sheridans Road
    KT23 4RZ Gt Bookham
    Surrey
    British76923650001
    PETTMAN, Allan John
    Main Street
    Staveley
    HG5 9LD Knaresborough
    Westfield House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Main Street
    Staveley
    HG5 9LD Knaresborough
    Westfield House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154421300001
    SAKSENA, Ajeit
    PO BOX 28836 Flat No 209
    Badri Bldd1 Bardubai
    Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    PO BOX 28836 Flat No 209
    Badri Bldd1 Bardubai
    Dubai
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesIndian152159860001
    SAXENA, Shivani Raijv
    PO BOX 23271 Villa No 90
    Umm Sequim 2,Jumeirah
    Dubai
    Administrateur
    PO BOX 23271 Villa No 90
    Umm Sequim 2,Jumeirah
    Dubai
    Indian136854990001

    PARITY TRAINING LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 07 oct. 2009
    Livré le 08 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb bank PLC re cardnet liability - parity training LTD and numbered 7272248 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 19 févr. 2009
    Livré le 07 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb bank PLC re cardnet liability - part traininf LTD and numbered 07272248 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 2006
    Livré le 04 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 05 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance LTD
    Transactions
    • 05 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 05 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance LTD
    Transactions
    • 05 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 8TH july 1999 and
    Créé le 18 mars 2003
    Livré le 26 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 17 mars 2003
    Livré le 21 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 8TH july 1999
    Créé le 19 juin 2002
    Livré le 25 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PARITY TRAINING LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juin 2010Administration started
    12 mai 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Claire Louise Middlebrook
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh
    practitioner
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh
    Graeme Cameron Smith
    Royal Exchange Panmure Street
    DD1 1DZ Dundee
    practitioner
    Royal Exchange Panmure Street
    DD1 1DZ Dundee
    2
    DateType
    12 mai 2011Commencement of winding up
    03 mars 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Claire Louise Middlebrook
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh
    practitioner
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh
    Graeme Cameron Smith
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh
    practitioner
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0