NEWMARKET FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWMARKET FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00856471
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWMARKET FOODS LIMITED ?

    • (0111) /
    • (0122) /

    Où se situe NEWMARKET FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Malton Bacon Factory Hugden Way
    Norton Grove Industrial Estate
    YO17 9HG Malton
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWMARKET FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ISANDCO FPF REALISATIONS LIMITED07 nov. 199607 nov. 1996
    FAVOR PARKER FARMS LIMITED27 janv. 198727 janv. 1987
    FAVOR PARKER PIGS LIMITED17 août 198417 août 1984
    BAXTER PARKER LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    FAVOR PARKER LIVESTOCK LIMITED11 août 196511 août 1965

    Quels sont les derniers comptes de NEWMARKET FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au22 nov. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWMARKET FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 avr. 2011

    3 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Nomination de Tmf Corporate Administration Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Mawlaw Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Malton Bacon Factory Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Malton North Yorkshire YO17 9HG le 06 janv. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 déc. 2010

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2010

    État du capital au 08 sept. 2010

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Antonius Lammers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Louis Antoine Maria Vernaus en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Ronald William Francis le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Antonius Matheus Maria Lammers le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 22 nov. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de NEWMARKET FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Secrétaire
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Administrateur
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    British194640001
    TROLLOPE, Barry Desmond
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    Secrétaire
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    British45609870001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secrétaire
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ALLEN, Geoffrey Gordon
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    British15877490001
    COLES, Philip Charles John
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    Administrateur
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    British47148220001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    HOLMES, William Brian
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    British15877510001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Administrateur
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Administrateur
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PARKER, Benjamin James
    Gooderstone Manor
    Gooderstone
    PE33 9BP Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    Gooderstone Manor
    Gooderstone
    PE33 9BP Kings Lynn
    Norfolk
    British17414200001
    PARKER, John Gordon
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    British15877480001
    PARKER, Michael Joseph Bennett
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    British12897020001
    ROCHE, Nicholas James
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    Administrateur
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    EnglandBritish15836170001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001

    NEWMARKET FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An intercreditor and security agreement
    Créé le 30 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 08 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 24 août 1987
    Livré le 01 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from favor parker limited under the terms of the charge to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Freehold property k/a the foulden estate, foulden, norfolk stock in trade, work in progress pre-payments investments (please see doc for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 24 août 1987
    Livré le 26 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stocks shares other interests. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of agricultural property
    Créé le 24 août 1987
    Livré le 26 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property known as or being foulden estate foulden norfolk together with certain rights more particularly described in and comprised in a conveyance dated 27/11/86.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 11 oct. 1977
    Livré le 14 oct. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies advanced to favor parker livestock limited under an agreement dated 11TH october 1977 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by the debenture dated 11TH october 1977
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebets & uncalled capital. See doc M29.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 14 oct. 1977Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 30 août 1974
    Livré le 11 sept. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H and l/h including all fixtures, goodwill and uncalled capital present and future a floating charge.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank LTD
    Transactions
    • 11 sept. 1974Enregistrement d'une charge
    • 29 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NEWMARKET FOODS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 août 2011Dissolved on
    15 déc. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0