HERON SERVICE STATIONS LIMITED

HERON SERVICE STATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHERON SERVICE STATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00859756
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HERON SERVICE STATIONS LIMITED ?

    • Vente au détail de carburants automobiles en magasin spécialisé (47300) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe HERON SERVICE STATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fisher Partners Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HERON SERVICE STATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HERON FIFTEENTH LIMITED01 mars 199401 mars 1994
    HERON SERVICE STATIONSLIMITED23 sept. 196523 sept. 1965

    Quels sont les derniers comptes de HERON SERVICE STATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HERON SERVICE STATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HERON SERVICE STATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    État du capital au 07 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share capital a/c 24/03/2014
    RES13

    Changement d'adresse du siège social de Heron House 4 Bentinck Street London W1U 2EF le 28 mars 2014

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Jonathan Simon Goldstein en tant que directeur le 31 déc. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Daniel Simon Samson en tant qu'administrateur le 31 déc. 2013

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Lionel Harvey Zeltser le 27 sept. 2010

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Simon Goldstein le 27 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Heron House 19 Marylebone Rd London NW1 5JL le 04 oct. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gerald Maurice Ronson le 27 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de HERON SERVICE STATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ZELTSER, Lionel Harvey
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Secrétaire
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    British82318190001
    RONSON, Gerald Maurice, Sir
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritish33068600002
    SAMSON, Daniel Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    EnglandBritish183982890001
    BROWN, Steven Andrew
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    Secrétaire
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    British107162240001
    FENCHELLE, Mark Stephen
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    Secrétaire
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    British40682770001
    MORTON, Christopher John
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    Secrétaire
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    British71879280001
    PARSONS, Neil
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    Secrétaire
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    British67799270001
    ROBERTSON, Ian Donald Winton
    Ashley Gate 17 Ashley Park Road
    KT12 1JN Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Ashley Gate 17 Ashley Park Road
    KT12 1JN Walton On Thames
    Surrey
    British35557760001
    AHEARN, William James
    14 Church Hill
    Cheddington
    LU7 0SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    14 Church Hill
    Cheddington
    LU7 0SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    United KingdomBritish34603670001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish8958700001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish8958700001
    GOLDSTEIN, Jonathan Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritish68352140004
    KITCHEN, Daniel John
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    United KingdomBritish153028260001
    MARX, Michael Henry
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish35019090001

    HERON SERVICE STATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargees underthe terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1981
    Livré le 09 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from theron alpha investments LTD to the chargee under the terms of the facility letters d/d 25/3/80 & 26/3/80
    Brèves mentions
    6 old street london EC1 10 woodgate lane birmingham 12 noreton garage stoke on grant 14 leicester road hindeley 20 radlett road st. Albans & fixtures fittings & equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 17 juin 1980
    Livré le 19 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of facility lettes d/d 25.3.80 & 26.3.80
    Brèves mentions
    Fixtures, fittings & equipment situate at properties having serial nos 33 & 38 in an agreement made the 17.12.79. (see doc M61 for details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1980Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 juin 1980
    Livré le 19 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to becomedue from heron alpha investments LTD. To the chargee under the terms of two facility letters dated 25/03/80 and 26/03/80
    Brèves mentions
    Fixtures and fittings and equipment situated at property having serial nos. 1,2,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,23,26, 30,32,33,34,35,37,40 & 41. (for further details see doc M60).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1980Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 mars 1978
    Livré le 28 mars 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to be come due from heron corporation limited under the terms of a deed of govenant dated 29/7/77 to tce chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Abbey garage chesterfield road north mansfield notts together with all fixtures fittings plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Banque De L'indochine Et De Suez
    Transactions
    • 28 mars 1978Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 mars 1978
    Livré le 28 mars 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from heron corporation limited. Under the terms of a deed of governant dated 29/7/77 to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    273/275 london road staines surrey together with all fixtures fittings plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Banque De L'indochine Et De Suez
    Transactions
    • 28 mars 1978Enregistrement d'une charge
    • 30 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HERON SERVICE STATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 mars 2014Commencement of winding up
    19 déc. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0