REINMAR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREINMAR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00860112
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REINMAR LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe REINMAR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ventureforth House
    South Denes Road
    NR30 3PT Great Yarmouth
    Norfolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REINMAR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VENTUREFORTH ESTATES LIMITED05 sept. 198905 sept. 1989
    INSPECTORATE MARINE BASES LIMITED21 sept. 198721 sept. 1987
    WIMPEY MARINE BASES LIMITED26 janv. 198326 janv. 1983
    BROWN & ROOT - WIMPEY LIMITED28 sept. 196528 sept. 1965

    Quels sont les derniers comptes de REINMAR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour REINMAR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Oliver Francis Holmes en tant que directeur le 30 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2017

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2016 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2015

    État du capital au 02 déc. 2015

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael David Futter le 26 mai 2015

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2014

    État du capital au 02 déc. 2014

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 nov. 2013

    État du capital au 25 nov. 2013

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael David Futter le 07 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Colleen Marie Ives le 26 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de REINMAR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FUTTER, Michael David
    Beatty Road
    NR30 4BT Great Yarmouth
    11
    Norfolk
    England
    Secrétaire
    Beatty Road
    NR30 4BT Great Yarmouth
    11
    Norfolk
    England
    BritishSecretary49394260002
    IVES, Colleen Marie
    21 West Road
    Ormesby St Margaret
    NR29 3RP Great Yarmouth
    Norfolk
    Administrateur
    21 West Road
    Ormesby St Margaret
    NR29 3RP Great Yarmouth
    Norfolk
    EnglandBritishCommercial Director42515130002
    FUTTER, Michael David
    33 Hollow Grove Way
    Carlton Colville
    NR33 8NS Lowestoft
    Suffolk
    Secrétaire
    33 Hollow Grove Way
    Carlton Colville
    NR33 8NS Lowestoft
    Suffolk
    British49394260001
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    BritishGroup Financial Executive43572470001
    WIGG, Jennifer Mary
    The Lawns
    Beccles Road,Thurlton
    NR14 6AJ Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    The Lawns
    Beccles Road,Thurlton
    NR14 6AJ Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Secretary37485390001
    ATKIN, Peter Stuart Richard
    12 Elms Avenue
    N10 2JP London
    Administrateur
    12 Elms Avenue
    N10 2JP London
    United KingdomBritishSolicitor39983730001
    FUTTER, Michael David
    33 Hollow Grove Way
    Carlton Colville
    NR33 8NS Lowestoft
    Suffolk
    Administrateur
    33 Hollow Grove Way
    Carlton Colville
    NR33 8NS Lowestoft
    Suffolk
    BritishCompany Secretary49394260001
    HOLMES, Francis Andrew
    Lound Manor Lound
    NR32 5LT Lowestoft
    Suffolk
    Administrateur
    Lound Manor Lound
    NR32 5LT Lowestoft
    Suffolk
    BritishConsultant5233320001
    HOLMES, Francis Andrew
    Lound Manor Lound
    NR32 5LT Lowestoft
    Suffolk
    Administrateur
    Lound Manor Lound
    NR32 5LT Lowestoft
    Suffolk
    BritishConsultant5233320001
    HOLMES, Frank Herbert
    Mariawood Hulver Street
    Hulver
    NR34 7UE Beccles
    Suffolk
    Administrateur
    Mariawood Hulver Street
    Hulver
    NR34 7UE Beccles
    Suffolk
    BritishCompany Director42648860001
    HOLMES, Oliver Francis
    129 Mountbatten Drive
    Sprowston
    NR6 7PP Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    129 Mountbatten Drive
    Sprowston
    NR6 7PP Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector83180520007
    IVES, Colleen Marie
    10 Park View Avenue
    Rollesby
    NR29 5DZ Great Yarmouth
    Norfolk
    Administrateur
    10 Park View Avenue
    Rollesby
    NR29 5DZ Great Yarmouth
    Norfolk
    BritishDirector42515130001
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    BritishGroup Financial Executive43572470001
    STOCK, David Ronald
    2 Swallow Close
    Bradwell
    NR31 8QT Great Yarmouth
    Norfolk
    Administrateur
    2 Swallow Close
    Bradwell
    NR31 8QT Great Yarmouth
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive42515080001
    WOODCOCK, Joseph Edward
    66 Longfields Road
    NR7 0NA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    66 Longfields Road
    NR7 0NA Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishGroup Estates Executive65199350001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REINMAR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ms Colleen Marie Ives
    Ventureforth House
    South Denes Road
    NR30 3PT Great Yarmouth
    Norfolk
    06 avr. 2016
    Ventureforth House
    South Denes Road
    NR30 3PT Great Yarmouth
    Norfolk
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Oliver Francis Holmes
    Ventureforth House
    South Denes Road
    NR30 3PT Great Yarmouth
    Norfolk
    06 avr. 2016
    Ventureforth House
    South Denes Road
    NR30 3PT Great Yarmouth
    Norfolk
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Ventureforth Contract Services Ltd
    South Denes Road
    NR30 3PT Great Yarmouth
    Ventureforth House
    England
    06 avr. 2016
    South Denes Road
    NR30 3PT Great Yarmouth
    Ventureforth House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementWales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCardiff
    Numéro d'enregistrement3149115
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    REINMAR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 03 mars 1993
    Livré le 18 mars 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The palgrave brown terminal southtown road great yarmouth norfolk t/no NK75767 see doc 395 112/l 18/3 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Omnicorp International Bv
    Transactions
    • 18 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 1992
    Livré le 23 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and/or holmesquest holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H & l/h land lying to the north west and south east of ousegate selby and the old shipyard shipyard road selby and land lying to the south side ousegate selby north yorkshire having title numbers nyk 42637, nyk 59771, nyk 66566 and nyk 59772.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 1992
    Livré le 28 sept. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land near thamesfield way great yarmouth norfolk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 déc. 1991
    Livré le 12 déc. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H, blocks a, b, d and e, the lichfield estate, suffolk road, great yarmouth, norfolk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 1990
    Livré le 17 janv. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or holmes crest holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property known as 2.45 acres at southdown road, great yarmouth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 17 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 07 août 1989
    Livré le 08 août 1989
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or inspectorate UK holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    1) all the f/hold property comprised in a conveyance dated 20/12/84 2) all the l/hold property comprised in a lease dated 24/5/85.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 08 août 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1988
    Livré le 13 janv. 1989
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or inspectorate UK holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H - land and buildings on west and eastside of malthouse lane, great yarmouth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 13 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 oct. 1988
    Livré le 13 oct. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or inspectorate UK holdings LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Ferry house, south denes road, great yarmouth, norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    Letter of offset
    Créé le 04 oct. 1988
    Livré le 25 oct. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from inspectorate UK holdings limited and all of the companies named on the schedule to the governor and company of the bank of scotland.
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the governor & company of the bank of scotland in the name of inspectorate marine bases limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 25 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 19 sept. 1988
    Livré le 29 sept. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or inspectorate UK holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Admiralty road, and south denes road, great yarmouth norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland.
    Transactions
    • 29 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 15 août 1988
    Livré le 23 août 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or inspectorate UK holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H - the palgrave terminal southtown road, great yarmouth norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 août 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 15 janv. 1988
    Livré le 27 janv. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 27 janv. 1988Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0