ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00865292
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    • Assurance-vie (65110) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    Adresse du siège social
    Unity Place
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Wiltshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAMBRO LIFE ASSURANCE PLC30 nov. 196530 nov. 1965

    Quels sont les derniers comptes de ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Kirk Matthew Spencer en tant qu'administrateur le 13 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Clive Taphouse en tant que directeur le 14 févr. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de révocation d'un administrateur

    1 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Steven Lewis Wall en tant que directeur le 31 mars 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Martin Clive Taphouse en tant qu'administrateur le 23 mars 2023

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Lewis Wall le 24 oct. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gareth David Jenkins le 24 oct. 2022

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tricentre One New Bridge Square Swindon SN1 1HN England à Unity Place 1 Carfax Close Swindon Wiltshire SN1 1AP

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Zurich Financial Services (Ukisa) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 nov. 2021

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées du secrétaire Zurich Corporate Secretary (Uk) Limited le 12 nov. 2021

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de The Grange Bishops Cleeve Cheltenham Gloucestershire GL52 8XX United Kingdom à Unity Place 1 Carfax Close Swindon Wiltshire SN1 1AP le 12 nov. 2021

    1 pagesAD01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de James Richard Sykes en tant que directeur le 31 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Gareth David Jenkins en tant qu'administrateur le 31 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    27 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ZURICH CORPORATE SECRETARY (UK) LIMITED
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement1437979
    184776530001
    JENKINS, Gareth David
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director179993470001
    SPENCER, Kirk Matthew
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director324488340001
    BLUNDELL, Ann Claire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    179738040001
    BUSSON, Alan Paul
    41 Home Close
    Chiseldon
    SN4 0ND Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    41 Home Close
    Chiseldon
    SN4 0ND Swindon
    Wiltshire
    British73360002
    HOWE, Peter Charles
    Englishcombe
    10 Butts Road Chiseldon
    SN4 0NW Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    Englishcombe
    10 Butts Road Chiseldon
    SN4 0NW Swindon
    Wiltshire
    British34162240003
    KNOTT, Amanda Louise
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    British116644060004
    LOWE, Nigel
    Tall Trees
    65 High View
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    Tall Trees
    65 High View
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    British104309680001
    MEACHAM, Jayne Michelle
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    British117273030002
    OLISA HOLDING, Lily
    17 Elcombe Farm
    SN4 9QL Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    17 Elcombe Farm
    SN4 9QL Swindon
    Wiltshire
    British91928570001
    RITCHIE, Ian
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    179738060001
    ROGERS, Helen Frances Leigh
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Uk Life Centre
    Wiltshire
    Secrétaire
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Uk Life Centre
    Wiltshire
    British112889520003
    ROSS, Corina Katherine
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    British134476460001
    ALLVEY, David Philip
    The Old House
    Muster Green
    RH16 4AA Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    The Old House
    Muster Green
    RH16 4AA Haywards Heath
    West Sussex
    BritishChartered Accountant76454860001
    BALDWIN, Keith Reginald
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritishManaging Director-Sales7401430002
    BEYNON, David John
    The Old Rectory
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    Administrateur
    The Old Rectory
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    BritishSales Director64751630001
    BRENNAN, Michael Joseph
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    IrelandBritish IrishCompany Director147599570001
    BRIDE, Martin Lindsay
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    BritishChief Financial Officer110869880001
    CACCHIOLI, John Antony
    Red Lodge
    Oaksey Road
    SN16 9PY Upper Minety
    Wiltshire
    Administrateur
    Red Lodge
    Oaksey Road
    SN16 9PY Upper Minety
    Wiltshire
    UkBritishClient Services Dir86796430001
    CAMPBELL, Peter Charles
    Clocktower House Down Place
    Water Oakley
    SL4 5UG Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Clocktower House Down Place
    Water Oakley
    SL4 5UG Windsor
    Berkshire
    BritishPersonnel Director50736700001
    CARBY, Keith Arthur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    The Tri Centre
    Wiltshire
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    The Tri Centre
    Wiltshire
    BritishCompany Director12732100004
    CARRIE, David Ross
    Carlton House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Carlton House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandUnited KingdomCustomer Services Director55711250001
    CARRIE, David Ross
    Carlton House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Carlton House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandUnited KingdomIt Director55711250001
    CHURCHILL, Lawrence
    Chatley House
    Norton St Philip
    BA2 7NP Bath
    Administrateur
    Chatley House
    Norton St Philip
    BA2 7NP Bath
    BritishCompany Director86328880001
    CHURCHILL, Lawrence
    Chatley House
    Norton St Philip
    BA2 7NP Bath
    Administrateur
    Chatley House
    Norton St Philip
    BA2 7NP Bath
    BritishCompany Director86328880001
    COLSELL, Steven James
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance Director101387770001
    COOK, Rodney Malcolm
    The Riverbank
    Reybridge Lacock
    SN15 2PF Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    The Riverbank
    Reybridge Lacock
    SN15 2PF Chippenham
    Wiltshire
    British/AustralianCustomer Solutions Director78228220001
    DAVIES, Keith John
    Pinkwell Barn
    Chedworth
    GL54 4NE Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pinkwell Barn
    Chedworth
    GL54 4NE Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant17028460001
    DEIGHTON, Shayne Paul
    Brickham House
    London Road
    SN10 2DS Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Brickham House
    London Road
    SN10 2DS Devizes
    Wiltshire
    BritishFinance Director59763310003
    ELLEN, Peter
    Beaumoor House
    East End
    GL7 4AP Fairford
    Gloucestershire
    Administrateur
    Beaumoor House
    East End
    GL7 4AP Fairford
    Gloucestershire
    BritishOperations Director28864160003
    ETHERINGTON, David John
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritishChief Operating Officer93076380003
    EVANS, Neil James
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant261073090001
    FERNS, Michael Andrew
    26 Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2JQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    26 Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2JQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritishSales Director63501510001
    FITZJOHN, Marianne
    Gossington Hall
    Gossington
    GL2 7DN Slimbridge
    Gloucestershire
    Administrateur
    Gossington Hall
    Gossington
    GL2 7DN Slimbridge
    Gloucestershire
    DanishDir Of Uk Customer Service96981690001
    GARRAWAY, Brian Pattison
    66 Park Hill
    Clapham
    SW4 9PB London
    Administrateur
    66 Park Hill
    Clapham
    SW4 9PB London
    BritishCompany Director8280810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Carfax Close
    SN1 1AP Swindon
    Unity Place
    Wiltshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1860680
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1860680
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third party legal mortgage
    Créé le 21 mars 2003
    Livré le 27 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from miller/ctp (fareham) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property assetsa income and undertaking of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Second charge
    Créé le 21 mars 2003
    Livré le 22 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Market quay fareham.
    Personnes ayant droit
    • Miller/Ctp (Fareham) Limited
    Transactions
    • 22 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge
    Créé le 12 févr. 2002
    Livré le 22 févr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a land lying to the south of shotwick road deeside industrial park flintshire and k/a expressway 55 t/no WA955370.
    Personnes ayant droit
    • Welsh Development Agency
    Transactions
    • 22 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Letter of set-off
    Créé le 11 nov. 1999
    Livré le 13 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The monies now or hereafter to be standing to the credit of any account of the company at the bank.
    Personnes ayant droit
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of set off
    Créé le 11 nov. 1999
    Livré le 13 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The monies now or hereafter to be standing to the credit of any account of the company at the bank.
    Personnes ayant droit
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH august 1996
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 21 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    That plot or area of ground at grayshill road in cumbernauld new town dunbarton part of t/no.DMB57602. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cumbernauld Development Corporation
    Transactions
    • 21 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 07 juil. 1987
    Livré le 21 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any moneys now or hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC and all interest on the company therein and all interest (if any) now due or hereforth to become due in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus letter of set off.
    Créé le 01 juil. 1986
    Livré le 09 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 avr. 1986
    Livré le 25 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Revolving fixed charge over cash deposits to secure own liabilities the schedule the deposit in the principal amount to £20.806.506 at lloyds barn PLC group treasury division.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 sept. 1985
    Livré le 16 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Revolving fixed charge over cash deposits to secure own liabilities.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 juil. 1985
    Livré le 31 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Revolving fixed charge over cash deposits to secure own liabilities the account at lloyds bank PLC group treasury division designated "lloyds bank re allied dunbar assurance PLC".
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 juil. 1985
    Livré le 31 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Revolving fixed charge over cash deposits to secure own liabilities the account at lloyds bank PLC group treasurey division designated "lloyds bank re allied dunbar assurane PLC".
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 juil. 1985
    Livré le 31 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Revolving fixed charge over cash deposits to secure own liabilities the account at lloyds bank PLC group treasury division designated "lloyds bank re allied dunbar assurace PLC".
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 avr. 1985
    Livré le 08 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Any moneys now or hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC and all interest of the company therein and all interest (if any) now due or henceforth to become due in respect thereof. The account at lloyds bank PLC overseas division designated "lloyds bank re hambro life assurance PLC".
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 avr. 1985
    Livré le 08 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Any moneys now or hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC and all interest of the company therein and all interest (if any) now due or henceforth to become due in respect thereof. The account of lloyds bank PLC overseas division designated "lloyds bank re hambro life assurance PLC".
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 07 déc. 1983
    Livré le 22 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $22,000,000 all monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of a loan agreement dated 9TH june, 1983.
    Brèves mentions
    All moneys standing to the credit of an account at lloyds bank PLC money market division re hambro life assurance PLC, no. 3489 and all interest.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    • Lloyds Bank International Limited
    Transactions
    • 22 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0