TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00868498 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?
| Adresse du siège social | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Jane Li en tant que secrétaire le 31 déc. 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Steven Fink en tant qu'administrateur le 26 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de Jane Li en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de Exel Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de la nomination de Jane Li en tant que directeur le 26 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 8 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de James Edward Gill en tant que directeur le 13 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de James Edward Gill en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Thorsten Kuhl en tant qu'administrateur le 13 juin 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2016 | 13 pages | AA | ||
legacy | 192 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr James Edward Gill en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Keith Roy Smith en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Michael James Trimm en tant que directeur le 09 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINK, Steven | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 158324340001 | |||||||||
| KUHL, Thorsten | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Germany | German | 247678730001 | |||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Secrétaire | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 64948610002 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Secrétaire | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Secrétaire | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| GRAY, Roderick James | Secrétaire | 5 Gresham Close RH8 0BH Oxted Surrey | British | 10767150002 | ||||||||||
| LI, Jane | Secrétaire | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 203503560001 | |||||||||||
| MILLS, John Michael | Secrétaire | 103 Moffats Lane AL9 7RP Brookmans Park Hertfordshire | British | 193353200001 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Leigh | Secrétaire | 34 Castle Hill Avenue HP4 1HJ Berkhamsted Hertfordshire | British | 45625440002 | ||||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Secrétaire | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | British | 15165070001 | ||||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Administrateur | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 64948610002 | |||||||||
| AUSTIN, Keith James | Administrateur | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 69617780001 | |||||||||
| BRABENDER, Murray Robert Malcolm | Administrateur | 19 Phoenix Drive Wateringbury ME18 5DR Maidstone Kent | British | 50169470001 | ||||||||||
| BROWN, David | Administrateur | Dunvegan Devonburn ML11 9PU Lesmahagow Lanarkshire | British | 15524300001 | ||||||||||
| BUMSTEAD, Jonathan Culver | Administrateur | Eastland Cottage Hall Place GU6 8LA Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 72820970001 | |||||||||
| BUTT, Kenneth Thomas John | Administrateur | Hatchfield House Epsom Road, West Horsley KT24 6DX Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 80963930001 | |||||||||
| CAMERON, Ian, Mr. | Administrateur | 66 High Street Stagsden MK43 8SQ Bedford Gamekeepers Cottage England | England | British | 164576100001 | |||||||||
| COOKE, Gordon Leslie | Administrateur | 92 High Street Wrestlingworth SG19 2EJ Sandy Bedfordshire | British | 34718600001 | ||||||||||
| DAVIS, Leonard John | Administrateur | 25 Hathaway Court ME1 1QX Rochester Kent | British | 15524310001 | ||||||||||
| ELLIS, Michael John | Administrateur | Little Trodgers Honor End Lane, Prestwood HP16 9HG Buckinghamshire | England | British | 133791220001 | |||||||||
| FERGUSON, Peter | Administrateur | 39 Pickering Street Loose ME15 9RS Maidstone Kent | British | 15524290001 | ||||||||||
| GILL, James Edward | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 165998750001 | |||||||||
| GRAY, Roderick James | Administrateur | 5 Gresham Close RH8 0BH Oxted Surrey | British | 10767150002 | ||||||||||
| HEAL, Stephen Alan | Administrateur | The Paddocks Drove Road Gamlingay SG19 3NY Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British | 42087770001 | |||||||||
| HOWES, David William | Administrateur | Old Walls Birdingbury Road, Leamington Hasting CV23 8EB Rugby Warwickshire | British | 53711750001 | ||||||||||
| LI, Jane | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 134292740003 | |||||||||
| MANN, Roger Michael Ewart | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 15476780001 | |||||||||
| MATHIAS, Alfred Robert | Administrateur | Trillick Furzedown Lane Amport SP11 8BW Andover Hampshire | British | 9433680001 | ||||||||||
| PALMER, Martin Robert | Administrateur | 9 Maple Road OX9 2BH Thame Oxfordshire | British | 45138540001 | ||||||||||
| ROWLEY, Michael James | Administrateur | 6 The Depository Rock Villa Road TN1 1HA Tunbridge Wells Kent | England | British | 10767160002 | |||||||||
| SEY, Kevin Paul | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 186787040001 | |||||||||
| SMITH, Jamie Robert Mark | Administrateur | Tanglewood 33 Woodend Drive SL5 9BD Sunninghill Berkshire | United Kingdom | British | 74084830002 | |||||||||
| SMITH, Keith Roy | Administrateur | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 140889200001 | |||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Administrateur | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | England | British | 15165070001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Jane Li | 01 juin 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr James Edward Gill | 01 juin 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Exel Holdings Limited | 06 avr. 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | Créé le 26 avr. 1996 Livré le 01 mai 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 23RD february 1996 numbered 47.170.19.111372 and this assignment | |
Brèves mentions All monies due under the "assigned agreements" (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 juin 1994 Livré le 12 juil. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 02 mars 1989 Livré le 14 mars 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14/2/89 and a debenture dated 14/2/89 | |
Brèves mentions First fixed charge over all and whole a lease on the north side of old edinburgh road bellshill larnarkshire title no: lan 1159. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 févr. 1989 Livré le 20 févr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14.2.89 | |
Brèves mentions (See doc. For full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0