TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED

TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00868498
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?

    • Transport routier de marchandises (49410) / Transports et stockage
    • Exploitation d'entrepôts et de terminaux de stockage pour le transport terrestre (52103) / Transports et stockage

    Où se situe TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    APPLIED DISTRIBUTION LIMITED03 mars 198903 mars 1989
    GEEST DISTRIBUTION LIMITED02 sept. 198802 sept. 1988
    GROUND'S TRANSPORT (BOSTON) LIMITED10 janv. 196610 janv. 1966

    Quels sont les derniers comptes de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jane Li en tant que secrétaire le 31 déc. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Steven Fink en tant qu'administrateur le 26 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de Jane Li en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov. 2018

    1 pagesPSC07

    Notification de Exel Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Jane Li en tant que directeur le 26 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de James Edward Gill en tant que directeur le 13 juin 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de James Edward Gill en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2018

    1 pagesPSC07

    Nomination de Thorsten Kuhl en tant qu'administrateur le 13 juin 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2016

    13 pagesAA

    legacy

    192 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Nomination de Mr James Edward Gill en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Keith Roy Smith en tant que directeur le 31 mars 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael James Trimm en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FINK, Steven
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish158324340001
    KUHL, Thorsten
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    GermanyGerman247678730001
    ARROWSMITH, Michael Richard
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British64948610002
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    GRAY, Roderick James
    5 Gresham Close
    RH8 0BH Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    5 Gresham Close
    RH8 0BH Oxted
    Surrey
    British10767150002
    LI, Jane
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    203503560001
    MILLS, John Michael
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secrétaire
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    British193353200001
    SMITH, Nicholas Leigh
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British45625440002
    STALBOW, Michael Robert
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    British15165070001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement817717
    32524900007
    ARROWSMITH, Michael Richard
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritish64948610002
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69617780001
    BRABENDER, Murray Robert Malcolm
    19 Phoenix Drive
    Wateringbury
    ME18 5DR Maidstone
    Kent
    Administrateur
    19 Phoenix Drive
    Wateringbury
    ME18 5DR Maidstone
    Kent
    British50169470001
    BROWN, David
    Dunvegan
    Devonburn
    ML11 9PU Lesmahagow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Dunvegan
    Devonburn
    ML11 9PU Lesmahagow
    Lanarkshire
    British15524300001
    BUMSTEAD, Jonathan Culver
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish72820970001
    BUTT, Kenneth Thomas John
    Hatchfield House
    Epsom Road, West Horsley
    KT24 6DX Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Hatchfield House
    Epsom Road, West Horsley
    KT24 6DX Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish80963930001
    CAMERON, Ian, Mr.
    66 High Street
    Stagsden
    MK43 8SQ Bedford
    Gamekeepers Cottage
    England
    Administrateur
    66 High Street
    Stagsden
    MK43 8SQ Bedford
    Gamekeepers Cottage
    England
    EnglandBritish164576100001
    COOKE, Gordon Leslie
    92 High Street
    Wrestlingworth
    SG19 2EJ Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    92 High Street
    Wrestlingworth
    SG19 2EJ Sandy
    Bedfordshire
    British34718600001
    DAVIS, Leonard John
    25 Hathaway Court
    ME1 1QX Rochester
    Kent
    Administrateur
    25 Hathaway Court
    ME1 1QX Rochester
    Kent
    British15524310001
    ELLIS, Michael John
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    EnglandBritish133791220001
    FERGUSON, Peter
    39 Pickering Street
    Loose
    ME15 9RS Maidstone
    Kent
    Administrateur
    39 Pickering Street
    Loose
    ME15 9RS Maidstone
    Kent
    British15524290001
    GILL, James Edward
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish165998750001
    GRAY, Roderick James
    5 Gresham Close
    RH8 0BH Oxted
    Surrey
    Administrateur
    5 Gresham Close
    RH8 0BH Oxted
    Surrey
    British10767150002
    HEAL, Stephen Alan
    The Paddocks Drove Road
    Gamlingay
    SG19 3NY Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Paddocks Drove Road
    Gamlingay
    SG19 3NY Sandy
    Bedfordshire
    United KingdomBritish42087770001
    HOWES, David William
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    British53711750001
    LI, Jane
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritish134292740003
    MANN, Roger Michael Ewart
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritish15476780001
    MATHIAS, Alfred Robert
    Trillick Furzedown Lane
    Amport
    SP11 8BW Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Trillick Furzedown Lane
    Amport
    SP11 8BW Andover
    Hampshire
    British9433680001
    PALMER, Martin Robert
    9 Maple Road
    OX9 2BH Thame
    Oxfordshire
    Administrateur
    9 Maple Road
    OX9 2BH Thame
    Oxfordshire
    British45138540001
    ROWLEY, Michael James
    6 The Depository
    Rock Villa Road
    TN1 1HA Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    6 The Depository
    Rock Villa Road
    TN1 1HA Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish10767160002
    SEY, Kevin Paul
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish186787040001
    SMITH, Jamie Robert Mark
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish74084830002
    SMITH, Keith Roy
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish140889200001
    STALBOW, Michael Robert
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish15165070001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Jane Li
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    01 juin 2017
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr James Edward Gill
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    01 juin 2017
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    England
    06 avr. 2016
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1505040
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment
    Créé le 26 avr. 1996
    Livré le 01 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 23RD february 1996 numbered 47.170.19.111372 and this assignment
    Brèves mentions
    All monies due under the "assigned agreements" (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws 3 Limited
    Transactions
    • 01 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 12 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 02 mars 1989
    Livré le 14 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14/2/89 and a debenture dated 14/2/89
    Brèves mentions
    First fixed charge over all and whole a lease on the north side of old edinburgh road bellshill larnarkshire title no: lan 1159.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific National Bank
    Transactions
    • 14 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 1989
    Livré le 20 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14.2.89
    Brèves mentions
    (See doc. For full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific National Bank.
    Transactions
    • 20 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 21 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0