EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00871878 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?
Adresse du siège social | Arjohuntleigh House Houghton Hall Business Park Houghton Regis LU5 5XF Dunstable Bedfordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 28 nov. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christoffer David Erik Franzen en tant qu'administrateur le 11 juin 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Mark Bloom en tant qu'administrateur le 11 juin 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Scott Green en tant que directeur le 11 juin 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 3 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 3 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 3 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 3 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 3 pages | MR04 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt en tant qu'administrateur le 01 déc. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Leif Erik Martensson en tant que directeur le 01 déc. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Richard Mark Bloom le 09 févr. 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 310-312 Dallow Road Luton Bedfordshire LU1 1TD le 09 févr. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOOM, Richard Mark | Secrétaire | Houghton Hall Business Park Houghton Regis LU5 5XF Dunstable Arjohuntleigh House Bedfordshire United Kingdom | British | Solicitor | 118671260002 | |||||
BLOOM, Richard Mark | Administrateur | Houghton Hall Business Park Houghton Regis LU5 5XF Dunstable Arjohuntleigh House Bedfordshire United Kingdom | England | British | Legal Counsel | 118671260002 | ||||
FRANZEN, Christoffer David Erik | Administrateur | Houghton Hall Business Park Houghton Regis LU5 5XF Dunstable Arjohuntleigh House Bedfordshire United Kingdom | England | Swedish | Finance Director | 188458510001 | ||||
VAN DEN BELT, Robert Nicolaas Wilko | Administrateur | Houghton Hall Business Park Houghton Regis LU5 5XF Dunstable Arjohuntleigh House Bedfordshire United Kingdom | Sweden | Dutch | Cfo | 175232950001 | ||||
BANFIELD, Graeme Daryl | Secrétaire | 40 Wheatstone Road PO4 0HY Southsea Hampshire | British | 66225840001 | ||||||
SCOTT GREEN, Andrew John | Secrétaire | Oysters Appledram Lane South Fishbourne PO20 7PE Chichester West Sussex | British | Financial Controller | 75900570003 | |||||
WILKINSON, Peter Horace | Secrétaire | 4 Hopgarden Road TN10 4QS Tonbridge Kent | British | 11531330001 | ||||||
BRACEY, Nicholas Aidan | Administrateur | 58 Wingfield Road BA14 9EW Trowbridge Wiltshire | British | Managing Director | 86041250002 | |||||
COUSINS, Peter John | Administrateur | Paines Farm TN15 6XN Otford Kent | England | British | Accountant | 9841900001 | ||||
FLUESTER, Terry Harold Charles | Administrateur | 86 Melody Road Biggin Hill TN16 3PJ Westerham Kent | British | Engineer | 68120790001 | |||||
FRISTEDT, Stefan Ulf | Administrateur | 26263 Angelholm Pannagatan 1 Sweden | Sweden | Swedish | Cfo | 241863330001 | ||||
HANNAGAN, Angus Patrick Douglas | Administrateur | Green Glades Droxford Road PO17 5AY Wickham Hampshire | British | Director | 74342020001 | |||||
LOCK, Robert Francis | Administrateur | Oak House Priors Frome Upper Dormington HR1 4EF Hereford | United Kingdom | British | Finance Director | 61939850001 | ||||
MARTENSSON, Leif Erik | Administrateur | Linnegatan 116 FOREIGN Malmo 216 18 Sweden | Sweden | Swedish | Accountant | 153479400001 | ||||
SCOTT GREEN, Andrew John | Administrateur | Oysters Appledram Lane South Fishbourne PO20 7PE Chichester West Sussex | United Kingdom | British | Financial Controller | 75900570003 | ||||
THOMPSON, Martin Stuart | Administrateur | High Brimstone 176 Worlds End Lane Chelsfield Park BR6 7SS Orpington Kent | England | British | Engineer | 11531350001 | ||||
WEBB, Martin Barry | Administrateur | 103 St Thomas Avenue West Town PO11 0EU Hayling Island Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 1914800001 | ||||
WOZENCROFT, Andrew John | Administrateur | Pleasant Stile Littledean GL14 3NX Cinderford Temple Cottage Gloucestershire | British | Company Director | 16102100001 |
EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 21 déc. 1998 Livré le 24 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 01 juil. 1993 Livré le 08 juil. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed equitable charge all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation and all right title and interest in any goods. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 20 nov. 1992 Livré le 21 nov. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 19/11/74 | |
Brèves mentions Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Aircraft mortgage | Créé le 24 juin 1992 Livré le 25 juin 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £82,350 & all other monies due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Tb 20 trinidad g-kkdl s/n 1096. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement entitled "prompt credit application" | Créé le 24 mars 1992 Livré le 09 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £22,803.20 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance see doc for details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 10 août 1982 Livré le 13 août 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts and other debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 19 nov. 1974 Livré le 04 déc. 1974 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0