EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED

EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00871878
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Arjohuntleigh House Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Bedfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 28 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Mr Christoffer David Erik Franzen en tant qu'administrateur le 11 juin 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Mark Bloom en tant qu'administrateur le 11 juin 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew John Scott Green en tant que directeur le 11 juin 2014

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    3 pagesMR04

    Nomination de Mr Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt en tant qu'administrateur le 01 déc. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Leif Erik Martensson en tant que directeur le 01 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Richard Mark Bloom le 09 févr. 2012

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de 310-312 Dallow Road Luton Bedfordshire LU1 1TD le 09 févr. 2012

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor118671260002
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLegal Counsel118671260002
    FRANZEN, Christoffer David Erik
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandSwedishFinance Director188458510001
    VAN DEN BELT, Robert Nicolaas Wilko
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    SwedenDutchCfo175232950001
    BANFIELD, Graeme Daryl
    40 Wheatstone Road
    PO4 0HY Southsea
    Hampshire
    Secrétaire
    40 Wheatstone Road
    PO4 0HY Southsea
    Hampshire
    British66225840001
    SCOTT GREEN, Andrew John
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    Secrétaire
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    BritishFinancial Controller75900570003
    WILKINSON, Peter Horace
    4 Hopgarden Road
    TN10 4QS Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    4 Hopgarden Road
    TN10 4QS Tonbridge
    Kent
    British11531330001
    BRACEY, Nicholas Aidan
    58 Wingfield Road
    BA14 9EW Trowbridge
    Wiltshire
    Administrateur
    58 Wingfield Road
    BA14 9EW Trowbridge
    Wiltshire
    BritishManaging Director86041250002
    COUSINS, Peter John
    Paines Farm
    TN15 6XN Otford
    Kent
    Administrateur
    Paines Farm
    TN15 6XN Otford
    Kent
    EnglandBritishAccountant9841900001
    FLUESTER, Terry Harold Charles
    86 Melody Road
    Biggin Hill
    TN16 3PJ Westerham
    Kent
    Administrateur
    86 Melody Road
    Biggin Hill
    TN16 3PJ Westerham
    Kent
    BritishEngineer68120790001
    FRISTEDT, Stefan Ulf
    26263 Angelholm
    Pannagatan 1
    Sweden
    Administrateur
    26263 Angelholm
    Pannagatan 1
    Sweden
    SwedenSwedishCfo241863330001
    HANNAGAN, Angus Patrick Douglas
    Green Glades
    Droxford Road
    PO17 5AY Wickham
    Hampshire
    Administrateur
    Green Glades
    Droxford Road
    PO17 5AY Wickham
    Hampshire
    BritishDirector74342020001
    LOCK, Robert Francis
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    Administrateur
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    United KingdomBritishFinance Director61939850001
    MARTENSSON, Leif Erik
    Linnegatan 116
    FOREIGN Malmo
    216 18
    Sweden
    Administrateur
    Linnegatan 116
    FOREIGN Malmo
    216 18
    Sweden
    SwedenSwedishAccountant153479400001
    SCOTT GREEN, Andrew John
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishFinancial Controller75900570003
    THOMPSON, Martin Stuart
    High Brimstone 176 Worlds End Lane
    Chelsfield Park
    BR6 7SS Orpington
    Kent
    Administrateur
    High Brimstone 176 Worlds End Lane
    Chelsfield Park
    BR6 7SS Orpington
    Kent
    EnglandBritishEngineer11531350001
    WEBB, Martin Barry
    103 St Thomas Avenue
    West Town
    PO11 0EU Hayling Island
    Hampshire
    Administrateur
    103 St Thomas Avenue
    West Town
    PO11 0EU Hayling Island
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director1914800001
    WOZENCROFT, Andrew John
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    BritishCompany Director16102100001

    EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1998
    Livré le 24 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 01 juil. 1993
    Livré le 08 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation and all right title and interest in any goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 20 nov. 1992
    Livré le 21 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 19/11/74
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Aircraft mortgage
    Créé le 24 juin 1992
    Livré le 25 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £82,350 & all other monies due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Tb 20 trinidad g-kkdl s/n 1096.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 25 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement entitled "prompt credit application"
    Créé le 24 mars 1992
    Livré le 09 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £22,803.20 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 09 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 10 août 1982
    Livré le 13 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1982Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 19 nov. 1974
    Livré le 04 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0