GEOFFREY OSBORNE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGEOFFREY OSBORNE LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00873093
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GEOFFREY OSBORNE LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction
    • Construction de routes et d'autoroutes (42110) / Construction
    • Autres installations en construction (43290) / Construction

    Où se situe GEOFFREY OSBORNE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GEOFFREY OSBORNE LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2023
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GEOFFREY OSBORNE LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 déc. 2024
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 déc. 2024
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 déc. 2023
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour GEOFFREY OSBORNE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Cessation de la nomination de Peter Edward Duff en tant que directeur le 01 sept. 2024

    1 pagesTM01

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    63 pagesAM03

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC

    29 pagesAM02

    Cessation de la nomination de David Gordon Smith en tant que directeur le 31 mai 2024

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Fonteyn House 47-49 London Road Reigate Surrey RH2 9PY à C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 10 mai 2024

    3 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Satisfaction de la charge 008730930024 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 008730930024, créée le 22 sept. 2023

    52 pagesMR01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2022 au 31 mars 2023

    1 pagesAA01

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 008730930023

    1 pagesMR05

    Cessation de la nomination de John Fernandez en tant que secrétaire le 10 mars 2023

    1 pagesTM02

    Inscription de la charge 008730930023, créée le 03 mars 2023

    57 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Mark David Taylor en tant que directeur le 21 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 008730930022 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Sarah Catherine Taylor en tant que directeur le 09 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard Martyn King en tant que directeur le 11 oct. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Peter Edward Duff en tant qu'administrateur le 20 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stuart Hammond en tant que directeur le 19 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2021

    49 pagesAA

    Nomination de Mr John Fernandez en tant que secrétaire le 24 mars 2022

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr David Gordon Smith en tant qu'administrateur le 02 déc. 2021

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de GEOFFREY OSBORNE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OSBORNE, Andrew Simon Charles
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant69198210019
    BURDEN, Franklyn David
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    Secrétaire
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    British4360750001
    FERNANDEZ, John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Secrétaire
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    293995010001
    HAMMOND, Stuart
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    British179087810001
    HATTON, Thomas David Michael
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    Secrétaire
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    British728380004
    OSBORNE, Andrew Simon Charles
    Osborne House
    51 Fishbourne Road East
    PO19 8LL Chichester
    C/O Geoffrey Osborne Limited
    West Sussex
    Secrétaire
    Osborne House
    51 Fishbourne Road East
    PO19 8LL Chichester
    C/O Geoffrey Osborne Limited
    West Sussex
    BritishDirector69198210013
    BALDWIN, Richard Keith, Dr
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Administrateur
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    United KingdomBritishConsultant37207590001
    BURDEN, Franklyn David
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Sunnyside Easthampnett Lane
    Easthampnett
    PO18 0JY Chichester
    West Sussex
    BritishCompany Director4360750001
    CHADWICK, John Rennie, Dr.
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Civil Engineer136362410001
    CLAYTON, Marie-Louise Louise
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishNone163090500001
    COWAN, Ralph
    Grinton 5 Aldenham Grove
    WD7 7BW Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Grinton 5 Aldenham Grove
    WD7 7BW Radlett
    Hertfordshire
    BritishRetired Company Director670630002
    CRAIG, John David, Mr.
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director, Construction215898750001
    DAINES, Graham
    24 Hunters Mews
    Fontwell
    BN18 0UW Arundel
    West Sussex
    Administrateur
    24 Hunters Mews
    Fontwell
    BN18 0UW Arundel
    West Sussex
    BritishCompany Director4400050002
    DOWSETT, John Vincent
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director215898790001
    DUFF, Peter Edward
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector89262050002
    EVERARD, Brian Kenneth
    5 Old Place
    Aldwick
    PO21 3AU Bognor Regis
    West Sussex
    Administrateur
    5 Old Place
    Aldwick
    PO21 3AU Bognor Regis
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director17789250001
    FISON, David Gareth
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCivil Engineer60231310001
    HAMMOND, Stuart
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishNone154194990001
    HEASMAN, Mark
    Mill House
    Bulford Mill Lane Cressing
    CM77 8NT Braintree
    Essex
    Administrateur
    Mill House
    Bulford Mill Lane Cressing
    CM77 8NT Braintree
    Essex
    EnglandBritishCompany Director115901610001
    HOOPER, David Matthew William
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    UkBritishNone168207200001
    KELLEY, Anthony John
    Broadlands
    27 Ralliwood Road
    KT21 1DD Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    Broadlands
    27 Ralliwood Road
    KT21 1DD Ashtead
    Surrey
    BritishCompany Director34076900001
    KING, Richard Martyn
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Marketer & Chartered Engineer154195030001
    LIDDLE, Stephen
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Administrateur
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    EnglandBritishDirector105835710001
    MATTHEWS, Timothy John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Remploy Ltd50382860001
    MURRAY, Simon Anthony
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Administrateur
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Civil Engineer79856110001
    OLIVER, John Frank
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    Administrateur
    51 Fishbourne Road
    PO19 3HZ Chichester
    Osborne House
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director17813980001
    OSBORNE, Geoffrey Clement Howard
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    BritishCompany Director4360760001
    OSBORNE, Pamela Agnew
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Rosewood Marley Common
    GU27 3PU Haslemere
    Surrey
    Great BritainBritishRetired4360770001
    PETTER, Michael John
    4 Romyns Court
    PO14 1NB Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    4 Romyns Court
    PO14 1NB Fareham
    Hampshire
    EnglandBritishDirector69338760002
    SHEPHERD, Gordon Bruce
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Management Accountan78724260001
    SHORTMAN, Philip John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director190035630001
    SMITH, David Gordon, Mr.
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector78869630003
    STEELE, Andrew Philip
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishNone179702030022
    STERLING, Nicholas John
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director97129450001
    TAYLOR, Mark David
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    Administrateur
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor And Company Director117602770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GEOFFREY OSBORNE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    31 janv. 2018
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement11056197
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    47-49 London Road
    RH2 9PY Reigate
    Fonteyn House
    Surrey
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07543585
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GEOFFREY OSBORNE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 sept. 2023
    Livré le 27 sept. 2023
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • B.I.G Finance Limited
    Transactions
    • 27 sept. 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 avr. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 03 mars 2023
    Livré le 08 mars 2023
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Osborne Group Holdings LTD
    Transactions
    • 08 mars 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 avr. 2023Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2019
    Livré le 23 déc. 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold property known as wickfield house, 18-22 disney place, london, SE1 1HJ registered at hm land registry under title number LN26705.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cynergy Bank Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 févr. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 mai 2019
    Livré le 16 mai 2019
    En cours
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 17 juin 2015
    Livré le 23 juin 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 juin 2015
    Livré le 03 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gcho (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 03 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 09 oct. 2013
    Livré le 16 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H land k/a wickfield house 18-22 disney place london t/no LN26705. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gcho (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 16 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over security account
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 22 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The account balance from time to time of the security account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its present and future rights, title and interest in and to (a) the security account; and (b) the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Caring 4 Croydon Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge on deposit
    Créé le 17 déc. 2003
    Livré le 18 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit being all monies on the account and all entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on deposit
    Créé le 10 oct. 2001
    Livré le 11 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £225,000.00 and all other sums due from the company to the chargee under the facility agreement and/or this charge on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Deposit of £225,000.00 and all entitlements to interest and other rights,benefits thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 11 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    18/22 disney place london SE1.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 21 mai 1998
    Livré le 29 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys due or owing to the company under or by virtue of the contract dated 19/12/97. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 26 sept. 1995
    Livré le 06 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from geoffrey osborne investments limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Brèves mentions
    Fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule to form 395 please see form for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 09 août 1993
    Livré le 17 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from geoffrey osborne (developments) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Higher interest account no. 70123838. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 28 mars 1993
    Livré le 14 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re geoffrey osborne limited gts bid deposit bid no 90133205. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 déc. 1987
    Livré le 29 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at manor farm lavant chichester west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 déc. 1987
    Livré le 29 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining stockbridge house, stockbridge road, chichester west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 21 août 1987
    Livré le 04 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Little meadow and gevelia cottage, smoch alley west chiltington west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 29 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at ham manor golf club, west-sussex title no sx 55065.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 oct. 1983
    Livré le 19 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold wessex gate, formerly known as 23, portsmouth rd., Hamdean, hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 19 août 1983
    Livré le 25 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold osborne house stockbridge road. Chichester west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1983Enregistrement d'une charge
    • 14 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 17 mai 1982
    Livré le 07 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £101,140 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Land and buildings comprised in title no. Sy 506869 forming part of nonsuch industrial estate.
    Personnes ayant droit
    • Tanley Bridge Limited
    Transactions
    • 07 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 1982
    Livré le 26 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold premises at quarry lane, chichester, west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 21 mars 1979
    Livré le 30 mars 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and premises at quarry lane chichester, west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 1979Enregistrement d'une charge
    • 24 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GEOFFREY OSBORNE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 avr. 2024Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Damian Webb
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    David Frederick Shambrook
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0