M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED

M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00878983
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED ?

    • fonte de métaux légers (24530) / Industries manufacturières

    Où se situe M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Ben Allen en tant qu'administrateur le 02 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael Nicholas Allen en tant qu'administrateur le 02 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    3 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Gary Robert Ealham en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2016

    État du capital au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Allen le 06 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Charles Gibson le 06 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gary Robert Ealham le 06 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy John Allen le 06 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    19 pagesAA

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Charles Gibson le 14 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Charles Gibson le 14 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gary Robert Ealham le 14 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy John Allen le 14 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Allen le 14 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GIBSON, Alan Charles
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Secrétaire
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    BritishDirector43724570002
    ALLEN, Ben Nicholas
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Administrateur
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    EnglandBritishCommercial Director255788420001
    ALLEN, Michael Nicholas
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Administrateur
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    EnglandBritishCommercial Director51496810005
    ALLEN, Michael John
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Administrateur
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    EnglandBritishCompany Director27989920001
    ALLEN, Timothy John
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Administrateur
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    EnglandBritishCompany Director159002510001
    GIBSON, Alan Charles
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Administrateur
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    EnglandBritishDirector43724570002
    GORDON, Graham
    Flat 104 The Metropole
    CT20 2LU Folkestone
    Kent
    Secrétaire
    Flat 104 The Metropole
    CT20 2LU Folkestone
    Kent
    British117843740001
    CROMBIE, Thomas Ronald
    78 Downs Road
    CT19 5PT Folkestone
    Kent
    Administrateur
    78 Downs Road
    CT19 5PT Folkestone
    Kent
    BritishCompany Director12492360001
    EALHAM, Gary Robert
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    Administrateur
    Hilton Road
    Cobbs Wood Estate
    TN23 1EW Ashford
    Kent
    EnglandEnglishCompany Director16475180001
    GORDON, Graham
    Flat 104 The Metropole
    CT20 2LU Folkestone
    Kent
    Administrateur
    Flat 104 The Metropole
    CT20 2LU Folkestone
    Kent
    EnglandBritishCompany Director117843740001
    RANDALL, Michael George
    14 Sevington Park
    Loose
    ME15 9SB Maidstone
    Kent
    Administrateur
    14 Sevington Park
    Loose
    ME15 9SB Maidstone
    Kent
    EnglandBritishCompany Director28098770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    M J Allen Holdings Limited
    Hilton Road
    TN23 1EW Ashford
    M J Allen (Non Ferrous Founders) Ltd
    England
    06 avr. 2016
    Hilton Road
    TN23 1EW Ashford
    M J Allen (Non Ferrous Founders) Ltd
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Uk
    Numéro d'enregistrement00699347
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    M.J. ALLEN (NON-FERROUS FOUNDERS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 mars 2014
    Livré le 25 mars 2014
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    All assets debenture deed
    Créé le 17 mai 2002
    Livré le 20 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 20 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture deed
    Créé le 05 avr. 2002
    Livré le 13 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 10 mars 1997
    Livré le 17 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 juin 1989
    Livré le 28 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    And heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 24 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 16 avr. 1985
    Livré le 29 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 19 sept. 1984
    Livré le 01 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 11 sept. 1979
    Livré le 02 oct. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property, undertaking and assets charged by the proncipal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1979Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 09 déc. 1974
    Livré le 24 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other existing companies and/or m j allen (charter)LTD. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property, undertakign and assets charged by the princial deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 janv. 1974
    Livré le 16 janv. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the four other companies named therein on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaking goodwill all property and assets present and future including uncalled capital together with all buildings fixtures (incl trade fixutres) fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1974Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0