INSUMAT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINSUMAT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00880336
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INSUMAT LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe INSUMAT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Reading
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INSUMAT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROOK VICTOR ELECTRIC VEHICLES LIMITED27 mai 196627 mai 1966

    Quels sont les derniers comptes de INSUMAT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour INSUMAT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    7 pagesAA

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 5 New Street Square London EC4A 3TW à 1020 Eskdale Road Winnersh Reading RG41 5TS le 20 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 janv. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pages4.70

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes pour une société dormante établis au 02 oct. 2015

    7 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2016

    État du capital au 19 mai 2016

    • Capital: GBP 2,250,000
    SH01

    Cessation de la nomination de James Love en tant que directeur le 29 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2015 au 30 sept. 2015

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mai 2015

    État du capital au 21 mai 2015

    • Capital: GBP 2,250,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mai 2014

    État du capital au 23 mai 2014

    • Capital: GBP 2,250,000
    SH01

    Nomination de Curtis Carl Reusser en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Lawrence en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de INSUMAT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Secrétaire
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04328885
    84071220002
    GEORGE, Robert David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Reading
    1020
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Reading
    1020
    United StatesAmerican133332220004
    REUSSER, Curtis Carl
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Reading
    1020
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Reading
    1020
    United StatesAmerican187868730001
    YOST, Albert Scott
    N. Murray Lane
    99019 Liberty Lake
    1225
    Washington
    Usa
    Administrateur
    N. Murray Lane
    99019 Liberty Lake
    1225
    Washington
    Usa
    United StatesAmerican149468560001
    DUNNING, Neil Martin
    36 St Bartholomews Close
    Cam
    GL11 5UR Dursley
    Gloucestershire
    Secrétaire
    36 St Bartholomews Close
    Cam
    GL11 5UR Dursley
    Gloucestershire
    British27700870001
    JAMES, Stephen Thomas
    9 Banks Terrace
    Hurworth Place
    DL2 2DE Darlington
    County Durham
    Secrétaire
    9 Banks Terrace
    Hurworth Place
    DL2 2DE Darlington
    County Durham
    British51807580001
    TURNER, Anthony George
    59 Parkside
    Greenways Estate
    DL16 6SA Spennymoor
    Durham
    Secrétaire
    59 Parkside
    Greenways Estate
    DL16 6SA Spennymoor
    Durham
    British93174280001
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    Secrétaire
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    75491680001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    160
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Secrétaire
    160
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1447749
    38565160001
    BONEHILL, Michael Kenrick
    3 Hartlebury Way
    Charlton Kings
    GL52 6YB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    3 Hartlebury Way
    Charlton Kings
    GL52 6YB Cheltenham
    Gloucestershire
    British3118000001
    BROWN, Robert Casson
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    British6343100001
    BURNS, Christopher Robert, Dr
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    Administrateur
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    British77008070001
    CREMIN, Robert William
    9226 South East 33rd Place
    Mercer Island
    Washington 98040
    Usa
    Administrateur
    9226 South East 33rd Place
    Mercer Island
    Washington 98040
    Usa
    UsaAmerican67768140003
    DUNNING, Neil Martin
    36 St Bartholomews Close
    Cam
    GL11 5UR Dursley
    Gloucestershire
    Administrateur
    36 St Bartholomews Close
    Cam
    GL11 5UR Dursley
    Gloucestershire
    British27700870001
    GAGG, Jonathan Woodley
    20 Fullford Grove
    Wynyard
    TS22 5QZ Billingham
    Cleveland
    Administrateur
    20 Fullford Grove
    Wynyard
    TS22 5QZ Billingham
    Cleveland
    British120488600001
    GAGG, Jonathan Woodley
    Holly House
    Church Lane, Skelton
    YO30 1XT York
    Administrateur
    Holly House
    Church Lane, Skelton
    YO30 1XT York
    British52903820004
    GAMBLE, Kevin George Alfred
    Areley House
    Watford Road
    NN6 7TT Crick
    Northamptonshire
    Administrateur
    Areley House
    Watford Road
    NN6 7TT Crick
    Northamptonshire
    British88627240001
    JAMES, Stephen Thomas
    9 Banks Terrace
    Hurworth Place
    DL2 2DE Darlington
    County Durham
    Administrateur
    9 Banks Terrace
    Hurworth Place
    DL2 2DE Darlington
    County Durham
    British51807580001
    LAWRENCE, Richard Bradley
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    United StatesAnmerican122574630001
    LOVE, James
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish149182680001
    LOVE, James
    6 Roper Court
    DL10 4DF Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    6 Roper Court
    DL10 4DF Richmond
    North Yorkshire
    British73639200001
    MENZIES, John Webster
    12 Church Street
    Dunnington
    YO19 5PW York
    North Yorkshire
    Administrateur
    12 Church Street
    Dunnington
    YO19 5PW York
    North Yorkshire
    British73637350001
    MOSS, Andrew Brian
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    Administrateur
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    O'DONOVAN, Kathleen Anne
    3c Cintra Park
    Upper Norwood
    SE19 2LH London
    Administrateur
    3c Cintra Park
    Upper Norwood
    SE19 2LH London
    United KingdomBritish34401390005
    PADBURY, John Richard
    Larkhill West End
    Osmotherly
    DL6 3AE Northallerton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Larkhill West End
    Osmotherly
    DL6 3AE Northallerton
    North Yorkshire
    British51807590003
    TURNER, Anthony George
    59 Parkside
    Greenways Estate
    DL16 6SA Spennymoor
    Durham
    Administrateur
    59 Parkside
    Greenways Estate
    DL16 6SA Spennymoor
    Durham
    EnglandBritish93174280001
    WILLIAMS, Stanley Killa
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish34401400001
    WOOD, Richard John
    10217 Se 21st Street
    Bellevue
    Washington 98004
    Usa
    Administrateur
    10217 Se 21st Street
    Bellevue
    Washington 98004
    Usa
    British110561630001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour INSUMAT LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    08 mai 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    INSUMAT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 22 december 2000
    Créé le 30 mars 2004
    Livré le 06 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 déc. 2000
    Livré le 05 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 22 oct. 1987
    Livré le 29 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15000000 7 1/4% debenture stock 1987/92 of hawker siddeley group public limited company and all other moneys intended to be secured by a trust deed d/d 2/5/66 and for further securing £595291 7 1/4% debenture stock 1987/92 and £2769239 8 3/4% debenture stock 1987/92 of hawker siddeley group PLC and all other moneys intended to be secured by a supplemental trust deed d/d 30/11/73 and by four supplemental trust deeds d/d 23/9/74 29 /12/81 20/12/85 17/7/87 and by this deed
    Brèves mentions
    Floating charge by way of collateral security on the undertaking (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transactions
    • 29 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    INSUMAT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 janv. 2017Commencement of winding up
    13 sept. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0