INSUMAT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INSUMAT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00880336 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INSUMAT LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Reading |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INSUMAT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour INSUMAT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 5 New Street Square London EC4A 3TW à 1020 Eskdale Road Winnersh Reading RG41 5TS le 20 janv. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | 4.70 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 02 oct. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de James Love en tant que directeur le 29 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2015 au 30 sept. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Curtis Carl Reusser en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Lawrence en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INSUMAT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | New Street Square EC4A 3TW London 5 United Kingdom |
| 84071220002 | ||||||||||
| GEORGE, Robert David | Administrateur | Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Reading 1020 | United States | American | 133332220004 | |||||||||
| REUSSER, Curtis Carl | Administrateur | Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Reading 1020 | United States | American | 187868730001 | |||||||||
| YOST, Albert Scott | Administrateur | N. Murray Lane 99019 Liberty Lake 1225 Washington Usa | United States | American | 149468560001 | |||||||||
| DUNNING, Neil Martin | Secrétaire | 36 St Bartholomews Close Cam GL11 5UR Dursley Gloucestershire | British | 27700870001 | ||||||||||
| JAMES, Stephen Thomas | Secrétaire | 9 Banks Terrace Hurworth Place DL2 2DE Darlington County Durham | British | 51807580001 | ||||||||||
| TURNER, Anthony George | Secrétaire | 59 Parkside Greenways Estate DL16 6SA Spennymoor Durham | British | 93174280001 | ||||||||||
| INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | 75491680001 | |||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
| 38565160001 | ||||||||||
| BONEHILL, Michael Kenrick | Administrateur | 3 Hartlebury Way Charlton Kings GL52 6YB Cheltenham Gloucestershire | British | 3118000001 | ||||||||||
| BROWN, Robert Casson | Administrateur | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||||||
| BURNS, Christopher Robert, Dr | Administrateur | 66 Fairmile Lane Doonside KT11 2DE Cobham Surrey | British | 77008070001 | ||||||||||
| CREMIN, Robert William | Administrateur | 9226 South East 33rd Place Mercer Island Washington 98040 Usa | Usa | American | 67768140003 | |||||||||
| DUNNING, Neil Martin | Administrateur | 36 St Bartholomews Close Cam GL11 5UR Dursley Gloucestershire | British | 27700870001 | ||||||||||
| GAGG, Jonathan Woodley | Administrateur | 20 Fullford Grove Wynyard TS22 5QZ Billingham Cleveland | British | 120488600001 | ||||||||||
| GAGG, Jonathan Woodley | Administrateur | Holly House Church Lane, Skelton YO30 1XT York | British | 52903820004 | ||||||||||
| GAMBLE, Kevin George Alfred | Administrateur | Areley House Watford Road NN6 7TT Crick Northamptonshire | British | 88627240001 | ||||||||||
| JAMES, Stephen Thomas | Administrateur | 9 Banks Terrace Hurworth Place DL2 2DE Darlington County Durham | British | 51807580001 | ||||||||||
| LAWRENCE, Richard Bradley | Administrateur | New Street Square EC4A 3TW London 5 United Kingdom | United States | Anmerican | 122574630001 | |||||||||
| LOVE, James | Administrateur | New Street Square EC4A 3TW London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 149182680001 | |||||||||
| LOVE, James | Administrateur | 6 Roper Court DL10 4DF Richmond North Yorkshire | British | 73639200001 | ||||||||||
| MENZIES, John Webster | Administrateur | 12 Church Street Dunnington YO19 5PW York North Yorkshire | British | 73637350001 | ||||||||||
| MOSS, Andrew Brian | Administrateur | Saddlebow Cottage Saddlebow Lane CV35 8PQ Claverdon Warwickshire | England | British | 161928410001 | |||||||||
| O'DONOVAN, Kathleen Anne | Administrateur | 3c Cintra Park Upper Norwood SE19 2LH London | United Kingdom | British | 34401390005 | |||||||||
| PADBURY, John Richard | Administrateur | Larkhill West End Osmotherly DL6 3AE Northallerton North Yorkshire | British | 51807590003 | ||||||||||
| TURNER, Anthony George | Administrateur | 59 Parkside Greenways Estate DL16 6SA Spennymoor Durham | England | British | 93174280001 | |||||||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Administrateur | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||||||
| WOOD, Richard John | Administrateur | 10217 Se 21st Street Bellevue Washington 98004 Usa | British | 110561630001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour INSUMAT LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 08 mai 2017 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
INSUMAT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 22 december 2000 | Créé le 30 mars 2004 Livré le 06 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 22 déc. 2000 Livré le 05 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental trust deed | Créé le 22 oct. 1987 Livré le 29 oct. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti £15000000 7 1/4% debenture stock 1987/92 of hawker siddeley group public limited company and all other moneys intended to be secured by a trust deed d/d 2/5/66 and for further securing £595291 7 1/4% debenture stock 1987/92 and £2769239 8 3/4% debenture stock 1987/92 of hawker siddeley group PLC and all other moneys intended to be secured by a supplemental trust deed d/d 30/11/73 and by four supplemental trust deeds d/d 23/9/74 29 /12/81 20/12/85 17/7/87 and by this deed | |
Brèves mentions Floating charge by way of collateral security on the undertaking (please see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||