VFI NORTH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVFI NORTH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00882677
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VFI NORTH LIMITED ?

    • (1533) /

    Où se situe VFI NORTH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VFI NORTH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FRESHBAKE FOODS LIMITED03 avr. 199803 avr. 1998
    FRESHBAKE AGRICULTURAL SERVICES LIMITED23 juin 198723 juin 1987
    WOLD FARM FOODS LIMITED01 juil. 196601 juil. 1966

    Quels sont les derniers comptes de VFI NORTH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour VFI NORTH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    5 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    4 pagesOC-DV

    legacy

    1 pagesLIQ

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    12 pages4.68

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Divers

    Sec/state's cert-release of liq.
    1 pagesMISC

    legacy

    1 pages287

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de VFI NORTH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FLEETNESS NOMINEES LIMITED
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    Lancashire
    65679910001
    CARR, Kenneth Edmund
    40 Nelson Road
    KT3 5EB New Malden
    Surrey
    Administrateur
    40 Nelson Road
    KT3 5EB New Malden
    Surrey
    United KingdomBritishDirector1590440001
    BYERS, Peter James
    44 Main Street
    Yarwell
    PE8 6PR Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    44 Main Street
    Yarwell
    PE8 6PR Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director46317580001
    LACY, Douglas Archibald
    61 Jack Straws Lane
    Headington
    OX3 0DW Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    61 Jack Straws Lane
    Headington
    OX3 0DW Oxford
    Oxfordshire
    British983630001
    LAND, Sian Louise
    8 Regent Park Court
    Gravel Lane
    SK9 6LQ Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    8 Regent Park Court
    Gravel Lane
    SK9 6LQ Wilmslow
    Cheshire
    British58244430002
    STUMP, Christopher Jeremy
    2 Sussex Street
    SW1V 4RU London
    Secrétaire
    2 Sussex Street
    SW1V 4RU London
    British9322400001
    BYERS, Peter James
    44 Main Street
    Yarwell
    PE8 6PR Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    44 Main Street
    Yarwell
    PE8 6PR Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director46317580001
    CASKEY, William Josin
    1 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    AmericanDirector32829360001
    DALEY, David
    10 Ray Mead Road
    SL6 8NJ Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    10 Ray Mead Road
    SL6 8NJ Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector61746440001
    DERBY, Graeme Robert
    Lodge Farm Barn Lodge Lane
    Ardleigh
    CO7 7PG Colchester
    Essex
    Administrateur
    Lodge Farm Barn Lodge Lane
    Ardleigh
    CO7 7PG Colchester
    Essex
    EnglandBritishManaging Director58244300002
    ENRIGHT, Michael Thomas
    9 Chadkirk Road
    Romiley
    SK6 3JY Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    9 Chadkirk Road
    Romiley
    SK6 3JY Stockport
    Cheshire
    BritishManaging Director69880080001
    HALE, Kelvyn Barry
    13 Stuart Road
    Windle
    WA10 6HU St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    13 Stuart Road
    Windle
    WA10 6HU St Helens
    Merseyside
    BritishBusiness Director54134970001
    HOBBINS, Jeremy Paul Egerton
    4 Groom Place
    Belgravia
    SW1X 7BA London
    Administrateur
    4 Groom Place
    Belgravia
    SW1X 7BA London
    CanadianChief Executive52576800001
    LACY, Douglas Archibald
    61 Jack Straws Lane
    Headington
    OX3 0DW Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    61 Jack Straws Lane
    Headington
    OX3 0DW Oxford
    Oxfordshire
    BritishBusiness Accountant983630001
    LAND, Sian Louise
    8 Regent Park Court
    Gravel Lane
    SK9 6LQ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    8 Regent Park Court
    Gravel Lane
    SK9 6LQ Wilmslow
    Cheshire
    BritishFinance Director58244430002
    LEGG, Peter James
    12 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    Administrateur
    12 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    BritishActing Managing Director75084100001
    MUSTOE, John William Tarleton
    Evergreen
    Beech Waye
    SL9 8BL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Evergreen
    Beech Waye
    SL9 8BL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector63792700003
    PAYNE, Nigel John
    6 Clark Drive,
    M33 6QD Cherry Hill,
    New Jersey, 08034
    U.S.A.
    Administrateur
    6 Clark Drive,
    M33 6QD Cherry Hill,
    New Jersey, 08034
    U.S.A.
    BritishDirector38262700003
    PLUMMER, Kevin John
    125 Banbury Road
    CV37 7HR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    125 Banbury Road
    CV37 7HR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishAccountant57667630002
    RICHTER, Rolf
    461 Rolling Road
    Rosemont
    Pa 19010
    Usa
    Administrateur
    461 Rolling Road
    Rosemont
    Pa 19010
    Usa
    BritishManaging Director46318330002

    VFI NORTH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 janv. 2001
    Livré le 01 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the terms of the loan agreement
    Brèves mentions
    The property known as 101 broadway salford quays salford title number GM588725. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Vlasic Foods International Inc
    Transactions
    • 01 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 avr. 1986
    Livré le 29 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 29 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    Mortgage and charge
    Créé le 17 mars 1986
    Livré le 25 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5X elbiscan 2000 electronic sorters serial nos:84/001/002/003/004/005.please see doc M51 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transactions
    • 25 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 07 nov. 1985
    Livré le 19 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from wold PLC to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7TH november 1985
    Brèves mentions
    Legal mortgage-land lying to the west of birchin way & land on the north side of birchin way,west marsh mills,grimbsy. See doc M50 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Investment Bank Limited
    Transactions
    • 19 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 28 juin 1985
    Livré le 19 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Merchant Bank Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 nov. 1984
    Livré le 07 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M48 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Merchant Bank Limited
    Transactions
    • 07 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    Mortgage & charge
    Créé le 29 août 1984
    Livré le 31 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5X elbiscan 2000 electronic sorters,serial nos:84.001/002/003/004/005 And charge by way of legal mortgage insofar as such goods and fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transactions
    • 31 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 02 juil. 1984
    Livré le 16 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 06 févr. 1984
    Livré le 16 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Merchant Bank Limited
    Transactions
    • 16 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 janv. 1984
    Livré le 19 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 mai 1982
    Livré le 15 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or wold (F.F.) europe limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Merchant Bank Limited
    Transactions
    • 15 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 mai 1982
    Livré le 15 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or wold (F.F.) europe limitd to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 15 avr. 1981
    Livré le 23 avr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 3/9/73
    Brèves mentions
    A specific charge over the benefit of all bookdebts & other debts as are now or may from time to time be owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1981Enregistrement d'une charge

    VFI NORTH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 nov. 2001Commencement of winding up
    08 nov. 2001Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William Scott Martin
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    Trevor Nigel Birch
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0