TRENTS LEISURE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TRENTS LEISURE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00882956 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRENTS LEISURE LIMITED ?
Adresse du siège social | Mccoll's House Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Essex |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRENTS LEISURE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 26 nov. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour TRENTS LEISURE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Jeremy Ian Fuller en tant que directeur le 22 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robbie Ian Bell en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Jeremy Ian Fuller le 24 oct. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bernadette Clare Young en tant que secrétaire le 07 sept. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 nov. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 29 août 2018
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Green en tant qu'administrateur le 22 août 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Bernadette Clare Young en tant que secrétaire le 22 août 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Jonathan Miller en tant que secrétaire le 22 août 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 nov. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 29 nov. 2015 | 4 pages | AAMD | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 nov. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Simon Jeremy Ian Fuller en tant qu'administrateur le 26 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Lancaster en tant que directeur le 26 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kingsley John Tedder en tant que secrétaire le 12 août 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TRENTS LEISURE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL, Robbie Ian | Administrateur | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | Chief Financial Officer | 97384120002 | ||||
GREEN, Steven | Administrateur | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | Director | 209349290001 | ||||
MILLER, Simon Jonathan | Administrateur | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | Director | 88269280005 | ||||
BARNES, Christopher Howard | Secrétaire | 11 Hepplewhite Close Baughurst RG26 5HD Basingstoke Hampshire | British | 25597650001 | ||||||
GOSNELL, Michael James | Secrétaire | The Birches 1 Lowfield Close GU18 5QT Lightwater Surrey | British | 10496160001 | ||||||
MILLER, Simon Jonathan | Secrétaire | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 88269280005 | ||||||
TAYLOR, Philip John Graham | Secrétaire | Cherry Tree House 19 Hill Road GU27 2JN Haslemere Surrey | British | 10082610001 | ||||||
TEDDER, Kingsley John | Secrétaire | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 101631010002 | ||||||
YOUNG, Bernadette Clare | Secrétaire | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | 237939310001 | |||||||
AGUSS, Martyn James | Administrateur | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | Director | 107991420002 | ||||
COX, Allister Russell | Administrateur | The Small House Mynthurst Leigh RH2 8RJ Reigate Surrey | England | British | Finance Director | 31500810002 | ||||
CULLENS, Alan | Administrateur | 4 Alexandra House Queens Hill Lodge SL5 7EQ Ascot Berkshire | United Kingdom | British | Director | 6875310002 | ||||
FULLER, Simon Jeremy Ian | Administrateur | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | Finance Director | 181763320002 | ||||
HANNA, Robert Houston | Administrateur | Cherry Garth Stokesheath Road Oxshott KT22 0PS Leatherhead Surrey | British | Director | 10082620001 | |||||
LANCASTER, James | Administrateur | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | Company Director | 147052660001 | ||||
WILKINSON, Stephen William | Administrateur | Martin Mccoll House Ashwells Road, CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood Essex | United Kingdom | British | Director | 101631100002 | ||||
WOOLHOUSE, Anthony Peter | Administrateur | Wellbourne Vicarage Hill GU9 8HG Farnham Surrey | British | Director | 10496200001 | |||||
WYATT, Peter Robert Michael | Administrateur | Frogs Close Clayford Lane TA22 9RH Dulverton West Somerset | British | Director | 10082630001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRENTS LEISURE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nss Newsagents Retail Limited | 06 avr. 2016 | Ashwells Road Pilgrims Hatch CM15 9ST Brentwood Mccolls House Essex England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
TRENTS LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Créé le 28 nov. 1998 Livré le 08 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 24 juil. 1995 Livré le 31 juil. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 17 mars 1982 Livré le 20 mars 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H 25 bridge street, swindon wiltshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 22 janv. 1980 Livré le 04 févr. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H 262/264 oxford road, reading, berks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 22 sept. 1978 Livré le 03 oct. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h or l/h property, all stocks shares or other securities, all book and other debts. Assignment of goodwill. Floating charge over the undertaking and all other property and assets present and future (see doc M31). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0