TRENTS LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRENTS LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00882956
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRENTS LEISURE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TRENTS LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mccoll's House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TRENTS LEISURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 nov. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour TRENTS LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Simon Jeremy Ian Fuller en tant que directeur le 22 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robbie Ian Bell en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Jeremy Ian Fuller le 24 oct. 2018

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Bernadette Clare Young en tant que secrétaire le 07 sept. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 26 nov. 2017

    4 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 août 2018

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Steven Green en tant qu'administrateur le 22 août 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Bernadette Clare Young en tant que secrétaire le 22 août 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Simon Jonathan Miller en tant que secrétaire le 22 août 2017

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 27 nov. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 29 nov. 2015

    4 pagesAAMD

    Comptes pour une société dormante établis au 29 nov. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juin 2016

    État du capital au 07 juin 2016

    • Capital: GBP 27,500
    SH01

    Nomination de Mr Simon Jeremy Ian Fuller en tant qu'administrateur le 26 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Lancaster en tant que directeur le 26 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kingsley John Tedder en tant que secrétaire le 12 août 2015

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2014

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TRENTS LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELL, Robbie Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Administrateur
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishChief Financial Officer97384120002
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Administrateur
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishDirector209349290001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Administrateur
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector88269280005
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    GOSNELL, Michael James
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    Secrétaire
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    British10496160001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Secrétaire
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    TAYLOR, Philip John Graham
    Cherry Tree House 19 Hill Road
    GU27 2JN Haslemere
    Surrey
    Secrétaire
    Cherry Tree House 19 Hill Road
    GU27 2JN Haslemere
    Surrey
    British10082610001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Secrétaire
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Secrétaire
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237939310001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Administrateur
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector107991420002
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Administrateur
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director31500810002
    CULLENS, Alan
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector6875310002
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Administrateur
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishFinance Director181763320002
    HANNA, Robert Houston
    Cherry Garth Stokesheath Road
    Oxshott
    KT22 0PS Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Garth Stokesheath Road
    Oxshott
    KT22 0PS Leatherhead
    Surrey
    BritishDirector10082620001
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Administrateur
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishCompany Director147052660001
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishDirector101631100002
    WOOLHOUSE, Anthony Peter
    Wellbourne
    Vicarage Hill
    GU9 8HG Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Wellbourne
    Vicarage Hill
    GU9 8HG Farnham
    Surrey
    BritishDirector10496200001
    WYATT, Peter Robert Michael
    Frogs Close
    Clayford Lane
    TA22 9RH Dulverton
    West Somerset
    Administrateur
    Frogs Close
    Clayford Lane
    TA22 9RH Dulverton
    West Somerset
    BritishDirector10082630001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRENTS LEISURE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccolls House
    Essex
    England
    06 avr. 2016
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccolls House
    Essex
    England
    Non
    Forme juridiqueProvate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2016
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement80028
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    TRENTS LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 nov. 1998
    Livré le 08 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 juil. 1995
    Livré le 31 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 17 mars 1982
    Livré le 20 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 25 bridge street, swindon wiltshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 22 janv. 1980
    Livré le 04 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 262/264 oxford road, reading, berks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 22 sept. 1978
    Livré le 03 oct. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h or l/h property, all stocks shares or other securities, all book and other debts. Assignment of goodwill. Floating charge over the undertaking and all other property and assets present and future (see doc M31).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1978Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0