ROCK REFRIGERATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROCK REFRIGERATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00885574
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROCK REFRIGERATION LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe ROCK REFRIGERATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 The Briars
    Waterberry Drive
    PO7 7YH Waterlooville
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ROCK REFRIGERATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour ROCK REFRIGERATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Strike off of company 04/09/2009
    RES13

    legacy

    pages652a

    legacy

    pages363a

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    pagesAA

    legacy

    pages288b

    Comptes établis au 30 sept. 2007

    pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Change of ro 08/05/2008
    RES13

    legacy

    pages287

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288a

    Comptes établis au 30 sept. 2006

    pagesAA

    legacy

    pages287

    legacy

    pages363s

    legacy

    pages225

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    pagesAA

    legacy

    pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    pagesAA

    legacy

    pages287

    Qui sont les dirigeants de ROCK REFRIGERATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AYRE, Mark
    Vermont Crescent
    IP4 2ST Ipswich
    24
    Suffolk
    Administrateur
    Vermont Crescent
    IP4 2ST Ipswich
    24
    Suffolk
    EnglandBritishController Building Efficiency Group129877500001
    OKARMA, Jerome Dennis
    1108 E Lexington Boulevard
    Whitefish Bay
    Wisconsin 53217
    Usa
    Administrateur
    1108 E Lexington Boulevard
    Whitefish Bay
    Wisconsin 53217
    Usa
    AmericanAmericanGeneral Council66211160002
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Secrétaire
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    British63261140001
    DUNK, Robert Mark
    175 Lower Mortlake Road
    TW9 2LP Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    175 Lower Mortlake Road
    TW9 2LP Richmond
    Surrey
    British105833020001
    KNAPMAN, Peter
    1 Roseacre
    Worsley
    M28 1YT Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Roseacre
    Worsley
    M28 1YT Manchester
    Lancashire
    BritishDirector22182580001
    MILLER, John David
    Apple Orchard
    Windmill Road, Weald
    TN14 6PH Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Apple Orchard
    Windmill Road, Weald
    TN14 6PH Sevenoaks
    Kent
    BritishChartered Accountant72113760001
    MORGAN, John David
    19 Grosvenor Road
    SS7 1NP South Benfleet
    Essex
    Secrétaire
    19 Grosvenor Road
    SS7 1NP South Benfleet
    Essex
    British35029410001
    ALBON, Michael Harold
    Rose Cottage Old Main Road
    Costock
    Loughborough
    Leics
    Administrateur
    Rose Cottage Old Main Road
    Costock
    Loughborough
    Leics
    BritishDirector20459100001
    BACK, David Frederick
    19 Summerbridge Close
    Carlinghow
    WF17 8ET Batley
    West Yorkshire
    Administrateur
    19 Summerbridge Close
    Carlinghow
    WF17 8ET Batley
    West Yorkshire
    BritishTechnical Sales Director29758640001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishFinancial Director63261140001
    DANIELS, Stephen Edward
    60 Grange Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 5JP Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    60 Grange Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 5JP Stockport
    Cheshire
    BritishEngineer45898880001
    DUDLEY, Jeffrey
    8 Buckley Close
    Gee Cross
    SK14 5LG Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    8 Buckley Close
    Gee Cross
    SK14 5LG Hyde
    Cheshire
    BritishDirector22182620001
    DUNK, Robert Mark
    175 Lower Mortlake Road
    TW9 2LP Richmond
    Surrey
    Administrateur
    175 Lower Mortlake Road
    TW9 2LP Richmond
    Surrey
    BritishGroup Counsel105833020001
    EDSON, Robert William
    559 Tamworth Road
    Long Eaton
    NG10 3FB Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    559 Tamworth Road
    Long Eaton
    NG10 3FB Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector70824260002
    HARRIS, Brian
    5 Longthorpe Green
    PE3 6LS Peterborough
    Administrateur
    5 Longthorpe Green
    PE3 6LS Peterborough
    BritishCompany Director61522200001
    HOWELLS, Ian
    5 Newport Road
    MK19 7NA Hanslope
    Buckinghamshire
    Administrateur
    5 Newport Road
    MK19 7NA Hanslope
    Buckinghamshire
    BritishFin Director76129590003
    IVERSEN, Kjeld Lindberg
    Humlevej 12
    Dk-8240 Risskov
    Denmark
    Administrateur
    Humlevej 12
    Dk-8240 Risskov
    Denmark
    DanishChief Financial Officer62027730001
    JOHNSON, James Anthony
    43 Bradman Drive
    Riverside
    DH3 3QS Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    43 Bradman Drive
    Riverside
    DH3 3QS Chester Le Street
    County Durham
    BritishAccountant77891700002
    KNAPMAN, Peter
    1 Roseacre
    Worsley
    M28 1YT Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    1 Roseacre
    Worsley
    M28 1YT Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishDirector22182580001
    MILLER, John David
    Apple Orchard
    Windmill Road, Weald
    TN14 6PH Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Apple Orchard
    Windmill Road, Weald
    TN14 6PH Sevenoaks
    Kent
    BritishChartered Accountant72113760001
    PENNINGTON, Harry
    1 Carlton Close
    Blackrod
    BL6 5DL Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    1 Carlton Close
    Blackrod
    BL6 5DL Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector3098890001
    PRICE, Katherine Mary
    62 Milbourne Lane
    KT10 9EA Esher
    Surrey
    Administrateur
    62 Milbourne Lane
    KT10 9EA Esher
    Surrey
    BritishManaging Director69139230001
    RASMUSSEN, Fritz Peter
    15 Hartley Place
    Vicarage Road
    B15 3HS Edgbaston
    Birmingham
    Administrateur
    15 Hartley Place
    Vicarage Road
    B15 3HS Edgbaston
    Birmingham
    DanishDirector75382370002
    ROGERS, Nigel Foster
    Bents Farm 2 Pebble Beach
    Whitburn
    SR6 7NY Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Bents Farm 2 Pebble Beach
    Whitburn
    SR6 7NY Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishAccountant36520190001
    ROSSALL, Paul Vincent
    2 Green Gate
    Syerston
    NG23 5NF Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    2 Green Gate
    Syerston
    NG23 5NF Newark
    Nottinghamshire
    BritishDirector7421190001
    SALE, Timothy Rawlinson
    Welton Town Farm
    NE43 7UL Welton
    Northumberland
    Administrateur
    Welton Town Farm
    NE43 7UL Welton
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector60327530002
    SEWARD, Brian Steven
    5 Kempnough Hall Road
    Worsley
    M28 2QP Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    5 Kempnough Hall Road
    Worsley
    M28 2QP Manchester
    Lancashire
    BritishDirector3098910001
    SEWARD, Robert Thomas
    262 Leigh Road
    M28 1LF Worsley
    Manchester
    Administrateur
    262 Leigh Road
    M28 1LF Worsley
    Manchester
    United KingdomBritishDirector55144710001
    TITTLE, David
    The White House 189 Derby Road
    Beeston
    NG9 3JA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The White House 189 Derby Road
    Beeston
    NG9 3JA Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector6444580001
    VARNAM, Roy
    Chestnut Lodge
    Main Street
    NG14 7EU Gunthorpe
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Chestnut Lodge
    Main Street
    NG14 7EU Gunthorpe
    Nottinghamshire
    BritishDirector27564650001

    ROCK REFRIGERATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 10 nov. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 10 nov. 1997
    Livré le 18 nov. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 14 janv. 1997
    Livré le 16 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land and buildings on the north east side of woodhouse street newton heath manchester with the benefit of all rights licences guarantees any goodwill of any business any rental and all other payments.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 13 août 1996
    Livré le 14 août 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    763 oldham road, newton heath, manchester with the benefit of all rights etc., any goodwill of any business, any rental and all other payments.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 24 déc. 1982
    Livré le 05 janv. 1983
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 1982
    Livré le 08 avr. 1982
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on north east side of woodhouse street, manchester constituting the site of former st anne's school st ann's street newton heath manchester, title no la 353261.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 06 mars 1979
    Livré le 13 mars 1979
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises being: st. Anne's street, off oldham road newton heath, manchester, together with all fixtures title no gm 52411.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank LTD
    Transactions
    • 13 mars 1979Enregistrement d'une charge
    Irredocable authority
    Créé le 22 mai 1978
    Livré le 06 juin 1978
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H premises at st.annes street, off oldham road newton heath manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank LTD
    Transactions
    • 06 juin 1978Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 06 nov. 1969
    Livré le 17 nov. 1969
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank LTD
    Transactions
    • 17 nov. 1969Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0