MARSDENS PHARMACY LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MARSDENS PHARMACY LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00888978 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MARSDENS PHARMACY LIMITED ?
Adresse du siège social | 2 Peterwood Way CR0 4UQ Croydon Surrey England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MARSDENS PHARMACY LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour MARSDENS PHARMACY LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 mars 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kirit Chimanbhai Patel en tant que directeur le 16 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Lion House Red Lion Street London WC1R 4GB à 2 Peterwood Way Croydon Surrey CR0 4UQ le 03 mars 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2015 au 30 mars 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Nalin Morjaria en tant que directeur le 01 juin 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jayanti Chimanbhai Patel Junior en tant qu'administrateur le 01 juin 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Heena Patel en tant qu'administrateur le 01 juin 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Kirit Chimanbhai Patel Junior en tant qu'administrateur le 01 juin 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Kirit Chimanbhai Patel en tant qu'administrateur le 01 août 2013 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ameetkumar Ramnbhai Patel en tant que secrétaire le 01 juin 2015 | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bhavin Morjaria en tant que directeur le 01 juin 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Spa Pharmacy 4 Westgate Ripon North Yorkshire HG4 2AT à Lion House Red Lion Street London WC1R 4GB le 11 juin 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Winn and Co 62-63 Westborough Scarborough North Yorkshire YO11 1TS* le 11 déc. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 7 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de MARSDENS PHARMACY LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATEL, Ameetkumar Ramnbhai | Secrétaire | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | 198473160001 | |||||||
PATEL, Heena | Administrateur | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 62369320002 | ||||
PATEL JUNIOR, Jayanti Chimanbhai | Administrateur | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | England | British | Director | 174158560001 | ||||
PATEL JUNIOR, Kirit Chimanbhai | Administrateur | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | England | British | Director | 101281110001 | ||||
CLARKE, Celia Jean | Secrétaire | West Mews Boldron Lane Startforth DL12 9AR Barnard Castle Co Durham | British | 23459300001 | ||||||
HERDMAN, Nigel Dale | Secrétaire | 2 Westfield Drive NE3 4XT Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Pharmacist | 48892640006 | |||||
MARSDEN, Hazel Ann | Secrétaire | Bishopton HG4 2QL Ripon Bishopton Rise North Yorkshire | British | Company Director | 44407680001 | |||||
CLARKE, Celia Jean | Administrateur | West Mews Boldron Lane Startforth DL12 9AR Barnard Castle Co Durham | British | Company Director/Housewife | 23459300001 | |||||
CLARKE, Colin | Administrateur | West Mews 7 Boldron Lane DL12 9AR Barnard Castle County Durham | British | Pharmacist | 71297180001 | |||||
CLARKE, Colin | Administrateur | West Mews 7 Boldron Lane DL12 9AR Barnard Castle County Durham | British | Company Director/Pharmacist | 71297180001 | |||||
HERDMAN, Alison Mary | Administrateur | 2 Westfield Drive NE3 4XT Gosforth Newcastle Upon Tyne | England | British | Pharmacist | 22785460006 | ||||
HERDMAN, Nigel Dale | Administrateur | 2 Westfield Drive NE3 4XT Gosforth Newcastle Upon Tyne | England | British | Pharmacist | 48892640006 | ||||
MARSDEN, Hazel Ann | Administrateur | Bishopton HG4 2QL Ripon Bishopton Rise North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 44407680001 | ||||
MARSDEN, Richard Stephen | Administrateur | Bishopton HG4 2QL Ripon Bishopton Rise North Yorkshire | England | British | Pharmacist | 19086970001 | ||||
MORJARIA, Bhavin, Mr. | Administrateur | Sandringham Road N22 6RB London 25 Uk | Uk | British | Director | 165434900001 | ||||
MORJARIA, Nalin | Administrateur | Sandringham Road N22 6RB London 25 Uk | Uk | British | Occupational Psychologist | 13151460001 | ||||
PATEL, Kirit Chimanbhai | Administrateur | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | England | British | Director | 11545120001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MARSDENS PHARMACY LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.S. Marsden (Chemist) Limited | 06 avr. 2016 | Peterwood Way CR0 4UQ Croydon 2 Surrey England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
MARSDENS PHARMACY LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 30 nov. 2012 Livré le 06 déc. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the group (or any group member)on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 03 nov. 2003 Livré le 21 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage l/h property 86 galgate barnard castle co durham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 19 mai 1999 Livré le 02 juin 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and herdman pharmacies (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 mai 1999 Livré le 02 juin 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 86 galgate,barnard castle,durham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 16 nov. 1994 Livré le 18 nov. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 27 nov. 1981 Livré le 28 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 86 glagate bernard castle, co. Durham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0