NUMARK MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNUMARK MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00889922
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NUMARK MANAGEMENT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NUMARK MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Numark House
    5/6 Fairway Court Amber Close
    B77 4RP Tamworth Business Park
    Tamworth Staffs
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NUMARK MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    N.P.U.MARKETING LIMITED18 oct. 196618 oct. 1966

    Quels sont les derniers comptes de NUMARK MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour NUMARK MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 nov. 2012

    État du capital au 02 nov. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 févr. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c capital redemption a/c and revaluation a/c to nil 21/02/2012
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Rowland Cole en tant que directeur le 31 janv. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Nomination de Mr Paul Jonathan Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen John William Marks le 04 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NUMARK MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARKS, Stephen John William
    33 Kelsey Lane
    Balsall Common
    CV7 7GR Coventry
    Secrétaire
    33 Kelsey Lane
    Balsall Common
    CV7 7GR Coventry
    BritishDirector51336290002
    HUDSON, Kevin Robert
    4 Dean Drive
    WA14 3NE Bowdon
    Cheshire
    Administrateur
    4 Dean Drive
    WA14 3NE Bowdon
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69091720002
    MARKS, Stephen John William
    33 Kelsey Lane
    Balsall Common
    CV7 7GR Coventry
    Administrateur
    33 Kelsey Lane
    Balsall Common
    CV7 7GR Coventry
    United KingdomBritishDirector51336290002
    SMITH, Paul Jonathan
    Numark House
    5/6 Fairway Court Amber Close
    B77 4RP Tamworth Business Park
    Tamworth Staffs
    Administrateur
    Numark House
    5/6 Fairway Court Amber Close
    B77 4RP Tamworth Business Park
    Tamworth Staffs
    WalesBritishDirector63118770002
    MILLER, Bernard Victor
    11 Grandborough Drive
    B91 3TS Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    11 Grandborough Drive
    B91 3TS Solihull
    West Midlands
    British 1538030003
    BASELEY, John
    Rosslyn House
    13 Rosslyn Road
    CM12 9JN Billericay
    Essex
    Administrateur
    Rosslyn House
    13 Rosslyn Road
    CM12 9JN Billericay
    Essex
    United KingdomBritishDirector73190660001
    BUTLER, Edwin Hugh
    Courtyard House 10 Main Street
    Frisby On The Wreake
    LE14 2NJ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Courtyard House 10 Main Street
    Frisby On The Wreake
    LE14 2NJ Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector1538050001
    COLE, David Rowland
    Bentleys Farm
    Woodhouse Lane
    LL13 0ST Marchwiel
    Clwyd
    Administrateur
    Bentleys Farm
    Woodhouse Lane
    LL13 0ST Marchwiel
    Clwyd
    WalesBritishDirector74246120001
    GARLICK, Antony John
    1 Malvern Road
    BD9 6AR Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Malvern Road
    BD9 6AR Bradford
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector1538060001
    LOW, Douglas Gilmour
    20 Craigmillar Avenue
    Milngavie
    G62 8AX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    20 Craigmillar Avenue
    Milngavie
    G62 8AX Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChairman16852250001
    MARSHALL, Peter
    12 Raikes Avenue
    BD23 1LP Skipton
    North Yorkshire
    Administrateur
    12 Raikes Avenue
    BD23 1LP Skipton
    North Yorkshire
    BritishPharmacist5517750002
    MILLER, Bernard Victor
    11 Grandborough Drive
    B91 3TS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    11 Grandborough Drive
    B91 3TS Solihull
    West Midlands
    British 1538030003
    NORRIS, Terence John
    Cornerways Roman Road
    Little Aston
    B74 3AA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    Cornerways Roman Road
    Little Aston
    B74 3AA Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishManaging Director16852260001
    SIMMS, Stephen Cochrane
    41 Hillhead Road
    Dundonald
    BT16 1XD Belfast
    County Antrim
    Administrateur
    41 Hillhead Road
    Dundonald
    BT16 1XD Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritishDirector64742990001
    WOOD, David Andrew
    Cobweb Barn
    Ingleby Lane
    DE73 7JQ Ticknall
    Derbyshire
    Administrateur
    Cobweb Barn
    Ingleby Lane
    DE73 7JQ Ticknall
    Derbyshire
    BritishDirector118111950001
    WOOD, Richard Kenneth
    39 Astra Court
    Hythe Marina
    SO45 6DZ Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    39 Astra Court
    Hythe Marina
    SO45 6DZ Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishChief Executive102208990001
    WRAGG, Charles Edward
    43 Allerton Drive
    Nether Poppleton
    YO2 6NL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    43 Allerton Drive
    Nether Poppleton
    YO2 6NL York
    North Yorkshire
    BritishDirector3033950001
    YOUNG, Alexander Stuart
    Pistyll House Farm
    Cox Lane Marford
    LL12 8YS Wrexham
    North Wales
    Administrateur
    Pistyll House Farm
    Cox Lane Marford
    LL12 8YS Wrexham
    North Wales
    BritishDirector1538090001

    NUMARK MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 01 mars 1993
    Livré le 03 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    51 boreham road warminster wiltshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 01 mars 1993
    Livré le 03 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 and 6 fairway court amber close tamworth. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 13 janv. 1992
    Livré le 21 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 5 and 6 fairway court,amber close tamworth business park,tamworth,staffs. T/nos.sf 269569 and sf 279411 (freehold). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 juil. 1991
    Livré le 05 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    51, boreham road, warminster, wilts and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0