TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00892968 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | LIQ13 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Towergate House Eclipse Park, Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN à 15 Canada Square London E14 5GL le 11 sept. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Christopher Ross en tant qu'administrateur le 20 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Jacqueline Anne Gregory en tant que secrétaire le 20 déc. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Jennifer Owens en tant que secrétaire le 01 mars 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Stephen Mugge le 25 nov. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Scott Egan en tant que directeur le 14 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Stephen Mugge en tant qu'administrateur le 11 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Steven Hodges en tant que directeur le 17 oct. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed hall & clarke insurance brokers LIMITED\certificate issued on 12/08/14 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Jennifer Owens en tant que secrétaire le 25 nov. 2013 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Samuel Thomas Budgen Clark en tant que secrétaire le 08 oct. 2013 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secrétaire | Canada Square E14 5GL London 15 | 221958200001 | |||||||
| MUGGE, Mark Stephen | Administrateur | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | 162920630005 | |||||
| ROSS, David Christopher | Administrateur | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Irish | 222326970001 | |||||
| CLARK, Darryl | Secrétaire | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | 153022630001 | |||||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Secrétaire | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | 161870940001 | |||||||
| CLARKE, Margaret Mary | Secrétaire | Lawford Wokingham Road Hurst RG10 0RX Reading Berkshire | British | 8288020001 | ||||||
| CRATON, Timothy Charles | Secrétaire | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | British | 76055420004 | ||||||
| HUNTER, Andrew Stewart | Secrétaire | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | 156618560001 | |||||||
| OWENS, Jennifer | Secrétaire | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | 183298770001 | |||||||
| REDDI, John | Secrétaire | Farbank 21 First Avenue BN14 9NJ Worthing West Sussex | British | 6180280001 | ||||||
| BAKER, Peter James | Administrateur | 50 Honister Heights CR8 1EU Purley Surrey | British | 8288030001 | ||||||
| BOGART, Robert Patrick | Administrateur | 21 Beech Way Wheathampstead AL4 8LY St Albans Hertfordshire | Scotland | British | 104023310001 | |||||
| BOLSHAW, Matthew | Administrateur | Chipperfield Back Lane WD25 8EJ Letchmore Heath Hertfordshire | England | British | 98898670002 | |||||
| CLARKE, Dudley John | Administrateur | Lawford Wokingham Road Hurst RG10 0RX Reading Berkshire | British | 8288040001 | ||||||
| CLARKE, Simon John | Administrateur | Westbury Harvest Hill SL8 5JJ Hedsor Buckinghamshire | British | 41695010003 | ||||||
| CULLUM, Peter Geoffrey | Administrateur | Wealden Hall Parkfield TN15 0HX Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 59873490009 | |||||
| EARL, David George | Administrateur | Cecil Close CM23 5RD Bishop's Stortford 5 Hertfordshire | England | British | 109451630001 | |||||
| EGAN, Scott | Administrateur | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | England | British | 170703910001 | |||||
| HODGES, Mark Steven | Administrateur | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 58444370003 | |||||
| JOHNSON, Timothy David | Administrateur | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | 129538180001 | |||||
| PHILIP, Timothy Duncan | Administrateur | 20 The Old Saw Mill Long Mill Lane Platt TN15 8QJ Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 99066410001 | |||||
| PROVERBS, Antony | Administrateur | 27 Capital Wharf 50 Wapping High Street E1W 1LY London | England | British | 79185700012 | |||||
| STEMP, Timothy Daniel | Administrateur | Orchard Cottage Bellington HP5 2XW Chesham Buckinghamshire | England | English | 72526930003 | |||||
| TORRANCE, David Winton Watt | Administrateur | Allt A'Bruaich IV4 7HX Kiltarlity Inverness-Shire | Uk | British | 5901560006 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Towergate Insurance Limited | 06 avr. 2016 | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Créé le 17 août 2000 Livré le 30 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 302-308 preston road, harrow, middlesex. T/no. NGL725723. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 31 juil. 1997 Livré le 01 août 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Further charge | Créé le 24 avr. 1985 Livré le 26 avr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti £15,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 17.12.81. | |
Brèves mentions (1) f/H. Land and buildings known as 67 park royal road park royal, acton, ealing london. Title no: mx 474707. (2) f/h land and buildings known as stone at 249 acton lane, park royal, acton. Title no: ngl 517926. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 19 avr. 1984 Livré le 02 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge on all book & other debts with a floating charge all the (please see doc M45). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 17 janv. 1984 Livré le 24 janv. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a lawford wokingham road hurst berkshire title no bk 80844. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 déc. 1982 Livré le 08 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti £58,773.25 and further advances from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H land & land k/a "lawford" workingham road, hurst berkshire title no bk 80844. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 17 déc. 1981 Livré le 21 déc. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti £25,000.25 and all other monies due or to beome due from the company to the chargee. | |
Brèves mentions F/H land & offices at 67 park royal road, acton london borough of ealing. Title no:- mx 474707. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 01 avr. 1980 Livré le 11 avr. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land & premises being 67 park royal road, acton, london borough of ealing. Tog. With all fixtures. Title no:- mx 474707. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0