TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00892968
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALL & CLARKE INSURANCE BROKERS LIMITED30 juil. 200830 juil. 2008
    HALL & CLARKE INSURANCE BROKERS LIMITED26 août 200526 août 2005
    HALL & CLARKE INSURANCE BROKERS PLC18 nov. 198618 nov. 1986
    HALL AND CLARKE (INSURANCE CONSULTANTS) LIMITED29 nov. 196629 nov. 1966

    Quels sont les derniers comptes de TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Towergate House Eclipse Park, Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN à 15 Canada Square London E14 5GL le 11 sept. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 août 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Déclaration de confirmation établie le 20 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr David Christopher Ross en tant qu'administrateur le 20 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jacqueline Anne Gregory en tant que secrétaire le 20 déc. 2016

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 mai 2016

    État du capital au 13 mai 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Jennifer Owens en tant que secrétaire le 01 mars 2016

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Stephen Mugge le 25 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Scott Egan en tant que directeur le 14 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Stephen Mugge en tant qu'administrateur le 11 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 avr. 2015

    État du capital au 29 avr. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Mark Steven Hodges en tant que directeur le 17 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed hall & clarke insurance brokers LIMITED\certificate issued on 12/08/14
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name12 août 2014

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 avr. 2014

    État du capital au 22 avr. 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomination de Jennifer Owens en tant que secrétaire le 25 nov. 2013

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Samuel Thomas Budgen Clark en tant que secrétaire le 08 oct. 2013

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    221958200001
    MUGGE, Mark Stephen
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish162920630005
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    153022630001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    161870940001
    CLARKE, Margaret Mary
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    British8288020001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    British76055420004
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    156618560001
    OWENS, Jennifer
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    183298770001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Secrétaire
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    BAKER, Peter James
    50 Honister Heights
    CR8 1EU Purley
    Surrey
    Administrateur
    50 Honister Heights
    CR8 1EU Purley
    Surrey
    British8288030001
    BOGART, Robert Patrick
    21 Beech Way
    Wheathampstead
    AL4 8LY St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Beech Way
    Wheathampstead
    AL4 8LY St Albans
    Hertfordshire
    ScotlandBritish104023310001
    BOLSHAW, Matthew
    Chipperfield
    Back Lane
    WD25 8EJ Letchmore Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Chipperfield
    Back Lane
    WD25 8EJ Letchmore Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish98898670002
    CLARKE, Dudley John
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    British8288040001
    CLARKE, Simon John
    Westbury
    Harvest Hill
    SL8 5JJ Hedsor
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Westbury
    Harvest Hill
    SL8 5JJ Hedsor
    Buckinghamshire
    British41695010003
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish59873490009
    EARL, David George
    Cecil Close
    CM23 5RD Bishop's Stortford
    5
    Hertfordshire
    Administrateur
    Cecil Close
    CM23 5RD Bishop's Stortford
    5
    Hertfordshire
    EnglandBritish109451630001
    EGAN, Scott
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish170703910001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Administrateur
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritish129538180001
    PHILIP, Timothy Duncan
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish99066410001
    PROVERBS, Antony
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    Administrateur
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    EnglandBritish79185700012
    STEMP, Timothy Daniel
    Orchard Cottage
    Bellington
    HP5 2XW Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Orchard Cottage
    Bellington
    HP5 2XW Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish72526930003
    TORRANCE, David Winton Watt
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    Administrateur
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    UkBritish5901560006

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Towergate Insurance Limited
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    06 avr. 2016
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement07476462
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 30 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 302-308 preston road, harrow, middlesex. T/no. NGL725723. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 juil. 1997
    Livré le 01 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further charge
    Créé le 24 avr. 1985
    Livré le 26 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 17.12.81.
    Brèves mentions
    (1) f/H. Land and buildings known as 67 park royal road park royal, acton, ealing london. Title no: mx 474707. (2) f/h land and buildings known as stone at 249 acton lane, park royal, acton. Title no: ngl 517926.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Building Society
    Transactions
    • 26 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 19 avr. 1984
    Livré le 02 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book & other debts with a floating charge all the (please see doc M45). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 17 janv. 1984
    Livré le 24 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a lawford wokingham road hurst berkshire title no bk 80844.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 07 déc. 1982
    Livré le 08 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £58,773.25 and further advances from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land & land k/a "lawford" workingham road, hurst berkshire title no bk 80844.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Building Society
    Transactions
    • 08 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 17 déc. 1981
    Livré le 21 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £25,000.25 and all other monies due or to beome due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    F/H land & offices at 67 park royal road, acton london borough of ealing. Title no:- mx 474707.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Building Society
    Transactions
    • 21 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1980
    Livré le 11 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises being 67 park royal road, acton, london borough of ealing. Tog. With all fixtures. Title no:- mx 474707.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 1980Enregistrement d'une charge

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 mai 2018Dissolved on
    15 août 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0