TUSCARORA (LONDON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTUSCARORA (LONDON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00893681
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TUSCARORA (LONDON) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe TUSCARORA (LONDON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    SCA PACKAGING LIMITED
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PE Darlington
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TUSCARORA (LONDON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARROWTIP MOULDINGS LIMITED17 sept. 199017 sept. 1990
    ARROWTIP LIMITED08 déc. 196608 déc. 1966

    Quels sont les derniers comptes de TUSCARORA (LONDON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour TUSCARORA (LONDON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2010

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    État du capital après une attribution d'actions au 14 oct. 2010

    • Capital: GBP 36,897
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    5 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de TUSCARORA (LONDON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SYKES, Victoria
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    Secrétaire
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    British138121210001
    HEYS, Thomas David
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    Administrateur
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    EnglandBritishManaging Director Speciality Products Division133589280001
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Administrateur
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Executive60781190001
    EYLES, Melanie
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    Secrétaire
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    British130563500001
    STAPLES, Anthony John
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    Secrétaire
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    British45838190001
    TAMBAYAH, Navam
    7 Norland Square
    Holland Park
    W11 4PX London
    Secrétaire
    7 Norland Square
    Holland Park
    W11 4PX London
    British2592340001
    TILLSON, Andrew John
    19 Colonial Drive
    Collingtree
    NN4 0BL Northampton
    Secrétaire
    19 Colonial Drive
    Collingtree
    NN4 0BL Northampton
    British54524940001
    BIDDINGER, Scott
    4 Seagrave Court
    Walton
    MK7 7HA Milton Keynes
    Bucks
    Administrateur
    4 Seagrave Court
    Walton
    MK7 7HA Milton Keynes
    Bucks
    AmericanManaging Director49882470001
    HILLS, Richard Beverley
    135 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    Administrateur
    135 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    EnglandBritishExpanded Polystyrene Specialist4803200001
    MILLER, Brian Joseph
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    BritishCompany Executive28463460001
    MULLINS, Brian Christopher
    5421 Kipling Road
    Pittsburg 15217
    Pennsylvania
    Usa
    Administrateur
    5421 Kipling Road
    Pittsburg 15217
    Pennsylvania
    Usa
    Us CitizenFinancial Executive49882440001
    RICE, Thomas Anthony
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    IrishFinance And Is Director108501020001
    STEAD, David Richard
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishCompany Executive72400470001
    VIVIAN, John Charles Gerald
    Cock Thorpe Hall
    Pottery House Binham
    NR21 0AL Fakenham
    Norfolk
    Administrateur
    Cock Thorpe Hall
    Pottery House Binham
    NR21 0AL Fakenham
    Norfolk
    BritishExpanded Polystyrene Specialist5569240001
    WILLIAMS, John David
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Executive74014480001

    TUSCARORA (LONDON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 17 mars 1994
    Livré le 26 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Transfer deed
    Créé le 08 oct. 1993
    Livré le 25 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the south eastern side of milverton street extending to the north western side of stannery street and having a frontage to aulton place. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 14 mai 1993
    Livré le 15 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule or any part thereof:one new teubert maschinenbau gmbh unimat pe/pp with omt 12 fold,tank 150L plus periphery elements,serial no:0731 one new maxi recycling plant for epp,kbm,serial no:920521.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 15 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 13 juin 1990
    Livré le 28 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and buildings k/as 33 stannary street london SE11. Together with the fixed plant machinery and other fixtures. Assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 28 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 1984
    Livré le 01 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co. Limited
    Transactions
    • 01 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 juin 1981
    Livré le 15 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 43,775 and all other monies due or to become due from the company to the chargee and agreed charges of sterling pounds 10177.84.
    Brèves mentions
    Two kurtz transfer moulding machines type 710TV machine nos- 277/81 and 276/81 and ancillary equipment. (See doc M33 for details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds and Scottish Trust LTD.
    Transactions
    • 15 juin 1981Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mars 1974
    Livré le 21 mars 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital fixed plant and machinery thereon.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co LTD
    Transactions
    • 21 mars 1974Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    TUSCARORA (LONDON) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 août 2011Dissolved on
    30 nov. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0