HEG (NUMBER 3) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEG (NUMBER 3) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00894639
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEG (NUMBER 3) LIMITED ?

    • (5190) /

    Où se situe HEG (NUMBER 3) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    822 Fountain Court
    Birchwood Boulevard Birchwood
    WA3 7QZ Warrington
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEG (NUMBER 3) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    S.A.F.A. LIMITED02 juin 198202 juin 1982
    SAFETY AND FIRST AID SERVICES (SAFE-AID) LIMITED22 déc. 196622 déc. 1966

    Quels sont les derniers comptes de HEG (NUMBER 3) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HEG (NUMBER 3) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de 17 Chesford Grange Woolston Warrington WA1 4RQ le 27 mai 2010

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 déc. 2009

    État du capital au 14 déc. 2009

    • Capital: GBP 16,260
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Goronwy Philip Ffoulkes Davies le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Lyndon James Gaborit le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 30 juin 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed S.A.F.A. LIMITED\certificate issued on 25/04/08
    3 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages225

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 28 févr. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 28 févr. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de HEG (NUMBER 3) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    BritishChartered Accountant79348050002
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant79348050002
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Administrateur
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    United KingdomAustralianCompany Director133660360001
    AMESBURY, Paula Jill
    10 Vixen Grove
    Upton Park
    WA8 9DS Widnes
    Cheshire
    Secrétaire
    10 Vixen Grove
    Upton Park
    WA8 9DS Widnes
    Cheshire
    BritishAccountant88003020002
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director54189670005
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director47388900001
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Secrétaire
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    AustralianCompany Director65921870004
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Secrétaire
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    AustralianCompany Director65921870004
    HARDMAN, Pamela Rosalind
    17 Ellaby Road
    Rainhill
    L35 4PP Prescot
    Merseyside
    Secrétaire
    17 Ellaby Road
    Rainhill
    L35 4PP Prescot
    Merseyside
    BritishPa67947720001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Secrétaire
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    UTTLEY, Robert David
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    Secrétaire
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    BritishFinancial Consultant37892760001
    VICARY, Gary Kevin
    481 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK3 3AY Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    481 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK3 3AY Stockport
    Cheshire
    British18943850001
    AMESBURY, Paula Jill
    10 Vixen Grove
    Upton Park
    WA8 9DS Widnes
    Cheshire
    Administrateur
    10 Vixen Grove
    Upton Park
    WA8 9DS Widnes
    Cheshire
    BritishAccountant88003020002
    BIRCHALL, Mavis
    10 The Chase
    Huyton
    L36 5YN Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    10 The Chase
    Huyton
    L36 5YN Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director21623180002
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishFinance Director54189670005
    BRUCK, Stuart
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    Administrateur
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    AmericanExecutive57236400002
    CONNOR, Mark
    1 Kings Newnham Road
    Church Lawford
    CV23 9EP Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    1 Kings Newnham Road
    Church Lawford
    CV23 9EP Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritishSales & Marketing Director21614380003
    COWAN, Peter Lawrence
    Flat 1 Hazelfields
    Delamere
    WA14 2NG Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Flat 1 Hazelfields
    Delamere
    WA14 2NG Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director42077520001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Administrateur
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritishCompany Director115844000001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director47388900001
    FLATTERY, Brendan Peter
    71 Stones Drive
    Ripponden
    HX6 4NY Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    71 Stones Drive
    Ripponden
    HX6 4NY Halifax
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant76477170001
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Administrateur
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    AustralianDirector65921870004
    IRELAND, Howard
    12 Truro Close
    SK7 2QN Bramhall
    Cheshire
    Administrateur
    12 Truro Close
    SK7 2QN Bramhall
    Cheshire
    BritishPurchasing Director56727980001
    JONES, Carl Stephen
    11a Mayfield Road
    Timperley
    WA15 7TB Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    11a Mayfield Road
    Timperley
    WA15 7TB Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector68027540001
    LEE, Ivan Alan Peter
    150 Whalley Road
    Wilpshire
    BB1 9LJ Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    150 Whalley Road
    Wilpshire
    BB1 9LJ Blackburn
    Lancashire
    BritishCompany Director70165640002
    MAGUIRE, Martin
    No 7 Willoughby Court
    Shore Road
    Enniskillen County Fermanagh
    Northern Ireland
    Administrateur
    No 7 Willoughby Court
    Shore Road
    Enniskillen County Fermanagh
    Northern Ireland
    BritishFinancial Dir44992260001
    MASTALERZ, Paul
    268 Warwick Road
    Olton
    B92 7AE Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    268 Warwick Road
    Olton
    B92 7AE Solihull
    West Midlands
    BritishDirector94696580001
    MC DERMOTT, Shirley Sandra
    15 Childwall Crescent
    L16 7PG Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    15 Childwall Crescent
    L16 7PG Liverpool
    Merseyside
    BritishChartered Accountant8356530001
    MCCORMACK, Stephen Peter
    42 West View Long Tongue Scrog Lane
    Houses Hill
    HD5 0PA Huddersfield
    Administrateur
    42 West View Long Tongue Scrog Lane
    Houses Hill
    HD5 0PA Huddersfield
    BritishOperations Manager41612660001
    PARKER, John Francis
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director47002780001
    RADNOR, Michael Andrew
    16 Arlington Road
    SK8 1LW Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    16 Arlington Road
    SK8 1LW Cheadle
    Cheshire
    BritishCompany Director1125820001
    ROBINSON, Anthony Leake
    17 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3ER Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    17 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3ER Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector48323880001
    SHEPHERD, Robert Priestley
    Woodcliffe Horncliffe
    BB4 6JS Rossendale
    Lancashire
    Administrateur
    Woodcliffe Horncliffe
    BB4 6JS Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director8802110001
    STONE, Frederick Harold
    19 Garden Road
    WA16 6HT Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    19 Garden Road
    WA16 6HT Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector12296860001
    STOREY, Roger Christopher
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director1663050001

    HEG (NUMBER 3) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Own account assignment of life policies
    Créé le 27 avr. 2004
    Livré le 28 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policies and all amounts that are to be paid under it and any amount to be paid on cancellation of the policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property t/n MS199119.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By clause 2 of the memorandum, the company declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank; clause 4, if at any time any further or other securities shall be deposited or transferred by the company to the bank or its trustees or nominees;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 déc. 1997
    Livré le 20 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 20 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 sept. 1996
    Livré le 11 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1996
    Livré le 11 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 59 hill street liverpool t/no MS199119 with the goodwill of the business the proceeds of any insurance and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 mars 1995
    Livré le 10 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 1990
    Livré le 24 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings situate at 59 hill stret, liverpool, merseyside title no: ms 191199 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Kleinmont Benson Limited
    Transactions
    • 24 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 janv. 1986
    Livré le 07 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 19 janv. 1984
    Livré le 25 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Warehouse and bildings 59 hill street liverool L8 parts of which are under title no's ms 42099, p 26034, la 244701.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 1984Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0