PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00898129 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Inspired Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mars 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 008981290045, créée le 11 déc. 2025 | 36 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge 008981290044, créée le 17 oct. 2025 | 18 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge 008981290043, créée le 17 oct. 2025 | 19 pages | MR01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Marie-Anne Bousaba en tant que directeur le 08 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 30 juin 2024 | 42 pages | AA | ||
Nomination de Mr Benjamin Sze Ern Lim en tant qu'administrateur le 20 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Inscription de la charge 008981290042, créée le 22 oct. 2024 | 42 pages | MR01 | ||
Satisfaction de la charge 008981290041 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 juin 2023 | 37 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Philip Venner en tant que secrétaire le 31 janv. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Robert Daniel Stavely en tant que secrétaire le 01 févr. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes annuels établis au 30 juin 2022 | 39 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Thomas Lyle en tant que directeur le 11 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Inscription de la charge 008981290041, créée le 21 déc. 2022 | 34 pages | MR01 | ||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2021 au 30 juin 2022 | 1 pages | AA01 | ||
Nomination de Mr Thomas Lyle en tant qu'administrateur le 11 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Anthony Hartis en tant qu'administrateur le 11 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Japan Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 juil. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||
Nomination de Marie-Anne Bousaba en tant qu'administrateur le 28 févr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP à Inspired Easthampstead Road Bracknell RG12 1YQ | 1 pages | AD02 | ||
Qui sont les dirigeants de PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVELY, Robert Daniel | Secrétaire | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | 318854510001 | |||||||
| ASHLEY, Jonathan | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | United States | American | 200973020002 | |||||
| BOLTON, Stephen Geoffrey | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | England | British | 177906520001 | |||||
| BROMFIELD, Andrew John | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | England | British | 281073930001 | |||||
| HARTIS, Anthony | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | England | British | 295742640001 | |||||
| HAWKINS, David Charles | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | England | British | 188138870001 | |||||
| LIM, Benjamin Sze Ern | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | England | British | 330584820001 | |||||
| STAADECKER, Justin | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | England | British | 260948250001 | |||||
| MCMILLAN, Richard John | Secrétaire | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 68601920003 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secrétaire | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| VENNER, Philip | Secrétaire | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | 284836860001 | |||||||
| BARCOSEC LIMITED | Secrétaire | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| ANDERSON, Jonathan Trevor | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 120447610001 | |||||
| ASQUITH, Andrew Martin Granville | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 77784310001 | |||||
| BARNES, Donna | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 260132540001 | |||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOUSABA, Marie-Anne | Administrateur | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | United Kingdom | Australian | 293005440001 | |||||
| BOX, Sarah | Administrateur | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| BROWN, Alexander Stuart | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 151529770001 | |||||
| BROWN, Jonathan James | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 245881230001 | |||||
| BUCKLEY, Stanley William | Administrateur | Beech Lodge Sleepers Hill SO22 4NE Winchester Hampshire | British | 72199760001 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 2444200005 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 2444200002 | ||||||
| CARVER, Joanna Mary | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | British | 128679590001 | ||||||
| CLARK, Thomas Martin | Administrateur | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| COLLINS, Nathaniel James | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 165941950001 | |||||
| CROCKETT, Angela Judith Mary | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 107377680001 | ||||||
| EAST, Robert David | Administrateur | Second Floor Flat Old Frognal Court NW3 7DB 23 Frognal Lane London | British | 96562820001 | ||||||
| EMNEY, Paul | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 | England | British | 64165590003 | |||||
| FORAN, Martin John | Administrateur | Pear Tree Cottage The Avenue GU3 1JN Compton Surrey | British | 35965360001 | ||||||
| FOWLER, Brian Frederick | Administrateur | Sawyers 11 Theobald Drive Tilehurst RG31 6YA Reading Berkshire | British | 50845720001 | ||||||
| FRENCH, Richard Keith | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 81714250002 | ||||||
| GAMBLE, Shawn Elizabeth | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | Canadian | 122666820001 | ||||||
| GLOVER, Michael Richard | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 179780470001 | |||||
| GRIGG, Christopher Montague | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 | British | 120706940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PEAC BUSINESS FINANCE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peac Business Finance Holdings Limited | 30 juin 2021 | Easthampstead Road RG12 1YQ Bracknell Inspired England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Barclays Principal Investments Limited | 26 juin 2020 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Barclays Bank Plc | 06 avr. 2016 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0