CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00900529 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?
Adresse du siège social | Miller House Pontefract Road WF6 1RN Normanton Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 8 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Galliford Try Secretariat Services Limited le 18 janv. 2021 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Neil David Cocker en tant qu'administrateur le 30 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Cooper en tant que directeur le 30 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Galliford Try Secretariat Services Limited le 25 juil. 2017 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Cooper le 15 mai 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 août 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Thomas Jubb le 22 avr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2015 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 13 juil. 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLIFORD TRY SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 3 Frayswater Place Cowley UB8 2AD Uxbridge Blake House Middlesex United Kingdom |
| 167168750001 | ||||||||||
COCKER, Neil David | Administrateur | Rossett Close Northwich CW9 8WP Cheshire 5 United Kingdom | England | British | Company Director | 260158230001 | ||||||||
JUBB, Ian Thomas | Administrateur | Miller House Pontefract Road WF6 1RN Normanton Yorkshire | United Kingdom | British | Senior Management | 162269970002 | ||||||||
BYRNE, Patrick James | Secrétaire | 5 The Crofts Main Street Markfield LE67 9UW Leicester Leicestershire | British | 20831220001 | ||||||||||
DONALDSON, Euan James | Secrétaire | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | Secretary | 41273760002 | |||||||||
LAWSON, Gordon Kenneth | Secrétaire | 5 Trench Knowe EH10 7HL Edinburgh | British | Company Secretary | 145330001 | |||||||||
MACKINNON, Iain Lachlan | Secrétaire | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||||||
SMYTH, Pamela June | Secrétaire | Miller House Pontefract Road WF6 1RN Normanton Yorkshire | British | 65057960002 | ||||||||||
BROOME, Martin Stephen | Administrateur | 71 Pereira Road B17 9JA Birmingham | British | Commercial Manager | 42988770001 | |||||||||
BURROWS, David | Administrateur | 21 Beechings Close Countesthorpe LE8 5PA Leicester Leicestershire | British | Civil Engineer | 20831210001 | |||||||||
BYRNE, Patrick James | Administrateur | 5 The Crofts Main Street Markfield LE67 9UW Leicester Leicestershire | England | British | Accountant/Company Secretary | 20831220001 | ||||||||
CARSON, John Ridley Taylor | Administrateur | 11 Kirkliston Road EH30 9NZ South Queensferry West Lothian | Scotland | British | Civil Engineer | 144668150001 | ||||||||
CLANCY, Edward John | Administrateur | 104 Allenby Road UB1 2HJ Southall Middlesex | Irish | Chartered Accountant | 11312540001 | |||||||||
CLARKE, Robert Anthony | Administrateur | 6 The Paddock Sandy Loan EH31 2BW Gullane East Lothian | British | Civil Engineer | 3221280003 | |||||||||
COOPER, Martin | Administrateur | Miller House Pontefract Road WF6 1RN Normanton Yorkshire | Scotland | British | Chartered Accountant | 156200280002 | ||||||||
DRAYCOTT, Colin Charles, Dr | Administrateur | Cream Lodge Farm Paudy Lane Barrow On Soar LE12 8HX Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | Engineer | 20006120001 | ||||||||
EASTON, John Howard | Administrateur | 34 Main Street Great Glen LE8 9GG Leicester Leicestershire | British | Civil Engineer | 19983050001 | |||||||||
EVISON, John Anthony | Administrateur | 73 Rugby Road Cubbington CV32 7HY Leamington Spa Warwickshire | England | British | Construction Manager | 522880001 | ||||||||
GRUNDON, Graham Nicolas | Administrateur | The Old Barn Glebe Farm NN12 7NL Alderton North Hants | British | Quantity Surveyor | 38085860005 | |||||||||
HARDWICKE, Alan Grove | Administrateur | Tower House Main Street Swithland Leicestershire | British | Civil Engineer | 40460030001 | |||||||||
HODSDEN, Richard David | Administrateur | Miller House Pontefract Road WF6 1RN Normanton Yorkshire | England | British | Finance Director | 183337930001 | ||||||||
JONES, William Bankes | Administrateur | Russet Corner Middle Lane Netherbroughton LE14 3HD Melton Mowbray Leicestershire | United Kingdom | British | Contracts Manager | 20831190001 | ||||||||
MILLER, Keith Manson | Administrateur | Miller House Pontefract Road WF6 1RN Normanton Yorkshire | Scotland | British | Company Director | 546650002 | ||||||||
PALMER, Stephen | Administrateur | 11 The Maltings Blythe Worksop Nottingham | British | Civil Engineer | 20831200001 | |||||||||
RICHARDS, John Steel | Administrateur | Miller House Pontefract Road WF6 1RN Normanton Yorkshire | United Kingdom | British | Financial Director | 1318380002 | ||||||||
SCOTT, Graeme Ronald Crawford | Administrateur | 1 West Cointon House 40 Woodhall Road, Colinton EH13 0DU Edinburgh | British | Financial Director | 381310001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galliford Try Corporate Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Lochside View 17452 EH12 1LB Edinburgh 2 Edinburgh United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 09 juil. 1991 Livré le 23 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land at fresh vale ind. Est. Cinderford gloucestershire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 13 mai 1991 Livré le 24 mai 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge on all goodwill & uncalled capital & all patents patent applications etc. (see 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 07 févr. 1991 Livré le 11 févr. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £300,000 | |
Brèves mentions Land and buildings at forest vale industrial estate, cinderford, gloucestershire title no: gr 113815. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 09 juin 1989 Livré le 15 juin 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & buildings at charnwood road, shepshed, leicestershire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 29/10/88 | Créé le 24 juin 1988 Livré le 15 juil. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & buildings situate at old dalby in the county of leicester being part of O.S. no. 5400. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 20 févr. 1986 Livré le 25 févr. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the bank charlesland property development limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions F/H land on the south east of station road, cropston leicestershire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 15 avr. 1982 Livré le 20 avr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 09 juil. 1980 Livré le 14 juil. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land & premises being land at the back of 88 hawcliffe road mountsorrell leics. Together with all fixtures title no lt 98743. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 06 mars 1979 Livré le 13 mars 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H lands & premises being: 88, hawcliffe road, mountsorrel, leicestershire, together with all fixtures. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 06 mars 1979 Livré le 13 mars 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Cr éé le 23 nov. 1974 Livré le 09 déc. 1974 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 15 août 1973 Livré le 24 août 1973 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land north west at hawcliffe rd mountsorrel leics, together with all fixtures. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0