CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED

CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00900529
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED13 mars 196713 mars 1967

    Quels sont les derniers comptes de CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Galliford Try Secretariat Services Limited le 18 janv. 2021

    1 pagesCH04

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Neil David Cocker en tant qu'administrateur le 30 juin 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Cooper en tant que directeur le 30 juin 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Galliford Try Secretariat Services Limited le 25 juil. 2017

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Cooper le 15 mai 2017

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Thomas Jubb le 22 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 août 2015

    État du capital au 25 août 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 13 juil. 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Qui sont les dirigeants de CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALLIFORD TRY SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    3 Frayswater Place
    Cowley
    UB8 2AD Uxbridge
    Blake House
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Frayswater Place
    Cowley
    UB8 2AD Uxbridge
    Blake House
    Middlesex
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement07970508
    167168750001
    COCKER, Neil David
    Rossett Close
    Northwich
    CW9 8WP Cheshire
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Rossett Close
    Northwich
    CW9 8WP Cheshire
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director260158230001
    JUBB, Ian Thomas
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    Administrateur
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    United KingdomBritishSenior Management162269970002
    BYRNE, Patrick James
    5 The Crofts Main Street
    Markfield
    LE67 9UW Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    5 The Crofts Main Street
    Markfield
    LE67 9UW Leicester
    Leicestershire
    British20831220001
    DONALDSON, Euan James
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    BritishSecretary41273760002
    LAWSON, Gordon Kenneth
    5 Trench Knowe
    EH10 7HL Edinburgh
    Secrétaire
    5 Trench Knowe
    EH10 7HL Edinburgh
    BritishCompany Secretary145330001
    MACKINNON, Iain Lachlan
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    Secrétaire
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    British66282570001
    SMYTH, Pamela June
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    Secrétaire
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    British65057960002
    BROOME, Martin Stephen
    71 Pereira Road
    B17 9JA Birmingham
    Administrateur
    71 Pereira Road
    B17 9JA Birmingham
    BritishCommercial Manager42988770001
    BURROWS, David
    21 Beechings Close
    Countesthorpe
    LE8 5PA Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    21 Beechings Close
    Countesthorpe
    LE8 5PA Leicester
    Leicestershire
    BritishCivil Engineer20831210001
    BYRNE, Patrick James
    5 The Crofts Main Street
    Markfield
    LE67 9UW Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    5 The Crofts Main Street
    Markfield
    LE67 9UW Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishAccountant/Company Secretary20831220001
    CARSON, John Ridley Taylor
    11 Kirkliston Road
    EH30 9NZ South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    11 Kirkliston Road
    EH30 9NZ South Queensferry
    West Lothian
    ScotlandBritishCivil Engineer144668150001
    CLANCY, Edward John
    104 Allenby Road
    UB1 2HJ Southall
    Middlesex
    Administrateur
    104 Allenby Road
    UB1 2HJ Southall
    Middlesex
    IrishChartered Accountant11312540001
    CLARKE, Robert Anthony
    6 The Paddock
    Sandy Loan
    EH31 2BW Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    6 The Paddock
    Sandy Loan
    EH31 2BW Gullane
    East Lothian
    BritishCivil Engineer3221280003
    COOPER, Martin
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    Administrateur
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    ScotlandBritishChartered Accountant156200280002
    DRAYCOTT, Colin Charles, Dr
    Cream Lodge Farm Paudy Lane
    Barrow On Soar
    LE12 8HX Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    Cream Lodge Farm Paudy Lane
    Barrow On Soar
    LE12 8HX Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishEngineer20006120001
    EASTON, John Howard
    34 Main Street
    Great Glen
    LE8 9GG Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    34 Main Street
    Great Glen
    LE8 9GG Leicester
    Leicestershire
    BritishCivil Engineer19983050001
    EVISON, John Anthony
    73 Rugby Road
    Cubbington
    CV32 7HY Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    73 Rugby Road
    Cubbington
    CV32 7HY Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishConstruction Manager522880001
    GRUNDON, Graham Nicolas
    The Old Barn Glebe Farm
    NN12 7NL Alderton
    North Hants
    Administrateur
    The Old Barn Glebe Farm
    NN12 7NL Alderton
    North Hants
    BritishQuantity Surveyor38085860005
    HARDWICKE, Alan Grove
    Tower House
    Main Street
    Swithland
    Leicestershire
    Administrateur
    Tower House
    Main Street
    Swithland
    Leicestershire
    BritishCivil Engineer40460030001
    HODSDEN, Richard David
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    Administrateur
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director183337930001
    JONES, William Bankes
    Russet Corner
    Middle Lane Netherbroughton
    LE14 3HD Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Russet Corner
    Middle Lane Netherbroughton
    LE14 3HD Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritishContracts Manager20831190001
    MILLER, Keith Manson
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    Administrateur
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    ScotlandBritishCompany Director546650002
    PALMER, Stephen
    11 The Maltings
    Blythe
    Worksop
    Nottingham
    Administrateur
    11 The Maltings
    Blythe
    Worksop
    Nottingham
    BritishCivil Engineer20831200001
    RICHARDS, John Steel
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    Administrateur
    Miller House
    Pontefract Road
    WF6 1RN Normanton
    Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Director1318380002
    SCOTT, Graeme Ronald Crawford
    1 West Cointon House
    40 Woodhall Road, Colinton
    EH13 0DU Edinburgh
    Administrateur
    1 West Cointon House
    40 Woodhall Road, Colinton
    EH13 0DU Edinburgh
    BritishFinancial Director381310001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Galliford Try Corporate Holdings Limited
    Lochside View
    17452
    EH12 1LB Edinburgh
    2
    Edinburgh
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Lochside View
    17452
    EH12 1LB Edinburgh
    2
    Edinburgh
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueListed By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House Edinburgh
    Numéro d'enregistrementSc288228
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 09 juil. 1991
    Livré le 23 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at fresh vale ind. Est. Cinderford gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 13 mai 1991
    Livré le 24 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all goodwill & uncalled capital & all patents patent applications etc. (see 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 févr. 1991
    Livré le 11 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £300,000
    Brèves mentions
    Land and buildings at forest vale industrial estate, cinderford, gloucestershire title no: gr 113815.
    Personnes ayant droit
    • J. S. Bloor
    Transactions
    • 11 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 juin 1989
    Livré le 15 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings at charnwood road, shepshed, leicestershire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 29/10/88
    Créé le 24 juin 1988
    Livré le 15 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings situate at old dalby in the county of leicester being part of O.S. no. 5400.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 févr. 1986
    Livré le 25 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the bank charlesland property development limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    F/H land on the south east of station road, cropston leicestershire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 15 avr. 1982
    Livré le 20 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 juil. 1980
    Livré le 14 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises being land at the back of 88 hawcliffe road mountsorrell leics. Together with all fixtures title no lt 98743.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 mars 1979
    Livré le 13 mars 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands & premises being: 88, hawcliffe road, mountsorrel, leicestershire, together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1979Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 06 mars 1979
    Livré le 13 mars 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1979Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 23 nov. 1974
    Livré le 09 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 15 août 1973
    Livré le 24 août 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land north west at hawcliffe rd mountsorrel leics, together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1973Enregistrement d'une charge

    CHARLES GREGORY (CIVIL ENGINEERING) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juin 1997Date of completion or termination of CVA
    28 juil. 1992Date of meeting to approve CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Wilson
    1 Woodborough Road
    Nottingham
    NG1 7FG
    practitioner
    1 Woodborough Road
    Nottingham
    NG1 7FG

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0