CROFTON PALLETS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CROFTON PALLETS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00901037 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CROFTON PALLETS LIMITED ?
Adresse du siège social | The Gravel Pit Needham IP20 9LB Norfolk England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CROFTON PALLETS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour CROFTON PALLETS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 7 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Norman Robert Scott en tant que directeur le 31 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Norman Robert Scott en tant que secrétaire le 31 mai 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Alan Graham Milne en tant qu'administrateur le 31 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 7 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Shed a Atlantic Way Barry Vale of Glamorgan CF63 3RA Wales à The Gravel Pit Needham Norfolk IP20 9LB le 22 janv. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 7 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Tracy Jayne Trotter en tant que directeur le 02 avr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alan Gibson en tant que directeur le 02 avr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Alistair Wells en tant que directeur le 21 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de John Ballinger en tant que directeur le 21 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 11 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 5 pages | AA | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 |
Qui sont les dirigeants de CROFTON PALLETS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILNE, Alan Graham | Administrateur | Needham IP20 9LB Norfolk The Gravel Pit England | Scotland | British | Director | 230205760001 | ||||
DAVIDSON, Jean Freda | Secrétaire | 1 Sherlock Road CB3 0HR Cambridge Cambridgeshire | English | 5361230001 | ||||||
HYDE, Jennifer Georgeanne | Secrétaire | Fiddlers Easton PE28 0TY Huntingdon Cambridgeshire | British | 43414960001 | ||||||
SCOTT, Norman Robert | Secrétaire | Needham IP20 9LB Norfolk The Gravel Pit England | British | Company Director | 134405100001 | |||||
BALLINGER, John | Administrateur | Atlantic Way CF63 3RA Barry Shed A Vale Of Glamorgan Wales | England | British | Company Director | 137768840001 | ||||
DAVIDSON, Jean Freda | Administrateur | 1 Sherlock Road CB3 0HR Cambridge Cambridgeshire | English | Secretary | 5361230001 | |||||
DAVIDSON, Paul Joseph | Administrateur | 21 Hartington Grove CB1 4UA Cambridge Cambridgeshire | United Kingdom | British | Manager | 5361250002 | ||||
DAVIDSON, Ronald Charles | Administrateur | 1 Sherlock Road CB3 0HR Cambridge Cambridgeshire | English | Sales Manager | 23446000001 | |||||
GIBSON, Alan | Administrateur | Atlantic Way CF63 3RA Barry Shed A Vale Of Glamorgan Wales | Scotland | British | Company Director | 94552630001 | ||||
GILLIES, Gavin Charles | Administrateur | Glebe Road St Peters Hill Industrial Estate PE29 7DX Huntingdon Cambridgeshire | Scotland | British | Company Director | 118774800001 | ||||
HALL, Timothy Wakelin | Administrateur | 33 Corsbie Close IP33 3ST Bury St. Edmunds Suffolk | English | Manager | 21081720005 | |||||
NILES, John William | Administrateur | 250 St Nicholas Drive DN37 9RP Grimsby South Humberside | British | Company Director | 37736250001 | |||||
ROBERTS, James Stephen | Administrateur | 670 Galleywood Road CM2 8BY Chelmsford Essex | Gbr | British | Timber Purchasing | 55541360003 | ||||
SCOTT, John Carruthers | Administrateur | Glen Alba House Caledonian Crescent PH3 1NG Auchterarder Perthshire | Uk | British | Company Director | 142251800001 | ||||
SCOTT, Norman Robert | Administrateur | Needham IP20 9LB Norfolk The Gravel Pit England | Scotland | British | Company Director | 134405100001 | ||||
TAYLOR, Andrew Neil | Administrateur | Old Crown House 14 Reads Street Stretham CB6 3JT Ely Cambridgeshire | British | Sales Director | 37832310001 | |||||
TROTTER, Tracy Jayne | Administrateur | Atlantic Way CF63 3RA Barry Shed A Vale Of Glamorgan Wales | Scotland | British | Finance Director | 103585250002 | ||||
WATKINS, Paul Frederick | Administrateur | 30 De Freville Avenue CB4 1HS Cambridge Cambridgeshire | British | Sales Manager | 23446010002 | |||||
WELLS, Alistair | Administrateur | Atlantic Way CF63 3RA Barry Shed A Vale Of Glamorgan Wales | Scotland | British | Company Director | 94552160001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CROFTON PALLETS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Timber Limited | 01 nov. 2016 | Halbeath Interchange Business Park, Kingseat Road Halbeath KY11 8RY Dunfermline U7 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CROFTON PALLETS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 31 mars 2006 Livré le 11 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 11 août 2000 Livré le 19 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti £500,000 due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H property at glebe road st peters road industrial area huntingdon t/no CB142637. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 15 mars 2000 Livré le 16 mars 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a premises at glebe road st peters road industrial area huntingdon cambridgeshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 févr. 2000 Livré le 17 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H glebe road st peters road industrial area huntingdon cambs. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 févr. 2000 Livré le 11 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 06 mars 1998 Livré le 10 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The goods as described in the schedule to the form 395 together with all accessories and component parts and all improvements thereof with all books manuals data etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 23 oct. 1997 Livré le 25 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Pallet forming machinery and pallet nailing machinery all bearing serial no. 3434/97 and manufactured by coralli S.P.A. italy. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 12 avr. 1996 Livré le 30 avr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H-land on the north side of thorold street grimsby together with all buildings and fixtures thereon, floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment and assigns the goodwill of the business (if any) (see ch microfiche for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 25 juin 1993 Livré le 01 juil. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Glebe road, st. Peters hill industrial estate huntingdon cambridgeshire and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 04 mars 1983 Livré le 14 mars 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital with all buildings fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 20 oct. 1978 Livré le 27 oct. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital with all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0