CROFTON PALLETS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROFTON PALLETS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00901037
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROFTON PALLETS LIMITED ?

    • fabrication d'autres articles en bois; fabrication d'articles en liège, en paille et en matériaux de vannerie (16290) / Industries manufacturières

    Où se situe CROFTON PALLETS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Gravel Pit
    Needham
    IP20 9LB Norfolk
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CROFTON PALLETS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CROFTON INDUSTRIAL AIDS LIMITED 16 mars 196716 mars 1967

    Quels sont les derniers comptes de CROFTON PALLETS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour CROFTON PALLETS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Norman Robert Scott en tant que directeur le 31 mai 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Norman Robert Scott en tant que secrétaire le 31 mai 2023

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Alan Graham Milne en tant qu'administrateur le 31 mai 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Shed a Atlantic Way Barry Vale of Glamorgan CF63 3RA Wales à The Gravel Pit Needham Norfolk IP20 9LB le 22 janv. 2021

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tracy Jayne Trotter en tant que directeur le 02 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Gibson en tant que directeur le 02 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alistair Wells en tant que directeur le 21 mai 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Ballinger en tant que directeur le 21 mai 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Qui sont les dirigeants de CROFTON PALLETS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MILNE, Alan Graham
    Needham
    IP20 9LB Norfolk
    The Gravel Pit
    England
    Administrateur
    Needham
    IP20 9LB Norfolk
    The Gravel Pit
    England
    ScotlandBritishDirector230205760001
    DAVIDSON, Jean Freda
    1 Sherlock Road
    CB3 0HR Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    1 Sherlock Road
    CB3 0HR Cambridge
    Cambridgeshire
    English5361230001
    HYDE, Jennifer Georgeanne
    Fiddlers
    Easton
    PE28 0TY Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Fiddlers
    Easton
    PE28 0TY Huntingdon
    Cambridgeshire
    British43414960001
    SCOTT, Norman Robert
    Needham
    IP20 9LB Norfolk
    The Gravel Pit
    England
    Secrétaire
    Needham
    IP20 9LB Norfolk
    The Gravel Pit
    England
    BritishCompany Director134405100001
    BALLINGER, John
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    EnglandBritishCompany Director137768840001
    DAVIDSON, Jean Freda
    1 Sherlock Road
    CB3 0HR Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    1 Sherlock Road
    CB3 0HR Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglishSecretary5361230001
    DAVIDSON, Paul Joseph
    21 Hartington Grove
    CB1 4UA Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    21 Hartington Grove
    CB1 4UA Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishManager5361250002
    DAVIDSON, Ronald Charles
    1 Sherlock Road
    CB3 0HR Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    1 Sherlock Road
    CB3 0HR Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglishSales Manager23446000001
    GIBSON, Alan
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    ScotlandBritishCompany Director94552630001
    GILLIES, Gavin Charles
    Glebe Road
    St Peters Hill Industrial Estate
    PE29 7DX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Glebe Road
    St Peters Hill Industrial Estate
    PE29 7DX Huntingdon
    Cambridgeshire
    ScotlandBritishCompany Director118774800001
    HALL, Timothy Wakelin
    33 Corsbie Close
    IP33 3ST Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    33 Corsbie Close
    IP33 3ST Bury St. Edmunds
    Suffolk
    EnglishManager21081720005
    NILES, John William
    250 St Nicholas Drive
    DN37 9RP Grimsby
    South Humberside
    Administrateur
    250 St Nicholas Drive
    DN37 9RP Grimsby
    South Humberside
    BritishCompany Director37736250001
    ROBERTS, James Stephen
    670 Galleywood Road
    CM2 8BY Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    670 Galleywood Road
    CM2 8BY Chelmsford
    Essex
    GbrBritishTimber Purchasing55541360003
    SCOTT, John Carruthers
    Glen Alba House
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Glen Alba House
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Auchterarder
    Perthshire
    UkBritishCompany Director142251800001
    SCOTT, Norman Robert
    Needham
    IP20 9LB Norfolk
    The Gravel Pit
    England
    Administrateur
    Needham
    IP20 9LB Norfolk
    The Gravel Pit
    England
    ScotlandBritishCompany Director134405100001
    TAYLOR, Andrew Neil
    Old Crown House
    14 Reads Street Stretham
    CB6 3JT Ely
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Old Crown House
    14 Reads Street Stretham
    CB6 3JT Ely
    Cambridgeshire
    BritishSales Director37832310001
    TROTTER, Tracy Jayne
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    ScotlandBritishFinance Director103585250002
    WATKINS, Paul Frederick
    30 De Freville Avenue
    CB4 1HS Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    30 De Freville Avenue
    CB4 1HS Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishSales Manager23446010002
    WELLS, Alistair
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Atlantic Way
    CF63 3RA Barry
    Shed A
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    ScotlandBritishCompany Director94552160001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CROFTON PALLETS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Scott Timber Limited
    Halbeath Interchange Business Park, Kingseat Road
    Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    U7
    Scotland
    01 nov. 2016
    Halbeath Interchange Business Park, Kingseat Road
    Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    U7
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc105196
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CROFTON PALLETS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 11 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 11 août 2000
    Livré le 19 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £500,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property at glebe road st peters road industrial area huntingdon t/no CB142637. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 mars 2000
    Livré le 16 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a premises at glebe road st peters road industrial area huntingdon cambridgeshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 févr. 2000
    Livré le 17 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H glebe road st peters road industrial area huntingdon cambs.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 févr. 2000
    Livré le 11 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 mars 1998
    Livré le 10 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The goods as described in the schedule to the form 395 together with all accessories and component parts and all improvements thereof with all books manuals data etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 10 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 oct. 1997
    Livré le 25 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Pallet forming machinery and pallet nailing machinery all bearing serial no. 3434/97 and manufactured by coralli S.P.A. italy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 25 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 12 avr. 1996
    Livré le 30 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-land on the north side of thorold street grimsby together with all buildings and fixtures thereon, floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment and assigns the goodwill of the business (if any) (see ch microfiche for details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 juin 1993
    Livré le 01 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Glebe road, st. Peters hill industrial estate huntingdon cambridgeshire and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 04 mars 1983
    Livré le 14 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital with all buildings fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1983Enregistrement d'une charge
    • 29 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 20 oct. 1978
    Livré le 27 oct. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital with all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1978Enregistrement d'une charge
    • 29 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0