HITEK POWER LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HITEK POWER LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00908344 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HITEK POWER LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 10 Hawthorn Road BN17 7LT Littlehampton England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HITEK POWER LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HITEK POWER LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 01 juil. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour HITEK POWER LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 36 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 42 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Cindy Pitrat en tant que secrétaire le 17 mars 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mrs Elizabeth Karpinski Vonne en tant que secrétaire le 17 mars 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mrs Elizabeth Karpinski Vonne en tant qu'administrateur le 17 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Cindy Pitrat en tant que directeur le 17 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 42 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Ms Cindy Pitrat en tant que secrétaire le 26 avr. 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Kelly Neagle en tant qu'administrateur le 15 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Thomas O. Mcgimpsey en tant que directeur le 15 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Cindy Pitrat en tant qu'administrateur le 15 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 41 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Hitek Power Building, Hawthorn Road, Littlehampton West Sussex BN17 7LT à Unit 10 Hawthorn Road Littlehampton BN17 7LT le 06 sept. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes complets modifiés jusqu'au 31 déc. 2019 | 37 pages | AAMD | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019 | 38 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 38 pages | AA | ||
Modification des détails de Ascent Investment Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 juin 2018 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 38 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de HITEK POWER LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONNE, Elizabeth Karpinski | Secrétaire | Hawthorn Road BN17 7LT Littlehampton Unit 10 England | 307043270001 | |||||||
NEAGLE, Kelly | Administrateur | Hawthorn Road BN17 7LT Littlehampton Unit 10 England | United States | American | Finance | 295280750001 | ||||
VONNE, Elizabeth Karpinski | Administrateur | Hawthorn Road BN17 7LT Littlehampton Unit 10 England | United States | American | Evp, General Counsel | 307042660001 | ||||
ATKINSON, Richard | Secrétaire | 5 Lukins Drive CM6 1XQ Dunmow Essex | British | 60376890001 | ||||||
BALLARD, Thomas Henry | Secrétaire | Hitek Power Building, Hawthorn Road, Littlehampton BN17 7LT West Sussex | 161981400001 | |||||||
ELSTONE, Henry Claude | Secrétaire | Valley House Darrington WF8 3BT Pontefract West Yorkshire | British | 81771100001 | ||||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Secrétaire | Kings Road GU32 3QY Petersfield 16 Hampshire United Kingdom | British | 42841660001 | ||||||
LINTOTT, Sheila Margaret | Secrétaire | Lowenva 2a St Winifreds Road HG2 8LN Harrogate North Yorkshire | British | 579070001 | ||||||
PITRAT, Cindy | Secrétaire | Hawthorn Road BN17 7LT Littlehampton Unit 10 England | 295280760001 | |||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
AUSTIN, Carey Jean Julian | Administrateur | 31 Upper Brighton Road BN14 9HY Worthing West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 28291620001 | ||||
AUSTIN, Carey Jean Julian | Administrateur | 31 Upper Brighton Road BN14 9HY Worthing West Sussex | United Kingdom | British | Director Of Companies | 28291620001 | ||||
BACON, Nicholas Andrew William | Administrateur | Shaftesbury House Clover Hill Old Warwick Road, Lapworth B94 6JY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 159081540001 | ||||
BALLARD, Thomas Henry | Administrateur | 48 Downsway BN43 5GN Shoreham By Sea West Sussex | United Kingdom | British | Accountant | 127878310001 | ||||
BARNETT, Malcolm Rodney | Administrateur | 18 Morris Way West Chiltington RH20 2RX Pulborough West Sussex | British | Director Of Companies | 28768340001 | |||||
BELISARIO, Anthony Alfredo | Administrateur | 24 Coronation Road Prestbury GL52 3DA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Chief Executive | 19258750001 | ||||
BIRCH, Ian Gregory | Administrateur | 35 Bowleaze Coveway DT3 6PL Weymouth Seaspray Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58137370003 | ||||
CLIFFORD, Brian Graham | Administrateur | 23 Erringham Road BN43 5NQ Shoreham By Sea West Sussex | British | Accountant | 11693880001 | |||||
DOWDING, Keith Stuart | Administrateur | 12 Nursery View SN7 8SJ Faringdon Oxfordshire | British | Director | 58585950001 | |||||
ELSTONE, Henry Claude | Administrateur | Valley House Darrington WF8 3BT Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | Director Of Companies | 81771100001 | ||||
FISHER, Andrew Charles | Administrateur | 5 Esholt Avenue Guiseley LS20 8AX Leeds West Yorkshire | British | Finance Director | 41331580001 | |||||
HALL, Eric | Administrateur | Barton House River View LS23 6BA Boston Spa West Yorkshire | England | British | Director Of Companies | 9835660001 | ||||
HERRON, Danny Carl | Administrateur | Hitek Power Building, Hawthorn Road, Littlehampton BN17 7LT West Sussex | Usa | U.S. Citizen | Cfo And Executive Vp | 187697690001 | ||||
KIDD, Raymond | Administrateur | 3 Rosedale Pannal HG3 1LB Harrogate North Yorkshire | British | Director Of Companies | 11224840001 | |||||
LAMMING, Philip Andrew | Administrateur | 25 Leconfield Garth Follifoot HG3 1NF Harrogate North Yorkshire | British | Company Director | 29764990001 | |||||
LAMMING, Philip Andrew | Administrateur | 25 Leconfield Garth Follifoot HG3 1NF Harrogate North Yorkshire | British | Development Manager | 29764990001 | |||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Administrateur | Kings Road GU32 3QY Petersfield 16 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 42841660002 | ||||
LIGUORI, Thomas | Administrateur | 1625 Sharp Point Drive Fort Collins Advanced Energy Industries Inc. Colorado Usa | United States Of America | American | Chief Financial Officer | 201192010001 | ||||
MCGIMPSEY, Thomas O. | Administrateur | Hawthorn Road BN17 7LT Littlehampton Unit 10 England | United States | American | Executive Vp, Corp Development & General Counsel | 187280240001 | ||||
MCKENZIE, Ian Munro | Administrateur | 12 The Fairway Bar Hill CB3 8SR Cambridge Cambridgeshire | Australian | Company Director | 18803950001 | |||||
MULLEN, Kenneth John | Administrateur | Tonhil House Borrowby YO7 4QQ Thirsk North Yorkshire | United Kingdom | Scottish | Company Secretary | 146642810001 | ||||
PITRAT, Cindy | Administrateur | Hawthorn Road BN17 7LT Littlehampton Unit 10 England | United States | American | Attorney | 295280720001 | ||||
WARD, Peter Douglas | Administrateur | 90 Station Road Burley In Wharfedale LS29 7NS Ilkley West Yorkshire | English | Company Director | 48821190001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HITEK POWER LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Energy Industries Uk Ltd. | 06 avr. 2016 | Hawthorne Road BN17 7LT Littlehampton Hitek Power Building United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
HITEK POWER LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 12 déc. 2012 Livré le 14 déc. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company or ascent to the chargee and/or any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 juil. 2003 Livré le 24 juil. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 juil. 2003 Livré le 24 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 juin 2000 Livré le 06 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 juin 2000 Livré le 06 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder (as herein defined) pursuant to the guarantee (as herein defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 11 mars 1982 Livré le 19 mars 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book & other debts due owing or incurred to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 11 mars 1982 Livré le 19 mars 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land & premises being 6 eastings close worthing west sussex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Equitable charge by deposit of deeds | Créé le 05 mars 1980 Livré le 13 mars 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H lands & premises being bedford hall bedford row, worthing west sussex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Equitable charge by deposit of deeds | Créé le 05 mars 1980 Livré le 13 mars 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H lands & premises being 6 eastings close dominion way, worthing, west sussex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0