HITEK POWER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHITEK POWER LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00908344
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HITEK POWER LIMITED ?

    • fabrication de moteurs électriques, générateurs et transformateurs (27110) / Industries manufacturières
    • fabrication d'autres équipements électriques (27900) / Industries manufacturières

    Où se situe HITEK POWER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 10 Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HITEK POWER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WALLIS HIVOLT LIMITED22 sept. 198822 sept. 1988
    BONAR WALLIS HIVOLT LIMITED12 févr. 198812 févr. 1988
    BONAR WALLIS ELECTRONICS LIMITED12 mai 198612 mai 1986
    WALLIS ELECTRONICS LIMITED13 juin 196713 juin 1967

    Quels sont les derniers comptes de HITEK POWER LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HITEK POWER LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HITEK POWER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    36 pagesAA
    AD7Y6JPK

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XD5FB51C

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    42 pagesAA
    ACD9VPQZ

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC6QMB4I

    Cessation de la nomination de Cindy Pitrat en tant que secrétaire le 17 mars 2023

    1 pagesTM02
    XBZXXS83

    Nomination de Mrs Elizabeth Karpinski Vonne en tant que secrétaire le 17 mars 2023

    2 pagesAP03
    XBZVEIVU

    Nomination de Mrs Elizabeth Karpinski Vonne en tant qu'administrateur le 17 mars 2023

    2 pagesAP01
    XBZVEKOZ

    Cessation de la nomination de Cindy Pitrat en tant que directeur le 17 mars 2023

    1 pagesTM01
    XBZVEICB

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    42 pagesAA
    ABD2ZLH6

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB7MPELL

    Nomination de Ms Cindy Pitrat en tant que secrétaire le 26 avr. 2022

    2 pagesAP03
    XB2V02MP

    Nomination de Mr Kelly Neagle en tant qu'administrateur le 15 avr. 2022

    2 pagesAP01
    XB2V02FU

    Cessation de la nomination de Thomas O. Mcgimpsey en tant que directeur le 15 avr. 2022

    1 pagesTM01
    XB2V02JM

    Nomination de Ms Cindy Pitrat en tant qu'administrateur le 15 avr. 2022

    2 pagesAP01
    XB2V028Z

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    41 pagesAA
    AAEEIX1M

    Changement d'adresse du siège social de Hitek Power Building, Hawthorn Road, Littlehampton West Sussex BN17 7LT à Unit 10 Hawthorn Road Littlehampton BN17 7LT le 06 sept. 2021

    1 pagesAD01
    XACH34WZ

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA7W9A2W

    Comptes complets modifiés jusqu'au 31 déc. 2019

    37 pagesAAMD
    A9VKLQT7

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    38 pagesAA
    A9K5JUX6

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X9BLQ1LV

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    38 pagesAA
    A8DBXSEB

    Modification des détails de Ascent Investment Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 juin 2018

    2 pagesPSC05
    X88UD4GJ

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X88UD6E1

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04
    X7DBGCK8

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    38 pagesAA
    A7B5QMLN

    Qui sont les dirigeants de HITEK POWER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VONNE, Elizabeth Karpinski
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    Secrétaire
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    307043270001
    NEAGLE, Kelly
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    Administrateur
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    United StatesAmericanFinance295280750001
    VONNE, Elizabeth Karpinski
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    Administrateur
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    United StatesAmericanEvp, General Counsel307042660001
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Secrétaire
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    British60376890001
    BALLARD, Thomas Henry
    Hitek Power Building, Hawthorn
    Road, Littlehampton
    BN17 7LT West Sussex
    Secrétaire
    Hitek Power Building, Hawthorn
    Road, Littlehampton
    BN17 7LT West Sussex
    161981400001
    ELSTONE, Henry Claude
    Valley House
    Darrington
    WF8 3BT Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Valley House
    Darrington
    WF8 3BT Pontefract
    West Yorkshire
    British81771100001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    Kings Road
    GU32 3QY Petersfield
    16
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kings Road
    GU32 3QY Petersfield
    16
    Hampshire
    United Kingdom
    British42841660001
    LINTOTT, Sheila Margaret
    Lowenva
    2a St Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Lowenva
    2a St Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    British579070001
    PITRAT, Cindy
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    Secrétaire
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    295280760001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    AUSTIN, Carey Jean Julian
    31 Upper Brighton Road
    BN14 9HY Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    31 Upper Brighton Road
    BN14 9HY Worthing
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director28291620001
    AUSTIN, Carey Jean Julian
    31 Upper Brighton Road
    BN14 9HY Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    31 Upper Brighton Road
    BN14 9HY Worthing
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector Of Companies28291620001
    BACON, Nicholas Andrew William
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishVenture Capitalist159081540001
    BALLARD, Thomas Henry
    48 Downsway
    BN43 5GN Shoreham By Sea
    West Sussex
    Administrateur
    48 Downsway
    BN43 5GN Shoreham By Sea
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant127878310001
    BARNETT, Malcolm Rodney
    18 Morris Way
    West Chiltington
    RH20 2RX Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    18 Morris Way
    West Chiltington
    RH20 2RX Pulborough
    West Sussex
    BritishDirector Of Companies28768340001
    BELISARIO, Anthony Alfredo
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishChief Executive19258750001
    BIRCH, Ian Gregory
    35 Bowleaze Coveway
    DT3 6PL Weymouth
    Seaspray
    Dorset
    United Kingdom
    Administrateur
    35 Bowleaze Coveway
    DT3 6PL Weymouth
    Seaspray
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58137370003
    CLIFFORD, Brian Graham
    23 Erringham Road
    BN43 5NQ Shoreham By Sea
    West Sussex
    Administrateur
    23 Erringham Road
    BN43 5NQ Shoreham By Sea
    West Sussex
    BritishAccountant11693880001
    DOWDING, Keith Stuart
    12 Nursery View
    SN7 8SJ Faringdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    12 Nursery View
    SN7 8SJ Faringdon
    Oxfordshire
    BritishDirector58585950001
    ELSTONE, Henry Claude
    Valley House
    Darrington
    WF8 3BT Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Valley House
    Darrington
    WF8 3BT Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector Of Companies81771100001
    FISHER, Andrew Charles
    5 Esholt Avenue
    Guiseley
    LS20 8AX Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Esholt Avenue
    Guiseley
    LS20 8AX Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director41331580001
    HALL, Eric
    Barton House
    River View
    LS23 6BA Boston Spa
    West Yorkshire
    Administrateur
    Barton House
    River View
    LS23 6BA Boston Spa
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector Of Companies9835660001
    HERRON, Danny Carl
    Hitek Power Building, Hawthorn
    Road, Littlehampton
    BN17 7LT West Sussex
    Administrateur
    Hitek Power Building, Hawthorn
    Road, Littlehampton
    BN17 7LT West Sussex
    UsaU.S. CitizenCfo And Executive Vp187697690001
    KIDD, Raymond
    3 Rosedale
    Pannal
    HG3 1LB Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Rosedale
    Pannal
    HG3 1LB Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector Of Companies11224840001
    LAMMING, Philip Andrew
    25 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    25 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director29764990001
    LAMMING, Philip Andrew
    25 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    25 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDevelopment Manager29764990001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    Kings Road
    GU32 3QY Petersfield
    16
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Road
    GU32 3QY Petersfield
    16
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary42841660002
    LIGUORI, Thomas
    1625 Sharp Point Drive
    Fort Collins
    Advanced Energy Industries Inc.
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    1625 Sharp Point Drive
    Fort Collins
    Advanced Energy Industries Inc.
    Colorado
    Usa
    United States Of AmericaAmericanChief Financial Officer201192010001
    MCGIMPSEY, Thomas O.
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    Administrateur
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    United StatesAmericanExecutive Vp, Corp Development & General Counsel187280240001
    MCKENZIE, Ian Munro
    12 The Fairway
    Bar Hill
    CB3 8SR Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    12 The Fairway
    Bar Hill
    CB3 8SR Cambridge
    Cambridgeshire
    AustralianCompany Director18803950001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Administrateur
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottishCompany Secretary146642810001
    PITRAT, Cindy
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    Administrateur
    Hawthorn Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Unit 10
    England
    United StatesAmericanAttorney295280720001
    WARD, Peter Douglas
    90 Station Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7NS Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    90 Station Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7NS Ilkley
    West Yorkshire
    EnglishCompany Director48821190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HITEK POWER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Advanced Energy Industries Uk Ltd.
    Hawthorne Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Hitek Power Building
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Hawthorne Road
    BN17 7LT Littlehampton
    Hitek Power Building
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement02839147
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HITEK POWER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2012
    Livré le 14 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or ascent to the chargee and/or any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hv Investments Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 juil. 2003
    Livré le 24 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 juil. 2003
    Livré le 24 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The "Trustee")
    Transactions
    • 24 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 juin 2000
    Livré le 06 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 juin 2000
    Livré le 06 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder (as herein defined) pursuant to the guarantee (as herein defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The "Trustee")
    Transactions
    • 06 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 11 mars 1982
    Livré le 19 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book & other debts due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1982
    Livré le 19 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & premises being 6 eastings close worthing west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Equitable charge by deposit of deeds
    Créé le 05 mars 1980
    Livré le 13 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H lands & premises being bedford hall bedford row, worthing west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1980Enregistrement d'une charge
    Equitable charge by deposit of deeds
    Créé le 05 mars 1980
    Livré le 13 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H lands & premises being 6 eastings close dominion way, worthing, west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0