ICELAND FOODSTORES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ICELAND FOODSTORES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00917394 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ICELAND FOODSTORES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Second Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Flintshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ICELAND FOODSTORES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 24 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour ICELAND FOODSTORES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 24 mars 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 25 mars 2016 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Duncan Andrew Vaughan le 16 avr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 27 mars 2015 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 23 déc. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 mars 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jayne Katherine Burrell en tant que secrétaire le 12 déc. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Duncan Andrew Vaughan en tant que secrétaire le 12 déc. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Duncan Andrew Vaughan en tant qu'administrateur le 12 déc. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jayne Katherine Burrell en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 29 mars 2013 | 12 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 mars 2012 | 12 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ICELAND FOODSTORES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN, Duncan Andrew | Secrétaire | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | 193427820001 | |||||||
| DHALIWAL, Tarsem Singh | Administrateur | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | United Kingdom | British | 151680990001 | |||||
| VAUGHAN, Duncan Andrew | Administrateur | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | United Kingdom | British | 132416950002 | |||||
| BERRY, John Graham | Secrétaire | The Poplars Darland Lane Lavister Rossett LL12 0BA Wrexham | British | 10711650001 | ||||||
| BERRY, John Graham | Secrétaire | The Poplars Darland Lane Lavister Rossett LL12 0BA Wrexham | British | 10711650001 | ||||||
| BURRELL, Jayne Katherine | Secrétaire | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | 159123960001 | |||||||
| CHASE, Suzanne Gabrielle | Secrétaire | Linden Gardens Chiswick W4 2EW London 68 United Kingdom | British | 135246350001 | ||||||
| SIGURDSSON, Gunnar | Secrétaire | 4 Greenlink Walk Kew Riverside TW9 4AF Richmond Upon Thames London | Icelandic | 114179720001 | ||||||
| BERRY, John Graham | Administrateur | The Poplars Darland Lane Lavister Rossett LL12 0BA Wrexham | Wales | British | 10711650001 | |||||
| BOOKER, Paul | Administrateur | 3 Suffolk Close BH21 2TX Wimborne Dorset | British | 50732080001 | ||||||
| BROWN, David Charles | Administrateur | Portal Lodge Forest Road CW6 0HX Tarporley Cheshire | British | 39013930002 | ||||||
| BURRELL, Jayne Katherine | Administrateur | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | England | British | 167879930001 | |||||
| CHASE, Suzanne Gabrielle | Administrateur | Linden Gardens Chiswick W4 2EW London 68 United Kingdom | United Kingdom | British | 135246350001 | |||||
| CLARKE, Andrew James | Administrateur | Old Rectory High Street Whitwell S80 4RE Nottingham | United Kingdom | British | 141323810001 | |||||
| COUPE, Michael Andrew | Administrateur | Riverside The Terrace LS23 6AH Boston Spa West Yorkshire | British | 59022790001 | ||||||
| DHALIWAL, Tarsem Singh | Administrateur | 6 Cumbrae Drive Stanney Oaks CH65 9JX Ellesmere Port Cheshire | United Kingdom | British | 112657600001 | |||||
| EVANS, Dennis | Administrateur | 21 Bickerton Way CW9 8FZ Northwich Cheshire | British | 74051840001 | ||||||
| HARALDSSON, Palmi | Administrateur | Solvallargata 4 FOREIGN 101 Reykjavik Iceland | Iceland | Icelandic | 98086060001 | |||||
| HARRIS, Nicholas Edward | Administrateur | 10 Primrose Road Allerton L18 2HE Liverpool | British | 74483900001 | ||||||
| HOSKINS, William John | Administrateur | 3 Homewood Road AL1 4BE St. Albans Hertfordshire | British | 49295070002 | ||||||
| KNOX, Kevin Douglas | Administrateur | 3 Periwinkle Close Lindford GU35 0YQ Bordon Hampshire | British | 96370150001 | ||||||
| LEIGH, James Bernard | Administrateur | 22 Curzon Park North CH4 8AR Chester Cheshire | British | 76713530001 | ||||||
| LEIGH, James Bernard | Administrateur | 22 Curzon Park North CH4 8AR Chester Cheshire | British | 76713530001 | ||||||
| PRITCHARD, Andrew Simon | Administrateur | Deeside Industrial Park CH5 2NW Deeside Second Avenue Flintshire | United Kingdom | British | 42467790003 | |||||
| PRITCHARD, Andrew Simon | Administrateur | Kidnal Grange Kidnal SY14 7DJ Malpas Cheshire | United Kingdom | British | 42467790003 | |||||
| SIGURDSSON, Gunnar | Administrateur | 4 Greenlink Walk Kew Riverside TW9 4AF Richmond Upon Thames London | England | Icelandic | 114179720001 | |||||
| WALKER, Malcolm Conrad, Sir | Administrateur | Broxton Old Hall Broxton CH5 9EF Chester Cheshire | United Kingdom | British, | 161541770001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ICELAND FOODSTORES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Midco Limited | 06 avr. 2016 | Deeside Industrial Parl Deeside CH5 2NW Flintshire Second Avenue United Kingdom | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
ICELAND FOODSTORES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 05 avr. 2012 Livré le 13 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of accession | Créé le 11 avr. 2007 Livré le 26 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession | Créé le 31 mars 2006 Livré le 13 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| An accession deed | Créé le 23 août 2005 Livré le 01 sept. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security trustee and or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0