ICELAND FOODSTORES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéICELAND FOODSTORES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00917394
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ICELAND FOODSTORES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ICELAND FOODSTORES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ICELAND FOODSTORES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BEJAM PROPERTIES LIMITED03 sept. 198703 sept. 1987
    HOME TRADING POST LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    BEJAM PRODUCE LIMITED06 oct. 196706 oct. 1967

    Quels sont les derniers comptes de ICELAND FOODSTORES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au24 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour ICELAND FOODSTORES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 mars 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 25 mars 2016

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2016

    État du capital au 15 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Duncan Andrew Vaughan le 16 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 27 mars 2015

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 28 mars 2014

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jayne Katherine Burrell en tant que secrétaire le 12 déc. 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Duncan Andrew Vaughan en tant que secrétaire le 12 déc. 2014

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Duncan Andrew Vaughan en tant qu'administrateur le 12 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jayne Katherine Burrell en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juin 2014

    État du capital au 18 juin 2014

    • Capital: GBP 5,005,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 29 mars 2013

    12 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 mars 2012

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ICELAND FOODSTORES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAUGHAN, Duncan Andrew
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Secrétaire
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    193427820001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Administrateur
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    United KingdomBritish151680990001
    VAUGHAN, Duncan Andrew
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Administrateur
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    United KingdomBritish132416950002
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Secrétaire
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Secrétaire
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    BURRELL, Jayne Katherine
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Secrétaire
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    159123960001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Secrétaire
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    British135246350001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Secrétaire
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Icelandic114179720001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Administrateur
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    WalesBritish10711650001
    BOOKER, Paul
    3 Suffolk Close
    BH21 2TX Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    3 Suffolk Close
    BH21 2TX Wimborne
    Dorset
    British50732080001
    BROWN, David Charles
    Portal Lodge Forest Road
    CW6 0HX Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Portal Lodge Forest Road
    CW6 0HX Tarporley
    Cheshire
    British39013930002
    BURRELL, Jayne Katherine
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Administrateur
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish167879930001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Administrateur
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    CLARKE, Andrew James
    Old Rectory
    High Street Whitwell
    S80 4RE Nottingham
    Administrateur
    Old Rectory
    High Street Whitwell
    S80 4RE Nottingham
    United KingdomBritish141323810001
    COUPE, Michael Andrew
    Riverside The Terrace
    LS23 6AH Boston Spa
    West Yorkshire
    Administrateur
    Riverside The Terrace
    LS23 6AH Boston Spa
    West Yorkshire
    British59022790001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    Administrateur
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    United KingdomBritish112657600001
    EVANS, Dennis
    21 Bickerton Way
    CW9 8FZ Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    21 Bickerton Way
    CW9 8FZ Northwich
    Cheshire
    British74051840001
    HARALDSSON, Palmi
    Solvallargata 4
    FOREIGN 101 Reykjavik
    Iceland
    Administrateur
    Solvallargata 4
    FOREIGN 101 Reykjavik
    Iceland
    IcelandIcelandic98086060001
    HARRIS, Nicholas Edward
    10 Primrose Road
    Allerton
    L18 2HE Liverpool
    Administrateur
    10 Primrose Road
    Allerton
    L18 2HE Liverpool
    British74483900001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    KNOX, Kevin Douglas
    3 Periwinkle Close
    Lindford
    GU35 0YQ Bordon
    Hampshire
    Administrateur
    3 Periwinkle Close
    Lindford
    GU35 0YQ Bordon
    Hampshire
    British96370150001
    LEIGH, James Bernard
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    Administrateur
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    British76713530001
    LEIGH, James Bernard
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    Administrateur
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    British76713530001
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Administrateur
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    United KingdomBritish42467790003
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish42467790003
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Administrateur
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    WALKER, Malcolm Conrad, Sir
    Broxton Old Hall
    Broxton
    CH5 9EF Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Broxton Old Hall
    Broxton
    CH5 9EF Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish,161541770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ICELAND FOODSTORES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Iceland Midco Limited
    Deeside Industrial Parl
    Deeside
    CH5 2NW Flintshire
    Second Avenue
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Deeside Industrial Parl
    Deeside
    CH5 2NW Flintshire
    Second Avenue
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ICELAND FOODSTORES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 05 avr. 2012
    Livré le 13 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 13 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of accession
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 26 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 26 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 13 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Islands Hf (The Security Trustee)
    Transactions
    • 13 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An accession deed
    Créé le 23 août 2005
    Livré le 01 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Islands Hf (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0