LOGICAL COMMERCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOGICAL COMMERCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00919643
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOGICAL COMMERCE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LOGICAL COMMERCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LOGICAL COMMERCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DIAMOND PLATFORMS LIMITED08 nov. 199508 nov. 1995
    EXETER HIRE CENTRE LIMITED25 oct. 196725 oct. 1967

    Quels sont les derniers comptes de LOGICAL COMMERCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour LOGICAL COMMERCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Cessation de la nomination de Jerome Sarragozi en tant que secrétaire le 30 avr. 2019

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 25 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 janv. 2019

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jerome Sarragozi en tant que secrétaire le 28 juil. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Andrew Cole en tant que secrétaire le 28 juil. 2017

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Donald Thomas Kenny le 24 juil. 2017

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Nomination de Mr Thomas Anthony Murray en tant qu'administrateur le 01 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alan Stuart Merrell en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Jeremy Peter Fish en tant que directeur le 28 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Changement d'adresse du siège social de 145-157 st. John Street London EC1V 4PY à 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN le 31 août 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alan Stuart Merrell en tant que secrétaire le 07 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Richard Andrew Cole en tant que secrétaire le 07 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 déc. 2015

    État du capital au 22 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Qui sont les dirigeants de LOGICAL COMMERCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KENNY, Thomas Donald
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandIrish165677760002
    MURRAY, Thomas Anthony
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish198214500001
    COLE, Richard Andrew
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Secrétaire
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    207374600001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    Secrétaire
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    HILL, Percy James Hannaford
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    Secrétaire
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    British34368290001
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Secrétaire
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    British59110640004
    SARRAGOZI, Jerome
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    236102320001
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    Secrétaire
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    APPLETON, Kevin Andrew
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish67821450016
    BAKER, Austin Philip
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    British44426070001
    FISH, Jeremy Peter
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish160373640001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    Administrateur
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    GANSSER-POTTS, Michael David
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    Administrateur
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    EnglandBritish158445070001
    GESTETNER, Geoffrey Sigmund
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    Administrateur
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    British47136960001
    MCMEEKING, Robert John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish75448720003
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish59110640004
    PRICE, David Lawrence
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    Administrateur
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    British25187800003
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    Administrateur
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    TANNER, Cecilia Kathleen Bessie
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    Administrateur
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British24926770001
    TANNER, Charles Derek
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    Administrateur
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British79342340001
    TANNER, Dale Charles
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    Administrateur
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    British43117330002
    WRIGHT, Andrew John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish122845150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LOGICAL COMMERCE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Zooom Holdings (Uk) Limited
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    06 avr. 2016
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement4812536
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LOGICAL COMMERCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A security agreement
    Créé le 08 mars 2012
    Livré le 27 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 27 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 18 nov. 2009
    Livré le 27 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and/or Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 27 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 05 sept. 2008
    Livré le 20 sept. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The “Security Trustee”)
    Transactions
    • 20 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 mars 1999
    Livré le 20 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 juin 1991
    Livré le 19 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 nov. 1989
    Livré le 29 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87
    Créé le 23 janv. 1987
    Livré le 24 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 1981
    Livré le 25 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 27 fore street, exmouth, devon.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 1981
    Livré le 25 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 20 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 07 avr. 1981
    Livré le 09 avr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details).
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust LTD
    Transactions
    • 09 avr. 1981Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 08 juil. 1977
    Livré le 28 juil. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731.
    Personnes ayant droit
    • E.J.Allen.
    Transactions
    • 28 juil. 1977Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 24 août 1972
    Livré le 30 août 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc.
    Brèves mentions
    Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 1972Enregistrement d'une charge
    • 18 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 01 mai 1968
    Livré le 08 mai 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc.
    Brèves mentions
    Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1968Enregistrement d'une charge

    LOGICAL COMMERCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 janv. 2019Commencement of winding up
    06 déc. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0