LOGICAL COMMERCE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LOGICAL COMMERCE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00919643 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LOGICAL COMMERCE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LOGICAL COMMERCE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour LOGICAL COMMERCE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | LIQ13 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jerome Sarragozi en tant que secrétaire le 30 avr. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 25 janv. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jerome Sarragozi en tant que secrétaire le 28 juil. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Andrew Cole en tant que secrétaire le 28 juil. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Donald Thomas Kenny le 24 juil. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Anthony Murray en tant qu'administrateur le 01 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Stuart Merrell en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 13 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Peter Fish en tant que directeur le 28 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 145-157 st. John Street London EC1V 4PY à 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN le 31 août 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 17 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Stuart Merrell en tant que secrétaire le 07 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Richard Andrew Cole en tant que secrétaire le 07 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de LOGICAL COMMERCE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNY, Thomas Donald | Administrateur | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | Irish | 165677760002 | |||||
| MURRAY, Thomas Anthony | Administrateur | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | England | British | 198214500001 | |||||
| COLE, Richard Andrew | Secrétaire | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | 207374600001 | |||||||
| FRANKLIN, Karen Jane | Secrétaire | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | 24926760001 | ||||||
| HILL, Percy James Hannaford | Secrétaire | 65 Southfield Avenue TQ3 1LQ Paignton Devon | British | 34368290001 | ||||||
| MERRELL, Alan Stuart | Secrétaire | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | British | 59110640004 | ||||||
| SARRAGOZI, Jerome | Secrétaire | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | 236102320001 | |||||||
| SHIPMAN, David Cyril | Secrétaire | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | 77501360001 | ||||||
| APPLETON, Kevin Andrew | Administrateur | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | England | British | 67821450016 | |||||
| BAKER, Austin Philip | Administrateur | 4 Meadowcroft Drive Kingsteignton TQ12 3PB Newton Abbot Devon | British | 44426070001 | ||||||
| FISH, Jeremy Peter | Administrateur | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | British | 160373640001 | |||||
| FRANKLIN, Karen Jane | Administrateur | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | 24926760001 | ||||||
| GANSSER-POTTS, Michael David | Administrateur | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire | England | British | 158445070001 | |||||
| GESTETNER, Geoffrey Sigmund | Administrateur | Flat 5 160 Gloucester Terrace W2 6HR London | British | 47136960001 | ||||||
| MCMEEKING, Robert John | Administrateur | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 75448720003 | |||||
| MERRELL, Alan Stuart | Administrateur | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 59110640004 | |||||
| PRICE, David Lawrence | Administrateur | Brook Farm Luddington In Th Brook PE28 0HB Oundle Northamptonshire | British | 25187800003 | ||||||
| SHIPMAN, David Cyril | Administrateur | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | 77501360001 | ||||||
| TANNER, Cecilia Kathleen Bessie | Administrateur | Three Tors Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | 24926770001 | ||||||
| TANNER, Charles Derek | Administrateur | Three Tors 66 Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | 79342340001 | ||||||
| TANNER, Dale Charles | Administrateur | 5 Fair Isle Close Scotts Meadow Barton TQ2 7BT Torquay Devon | British | 43117330002 | ||||||
| WRIGHT, Andrew John | Administrateur | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 122845150001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LOGICAL COMMERCE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zooom Holdings (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
LOGICAL COMMERCE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Créé le 08 mars 2012 Livré le 27 mars 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 18 nov. 2009 Livré le 27 nov. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 sept. 2008 Livré le 20 sept. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 12 mars 1999 Livré le 20 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 18 juin 1991 Livré le 19 juin 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 nov. 1989 Livré le 29 nov. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87 | Créé le 23 janv. 1987 Livré le 24 janv. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 19 août 1981 Livré le 25 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 27 fore street, exmouth, devon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 19 août 1981 Livré le 25 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattels mortgage | Créé le 07 avr. 1981 Livré le 09 avr. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 08 juil. 1977 Livré le 28 juil. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Brèves mentions Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 24 août 1972 Livré le 30 août 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due etc. | |
Brèves mentions Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 01 mai 1968 Livré le 08 mai 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due etc. | |
Brèves mentions Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
LOGICAL COMMERCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0