PIPPA DEE PARTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPIPPA DEE PARTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00924601
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PIPPA DEE PARTIES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PIPPA DEE PARTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Church Bridge House
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PIPPA DEE PARTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 mars 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour PIPPA DEE PARTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Mr Michael Arnaouti en tant qu'administrateur le 17 déc. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael Arnaouti en tant que secrétaire le 17 déc. 2021

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Mark Ashcroft en tant que secrétaire le 16 déc. 2021

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Mark Ashcroft en tant que directeur le 16 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 mars 2021

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 mars 2020

    1 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip Binns Maudsley en tant que directeur le 26 mars 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 mars 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 mars 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Ashcroft le 02 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Binns Maudsley le 02 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stuart Murdoch Caldwell le 01 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Rosgill Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mars 2018

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 2 Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4th à Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE le 01 mars 2018

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Timothy John Kowalski en tant que directeur le 05 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mark Ashcroft en tant qu'administrateur le 06 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Stuart Murdoch Caldwell en tant qu'administrateur le 06 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PIPPA DEE PARTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARNAOUTI, Michael
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    290653820001
    ARNAOUTI, Michael
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Administrateur
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    EnglandBritish539040004
    CALDWELL, Stuart Murdoch
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Administrateur
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish229000880001
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165368920001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Secrétaire
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    British14333000007
    CANN, Geoffrey
    11 Malmesbury Avenue
    Midway
    DE11 7PS Swadlincote
    Derbyshire
    Secrétaire
    11 Malmesbury Avenue
    Midway
    DE11 7PS Swadlincote
    Derbyshire
    British12477370001
    HALE, Donald
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    British75316130001
    ASHCROFT, Mark
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Administrateur
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish113691350001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Administrateur
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United KingdomBritish14333000007
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish143093130001
    HALE, Donald
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    British75316130001
    JOHNSON, David Anthony
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    Administrateur
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    United KingdomBritish157156750001
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    Administrateur
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritish75327660001
    KING, Dennis
    13 Dower House Crescent
    TN4 0TT Southborough
    Kent
    Administrateur
    13 Dower House Crescent
    TN4 0TT Southborough
    Kent
    British55754500001
    KITE, Ronald
    Keston Hall Lane
    Doveridge
    DE6 5NQ Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Keston Hall Lane
    Doveridge
    DE6 5NQ Ashbourne
    Derbyshire
    British13131070001
    KOWALSKI, Timothy John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Administrateur
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    UkBritish153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Administrateur
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish15967010001
    MOUNTFORD, Ewart
    11 Ambleside Court
    CW12 4HZ Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    11 Ambleside Court
    CW12 4HZ Congleton
    Cheshire
    British13300230001
    SIDDLE, Roger William John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Administrateur
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    EnglandBritish46903210001
    WILLIAMS, Keith John
    12 The Hay Barn
    Walmley
    B76 1DE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    12 The Hay Barn
    Walmley
    B76 1DE Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish12477390001
    WOODS, Roger Slater
    229 Burton Road
    Branston
    DE14 3DR Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    229 Burton Road
    Branston
    DE14 3DR Burton On Trent
    Staffordshire
    British13300240001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PIPPA DEE PARTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01721195
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PIPPA DEE PARTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 20 mai 1991
    Livré le 05 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 25 nov. 1988
    Livré le 13 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 28 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 mars 1984
    Livré le 01 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1984Enregistrement d'une charge
    Further guarantee and debenture
    Créé le 04 juil. 1977
    Livré le 08 juil. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any at the other los named therein
    Brèves mentions
    All that property, undertaking & assets charged by the principal deed & further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1977Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 23 juil. 1976
    Livré le 16 août 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other los named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property, undertaking & asstes charged by the principal deed & further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1976Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 nov. 1973
    Livré le 14 nov. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the two other companies named therein
    Brèves mentions
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charges.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 1973Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0