SPEEDY HIRE PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPEEDY HIRE PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00927680
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPEEDY HIRE PLC ?

    • Location et location d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77390) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SPEEDY HIRE PLC ?

    Adresse du siège social
    Chase House
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton Le Willows
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPEEDY HIRE PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALLEN PLC31 mai 198931 mai 1989
    ALLEN HOLDINGS (UK) LIMITED20 juil. 198420 juil. 1984
    ALLEN BROTHERS (LANCASHIRE) LIMITED22 févr. 196822 févr. 1968

    Quels sont les derniers comptes de SPEEDY HIRE PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SPEEDY HIRE PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 août 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 sept. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au19 août 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SPEEDY HIRE PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Robert Barclay en tant que directeur le 04 sept. 2025

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Re: a general meeting of the company, other than an annual general meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice. 04/09/2025
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2025

    174 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 009276800032 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 009276800034 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 009276800033 en totalité

    4 pagesMR04

    Inscription de la charge 009276800035, créée le 24 avr. 2025

    23 pagesMR01

    Inscription de la charge 009276800036, créée le 24 avr. 2025

    59 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolutions

    Market purchases maximum number 46,183,735 minimum price which may be paid for each such maximum price is higher pf 105% 05/09/2024
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:

    • Capital: GBP 2,596,842.7
    2 pagesSH04

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2024

    170 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,597,073.9
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 oct. 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2023

    190 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    That a general meeting of the company, other than an annual general meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice. 07/09/2023
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Nomination de Mr Paul Adrian Rayner en tant qu'administrateur le 01 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Rachat d'actions propres.

    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,532,630.95
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 juin 2023Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Qui sont les dirigeants de SPEEDY HIRE PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUNT, Neil John
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    228193130001
    BARTLETT, Rhian Helen
    Chase House
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton Le Willows
    Merseyside
    Administrateur
    Chase House
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton Le Willows
    Merseyside
    United KingdomBritish238325500001
    DASANI, Shatish Damodar
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish132555670003
    EVANS, Daniel John
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish272760890001
    GARMAN, David Noel Christopher
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish220510180001
    KAVANAGH, Carol
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish283824030001
    RAYNER, Paul Adrian
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    SHEARER, David James Buchanan
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish214451420001
    BLAIR, James Edward
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    168697390001
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    British11806560001
    KONCAREVIC, Suzana
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    British139800190001
    MCGRATH, Michael Andrew
    Abbey Barn
    Macclesfield Road
    SK11 9AH Chelford
    Cheshire
    Secrétaire
    Abbey Barn
    Macclesfield Road
    SK11 9AH Chelford
    Cheshire
    British82005890002
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    RAWNSLEY, Patrick James
    Grove Avenue
    LS29 9PL Ilkley
    The Ghyll
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Grove Avenue
    LS29 9PL Ilkley
    The Ghyll
    West Yorkshire
    Other108571170002
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Secrétaire
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    ASTRAND, Jan Gunnar
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandSwedish76435330004
    ATKINSON, Peter Duncan
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish18525420002
    AVERILL, Michael Charles Edward
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish24913560002
    BARCLAY, Robert
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish124856170002
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish11806560001
    BUNN, James Richard
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish274171570001
    CONTRERAS, Robert Leonard
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish93499270002
    CORCORAN, Steven James
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish39358260003
    DAVIES, Nicholas William
    Hazel Way
    Linby
    NG15 8GS Nottingham
    17
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Hazel Way
    Linby
    NG15 8GS Nottingham
    17
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish44011700002
    DEE, Frank Rigby
    6 Grosvenor Crescent Mews
    SW1X 7EU London
    Administrateur
    6 Grosvenor Crescent Mews
    SW1X 7EU London
    EnglandBritish143265460001
    DOWN, Russell
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish253603400001
    FOX, Kenneth
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish15540580001
    GALLOWAY, David Allistair
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    Administrateur
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    EnglandBritish180591130001
    GODWIN, Charles Richard
    Greencroft
    Priest Lane
    LA11 6PT Cartmel
    Cumbria
    Administrateur
    Greencroft
    Priest Lane
    LA11 6PT Cartmel
    Cumbria
    EnglandEnglish3414100001
    GREENHALGH, Donald
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    Administrateur
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    British47084170002
    GREENOUGH, Michael Robert
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    Administrateur
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    British53010640001
    HILTON, Ian John
    120 Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    120 Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    British9601490002
    KRIGE, Lynette Gillian
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish90566820002
    MACPHERSON, Ishbel Jean Stewart
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish151546810001
    MASTERS, Christopher
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish162773310001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0