HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED

HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00928356
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL PLC19 oct. 199919 oct. 1999
    HILLS ELECTRICAL PLC11 mars 198811 mars 1988
    HILLS ELECTRICAL (MIDLANDS) LIMITED06 mars 196806 mars 1968

    Quels sont les derniers comptes de HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Daron Mullineaux le 03 mars 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Daron Mullineaux le 03 mars 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    18 pagesAA

    Nomination de Brian Dominic Sharma en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Elizabeth Tanner en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Brian Dominic Sharma en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Tanner en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 août 2013

    État du capital au 02 août 2013

    • Capital: GBP 255,000
    SH01

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    34 pagesMAR

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée

    1 pagesRR02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Elizabeth Anne Tanner en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Lawrence Donnelly en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Divers

    Re section 519
    1 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Adrian Pike en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Payne en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHARMA, Brian Dominic
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    180642490001
    HILLMAN, Christopher Michael
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    Ireland
    Administrateur
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    Ireland
    EnglandBritishAccountant17572470002
    MULLINEAUX, Daron
    Walton Road
    Cosham
    PO6 1UJ Portsmouth
    Sgn , Walton Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Walton Road
    Cosham
    PO6 1UJ Portsmouth
    Sgn , Walton Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperation Director104269470002
    SHARMA, Brian Dominic
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor180444150001
    ALLEESON, Anthony James
    The Folly, Chapel Lane
    Lower Rowney Green
    B48 7QJ Alvechurch
    West Midlands
    Secrétaire
    The Folly, Chapel Lane
    Lower Rowney Green
    B48 7QJ Alvechurch
    West Midlands
    BritishCompany Director89390720001
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Secrétaire
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    BritishSolicitor62794440002
    HILL, David Benjamin
    126 Longwood Road
    Aldridge
    WS9 0TD Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    126 Longwood Road
    Aldridge
    WS9 0TD Walsall
    West Midlands
    British9362690001
    TANNER, Elizabeth Anne
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    164887410001
    ALLEESON, Anthony James
    The Folly, Chapel Lane
    Lower Rowney Green
    B48 7QJ Alvechurch
    West Midlands
    Administrateur
    The Folly, Chapel Lane
    Lower Rowney Green
    B48 7QJ Alvechurch
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director89390720001
    BELCHER, Jeremy David
    71 Ferndale Road
    WS13 7DL Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    71 Ferndale Road
    WS13 7DL Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director91943220002
    BIGLAND, Philip John
    57 Spinney Hill
    DE73 1LX Melbourne
    Dorset
    Administrateur
    57 Spinney Hill
    DE73 1LX Melbourne
    Dorset
    BritishCompany Director103015290001
    BIRD, John Henry
    Malvern View
    Pattingham Road Perton Ridge
    WV6 7HD Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    Malvern View
    Pattingham Road Perton Ridge
    WV6 7HD Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishEngineer102876220001
    CHAFFER, Douglas Andrew
    Becketts Green Bank Road
    Aldington
    TN25 7DF Ashford
    Kent
    Administrateur
    Becketts Green Bank Road
    Aldington
    TN25 7DF Ashford
    Kent
    BritishElectrical Engineer47221240002
    GURNEY, David John
    24 Madley Close
    Rubery
    B45 9XA Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    24 Madley Close
    Rubery
    B45 9XA Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant91943060001
    HILL, Benjamin
    Hilranton
    Holdeford Lane
    ST18 0XP Tixall Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    Hilranton
    Holdeford Lane
    ST18 0XP Tixall Stafford
    Staffordshire
    BritishElectrical Engineer9362710001
    HILL, David Benjamin
    126 Longwood Road
    Aldridge
    WS9 0TD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    126 Longwood Road
    Aldridge
    WS9 0TD Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director9362690001
    HILL, Phyllis
    Hilranton
    Holdeford Lane
    ST18 0XP Tixall Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    Hilranton
    Holdeford Lane
    ST18 0XP Tixall Stafford
    Staffordshire
    BritishNurse9362720001
    HUTCHINSON, Eoin
    62 Hawkwood Crescent
    WR10 Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    62 Hawkwood Crescent
    WR10 Pershore
    Worcestershire
    BritishElectrical Engineer24104700001
    MEAD, Richard Barwick
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishConsultant44255220002
    MOLNAR, Edward Louis
    Courtmoor Avenue
    GU52 7UE Fleet
    19
    Hampshire
    Administrateur
    Courtmoor Avenue
    GU52 7UE Fleet
    19
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director70663270001
    PAYNE, Timothy
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    UkBritishCompany Director97917450002
    PIKE, Adrian John
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director161186320001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Administrateur
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritishSolicitor43632680001
    SHORE, John Wilson
    26 Thorney Road
    Streetly
    B74 3HT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    26 Thorney Road
    Streetly
    B74 3HT Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishElectrical Engineer47221230001
    SMOLARZ, Richard
    23 Derwent Avenue
    Kingston Vale
    SW15 3RA London
    Administrateur
    23 Derwent Avenue
    Kingston Vale
    SW15 3RA London
    BritishCompany Director121440360001
    TANNER, Elizabeth Anne
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishBarrister100488700002
    WAINWRIGHT, Philip
    Cross Barn
    Dove Street Ellastone
    DE6 2GY Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Cross Barn
    Dove Street Ellastone
    DE6 2GY Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director106471770001
    WRIGHT, Antony Jonathan
    39 Bluebell Lane
    Great Wryley
    WS6 6HG Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    39 Bluebell Lane
    Great Wryley
    WS6 6HG Walsall
    West Midlands
    BritishElectrical Engineer45760140001

    HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 juin 2007
    Livré le 03 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 août 2003
    Livré le 02 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 30 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £22,496.90 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All right,title and interest in and to all sums payable under the insurances (see doc ref M266C for full details).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 30 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 15 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,926.12 due from the co to the chargee, under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All its right title & interest in and to all sums payable under the insurance (for full details see from 395).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 15 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A credit agreement
    Créé le 24 mai 1990
    Livré le 07 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Right title & interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 07 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 sept. 1987
    Livré le 10 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at green lane walsall.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 02 sept. 1987
    Livré le 10 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts. Uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 26 juil. 1978
    Livré le 01 août 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands hereditaments & premises being land situate on the north side of leamore lane walsall, west midlands, title no sf 96658 with all fixtures whatsoever.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 1978Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0