HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00928356 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?
Adresse du siège social | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Daron Mullineaux le 03 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Daron Mullineaux le 03 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2013 | 18 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Brian Dominic Sharma en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Elizabeth Tanner en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Brian Dominic Sharma en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Elizabeth Tanner en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée | 1 pages | CERT10 | ||||||||||
Réenregistrement des statuts | 34 pages | MAR | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée | 1 pages | RR02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Elizabeth Anne Tanner en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lawrence Donnelly en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Divers Re section 519 | 1 pages | MISC | ||||||||||
Cessation de la nomination de Adrian Pike en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Payne en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARMA, Brian Dominic | Secrétaire | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 180642490001 | |||||||
HILLMAN, Christopher Michael | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire Ireland | England | British | Accountant | 17572470002 | ||||
MULLINEAUX, Daron | Administrateur | Walton Road Cosham PO6 1UJ Portsmouth Sgn , Walton Park Hampshire United Kingdom | England | British | Operation Director | 104269470002 | ||||
SHARMA, Brian Dominic | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | Solicitor | 180444150001 | ||||
ALLEESON, Anthony James | Secrétaire | The Folly, Chapel Lane Lower Rowney Green B48 7QJ Alvechurch West Midlands | British | Company Director | 89390720001 | |||||
DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | Solicitor | 62794440002 | |||||
HILL, David Benjamin | Secrétaire | 126 Longwood Road Aldridge WS9 0TD Walsall West Midlands | British | 9362690001 | ||||||
TANNER, Elizabeth Anne | Secrétaire | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 164887410001 | |||||||
ALLEESON, Anthony James | Administrateur | The Folly, Chapel Lane Lower Rowney Green B48 7QJ Alvechurch West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 89390720001 | ||||
BELCHER, Jeremy David | Administrateur | 71 Ferndale Road WS13 7DL Lichfield Staffordshire | England | British | Company Director | 91943220002 | ||||
BIGLAND, Philip John | Administrateur | 57 Spinney Hill DE73 1LX Melbourne Dorset | British | Company Director | 103015290001 | |||||
BIRD, John Henry | Administrateur | Malvern View Pattingham Road Perton Ridge WV6 7HD Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Engineer | 102876220001 | ||||
CHAFFER, Douglas Andrew | Administrateur | Becketts Green Bank Road Aldington TN25 7DF Ashford Kent | British | Electrical Engineer | 47221240002 | |||||
GURNEY, David John | Administrateur | 24 Madley Close Rubery B45 9XA Birmingham West Midlands | England | British | Accountant | 91943060001 | ||||
HILL, Benjamin | Administrateur | Hilranton Holdeford Lane ST18 0XP Tixall Stafford Staffordshire | British | Electrical Engineer | 9362710001 | |||||
HILL, David Benjamin | Administrateur | 126 Longwood Road Aldridge WS9 0TD Walsall West Midlands | England | British | Company Director | 9362690001 | ||||
HILL, Phyllis | Administrateur | Hilranton Holdeford Lane ST18 0XP Tixall Stafford Staffordshire | British | Nurse | 9362720001 | |||||
HUTCHINSON, Eoin | Administrateur | 62 Hawkwood Crescent WR10 Pershore Worcestershire | British | Electrical Engineer | 24104700001 | |||||
MEAD, Richard Barwick | Administrateur | Clayfurlong House Kemble GL7 6BS Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | Consultant | 44255220002 | ||||
MOLNAR, Edward Louis | Administrateur | Courtmoor Avenue GU52 7UE Fleet 19 Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 70663270001 | ||||
PAYNE, Timothy | Administrateur | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | Uk | British | Company Director | 97917450002 | ||||
PIKE, Adrian John | Administrateur | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | England | British | Company Director | 161186320001 | ||||
SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Administrateur | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | Solicitor | 43632680001 | ||||
SHORE, John Wilson | Administrateur | 26 Thorney Road Streetly B74 3HT Sutton Coldfield West Midlands | British | Electrical Engineer | 47221230001 | |||||
SMOLARZ, Richard | Administrateur | 23 Derwent Avenue Kingston Vale SW15 3RA London | British | Company Director | 121440360001 | |||||
TANNER, Elizabeth Anne | Administrateur | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | England | British | Barrister | 100488700002 | ||||
WAINWRIGHT, Philip | Administrateur | Cross Barn Dove Street Ellastone DE6 2GY Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 106471770001 | |||||
WRIGHT, Antony Jonathan | Administrateur | 39 Bluebell Lane Great Wryley WS6 6HG Walsall West Midlands | British | Electrical Engineer | 45760140001 |
HILLS ELECTRICAL & MECHANICAL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 25 juin 2007 Livré le 03 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 28 août 2003 Livré le 02 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement | Créé le 21 mai 1992 Livré le 30 mai 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £22,496.90 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Brèves mentions All right,title and interest in and to all sums payable under the insurances (see doc ref M266C for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement | Créé le 07 mai 1991 Livré le 15 mai 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £17,926.12 due from the co to the chargee, under the terms of the charge | |
Brèves mentions All its right title & interest in and to all sums payable under the insurance (for full details see from 395). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A credit agreement | Créé le 24 mai 1990 Livré le 07 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions Right title & interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 02 sept. 1987 Livré le 10 sept. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land at green lane walsall. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 02 sept. 1987 Livré le 10 sept. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts. Uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 26 juil. 1978 Livré le 01 août 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H lands hereditaments & premises being land situate on the north side of leamore lane walsall, west midlands, title no sf 96658 with all fixtures whatsoever. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0