BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED

BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 00947511
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED ?

    • (5139) /

    Où se situe BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Po Box 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RICHMOND RENTALS LIMITED06 févr. 196906 févr. 1969

    Quels sont les derniers comptes de BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    CERTIPS

    Divers

    Convert to I & ps
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to I & ps 17/06/2011
    RES13

    Cessation de la nomination de Stephen Humes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2010

    État du capital au 09 sept. 2010

    • Capital: GBP 6,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    6 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 11 janv. 2010 au 02 janv. 2010

    1 pagesAA01

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Katherine Eldridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 10 janv. 2009

    18 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    Comptes annuels établis au 12 janv. 2008

    21 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 13 janv. 2007

    21 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 14 janv. 2006

    20 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    PO BOX 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    Secrétaire
    PO BOX 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    150560510001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishGeneral Manager - Food99724260001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    STEPHENSON, William Henry
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    British1720730001
    CWS (NO 2) LIMITED
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Secrétaire
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    36139760001
    DOHERTY, Frank Edgar
    Thrumpton House
    NG11 0AX Thrumpton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Thrumpton House
    NG11 0AX Thrumpton
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishChief Executive1720740001
    HEWITT, Paul William
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishDeputy Chief Executive163759450001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    JACKSON, David James
    82 Horseshoe Lane
    Bromley Cross
    BL7 9RR Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    82 Horseshoe Lane
    Bromley Cross
    BL7 9RR Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishFinancial Controller102840001
    KELLY, Derek Kevin
    London Spring Farm
    Soyland Ripponden
    HX6 4LS Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    London Spring Farm
    Soyland Ripponden
    HX6 4LS Halifax
    West Yorkshire
    BritishDivisional Accountant29696920001
    MAXWELL, Alan
    Perrins Barn
    Woods Green
    TN5 6QS Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Perrins Barn
    Woods Green
    TN5 6QS Wadhurst
    East Sussex
    BritishChief Officer26297780001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishRetailer106997230001
    STEPHENSON, William Henry
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishDirector & Coy Secretary1720730001
    CWS (NO 1) LIMITED
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Administrateur
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    36139970001

    BLENHEIM DISTRIBUTION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 15 oct. 1990
    Livré le 16 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 15 oct. 1990
    Livré le 16 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and premises situate at freeston drive, blenheim ind. Est., Bulwell nottingham all/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 juin 1990
    Livré le 26 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined therein) pursuant to a composite guarantee and mortgage debenture dated 31-5-90
    Brèves mentions
    L/H property k/a land & buildings at freestone drive, blenheim ind est, bulwell nottingham title no nt 236784 together with all buildings & fixtures (including trade & tenants fixtures) thereon.
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 26 juin 1990Enregistrement d'une charge
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 31 mai 1990
    Livré le 07 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Bank Public Limited Companyas Security Trustee for the Banks
    Transactions
    • 07 juin 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0