BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED

BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00948809
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Woolsington House
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    D.F.W. GOLDING (ANGLIA) LIMITED 20 juin 198620 juin 1986
    D.F.W. GOLDING LIMITED27 févr. 196927 févr. 1969

    Quels sont les derniers comptes de BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Seaton Burn House Dudley Lane Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6BE à Woolsington House Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BF le 25 août 2020

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Jayne Patricia Powell en tant que secrétaire le 30 avr. 2020

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Simon Scougall en tant que secrétaire le 30 avr. 2020

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 14 mars 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 janv. 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2019

    2 pagesAA

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 20 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCOUGALL, Simon
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Secrétaire
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    269299850001
    ADEY, Keith Derek
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Administrateur
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    United KingdomBritish166483540002
    HONEYMAN, Jason Michael
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Administrateur
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    EnglandBritish237437010001
    POWELL, Jayne Patricia
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    253468180001
    SCOUGALL, Simon
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    205018840001
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British62440010001
    WRIGHTSON, Gilbert Kevin
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British51453140002
    AYRES, Edward Francis
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    Administrateur
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    EnglandBritish83605650003
    BELL, Ashley Kenrick
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British4620460001
    BELL, Kenneth
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    British549680001
    DAWE, Howard Carlton
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    Administrateur
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    United KingdomBritish37782520006
    HADDRELL, Keith Sydney
    Avon
    Peldon Road Abberton
    CO5 7PB Colchester
    Essex
    Administrateur
    Avon
    Peldon Road Abberton
    CO5 7PB Colchester
    Essex
    EnglandBritish108901110001
    LEITCH, Alistair Mcleod
    The Red House
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    The Red House
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish83848200001
    ROBSON, Alan George
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    British3844820005
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish62440010001
    WARBURTON, Derek
    Brooklands Tye
    7 John Raven Court, Feering
    CO5 9NB Colchester
    Essex
    Administrateur
    Brooklands Tye
    7 John Raven Court, Feering
    CO5 9NB Colchester
    Essex
    British101798130002
    WATSON, John Knowlton
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish72766290002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    D.F.W. Golding Limited
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    06 avr. 2016
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Companies Registry
    Numéro d'enregistrement1991200
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 27 avr. 1987
    Livré le 08 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Millfield house, barnston in the county of essex.
    Personnes ayant droit
    • Bellway (Builders) Limited
    Transactions
    • 08 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 06 févr. 1987
    Livré le 12 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £150,000.
    Brèves mentions
    The dwellinghouse and garden k/a millfield house barnston great dunmow essex together with the garden thereof.
    Personnes ayant droit
    • Roger James Barnard.
    Transactions
    • 12 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 06 févr. 1987
    Livré le 10 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and premises k/as millfield house chelmsford road and barnston road great dunmow essex. Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • Tcb Limited
    Transactions
    • 10 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1986
    Livré le 09 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & premises at the rear of 215/217 (odd nos. Only). High street kelvedon. Essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 25 nov. 1986
    Livré le 26 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £107,000.
    Brèves mentions
    Land comprising part of the old omnibus depot at high street, kelvedon essex.
    Personnes ayant droit
    • Douglas Frederick Wyn Golding.
    Transactions
    • 26 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 29 oct. 1986
    Livré le 18 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land k/a site b, phase vi south woodham ferrers town centre title no:- ex 168296.
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transactions
    • 18 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 30 mai 1986
    Livré le 06 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or D.F.W. golding (western) limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Floating charge all of the company's undertaking & goodwill & its property assets & rights (see doc 50 for further details).
    Personnes ayant droit
    • Tcb Limited
    Transactions
    • 06 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 27 mars 1986
    Livré le 09 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Site at wickford avenue, pitsea, basildon, essex.
    Personnes ayant droit
    • First National Finance Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 09 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 01 nov. 1985
    Livré le 08 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land at laindon, basildon in the county of essex forming part of langdon hills north 4TH housing areas (the badgers estate - phase 111).
    Personnes ayant droit
    • First National Finance Corporation PLC.
    Transactions
    • 08 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 1985
    Livré le 03 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate to the east of betterton road and lying to the south of frederick road, rainham, essex t/no s egl 23215, egl 27605, egl 27605, egl 78804, egl 140869 & egl 145140 together with unregistered land &. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge on building agreement
    Créé le 08 mai 1985
    Livré le 15 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Water tower estate, mill lane, kelvedon hatch, brentwood essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 1984
    Livré le 26 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H - land fronting the chase, great totham, essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge on building agreement and licence
    Créé le 31 oct. 1983
    Livré le 08 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the interest of the company in and all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company (see doc M42 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 juil. 1983
    Livré le 11 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at the chase, great totham, essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 08 mars 1983
    Livré le 17 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the interest of the company in, and all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement and licence dated 20 dec 1982 (for full details see doc no M40).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1983Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 28 févr. 1983
    Livré le 04 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a all that piece or parcel of land at one time part of warrens farm situate in the parish of feering essex and k/a village field or death croft.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 10 déc. 1982
    Livré le 16 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1982
    Livré le 20 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at the chase, kelvedon, essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 1982
    Livré le 24 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at 41/5 bridge street witham essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 10 déc. 1981
    Livré le 17 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the building agreement dated 9.4.81
    Brèves mentions
    F/H land at east street great coggeshall essex described in a conveyance dated 14.5.81. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 17 août 1981
    Livré le 04 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the building agreement dated 9.4.81
    Brèves mentions
    All the interest of the company in a building agreement dated 9.4.81 between basildon development corporation and the company relating to heathleigh, north housing area langdon hills basildon essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignments
    Créé le 17 août 1981
    Livré le 04 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the building agreement dated 9.4.81
    Brèves mentions
    All monies due or owing to the company under the building agreement dated 9.4.81 between the company and basildon development corporation and D.F.W. golding LTD relating to heathleigh north housing area langdon hills basildon essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 janv. 1981
    Livré le 22 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land adjoining oak cottage chelmsford road, felstead, essex.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 07 févr. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at albert road, witham, essex as comprised in a conveyance dated 2/10/78.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 29 déc. 1979
    Livré le 17 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as coach and bus depot, high street, kelvedon, as described in a conveyance dated 19-12-79.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 1980Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0