WIDNEY UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWIDNEY UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00950388
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WIDNEY UK LIMITED ?

    • (3663) /

    Où se situe WIDNEY UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO STOY HAYWARD LLP
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WIDNEY UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WIDNEY ENCLOSURES LIMITED27 mars 198527 mars 1985
    WIDNEY PROPERTIES LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    TRANSTRIP LIMITED20 mars 196920 mars 1969

    Quels sont les derniers comptes de WIDNEY UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2007

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WIDNEY UK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WIDNEY UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 oct. 2014

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    4 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2014

    9 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:re court order replacement of liq
    9 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 oct. 2013

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2013

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 oct. 2012

    11 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2012

    11 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 oct. 2011

    12 pages4.68

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    6 pages4.40

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    6 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2011

    11 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 oct. 2010

    13 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 sept. 2009

    8 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    8 pages2.34B

    Résultat de la réunion des créanciers

    31 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    35 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    19 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de WIDNEY UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DEVERS, Matthew Ian
    10 Woodstock Close
    Wordsley
    DY8 5HZ Stourbridge
    West Midlands
    Secrétaire
    10 Woodstock Close
    Wordsley
    DY8 5HZ Stourbridge
    West Midlands
    BritishAccountant108290890001
    BROOKES, Jason Edward
    29 Balaams Wood Drive
    B31 5HF Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    29 Balaams Wood Drive
    B31 5HF Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishEngineer98440420001
    DEVERS, Matthew Ian
    10 Woodstock Close
    Wordsley
    DY8 5HZ Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    10 Woodstock Close
    Wordsley
    DY8 5HZ Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishAccountant108290890001
    ERRINGTON, Graham Paul
    31 Firs Walk
    Tewin
    AL6 0NY Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    31 Firs Walk
    Tewin
    AL6 0NY Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant1320000001
    ROBERTS, Stephen Leslie
    48 Northfield Road
    Kings Norton
    B30 1JH Birmingham
    Administrateur
    48 Northfield Road
    Kings Norton
    B30 1JH Birmingham
    EnglandBritishFinance Director28518570004
    LINES, Paul Francis
    59 Boileau Road
    Ealing
    W5 3AP London
    Secrétaire
    59 Boileau Road
    Ealing
    W5 3AP London
    British1181840001
    ROBERTS, Stephen Leslie
    48 Northfield Road
    Kings Norton
    B30 1JH Birmingham
    Secrétaire
    48 Northfield Road
    Kings Norton
    B30 1JH Birmingham
    British28518570004
    CASSIDY, David James
    7 Howe Drive
    HP9 2BG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    7 Howe Drive
    HP9 2BG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishAccountant352020001
    COX, Roger
    27 Colebourne Road
    Kingsheath
    B14 Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    27 Colebourne Road
    Kingsheath
    B14 Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector53338060001
    HADDLETON, Frank Albert
    29 The Downs
    WS9 0YT Hardwick Grange
    West Midlands
    Administrateur
    29 The Downs
    WS9 0YT Hardwick Grange
    West Midlands
    BritishEngineering Director33702220001
    HAIGH, John Michael
    Warwick House
    11 The Langs Leckhampton
    GL53 0PU Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Warwick House
    11 The Langs Leckhampton
    GL53 0PU Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishIndustrial Sales & Marketing50185650001
    JORDAN, Barry James
    17 Millcroft Road
    Streetly
    B74 2EE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    17 Millcroft Road
    Streetly
    B74 2EE Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishEngineer5007320001
    LINES, Paul Francis
    59 Boileau Road
    Ealing
    W5 3AP London
    Administrateur
    59 Boileau Road
    Ealing
    W5 3AP London
    BritishLawyer1181840001
    PERKS, Rodney Terence
    61 Highwood Avenue
    B92 8QZ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    61 Highwood Avenue
    B92 8QZ Solihull
    West Midlands
    BritishManaging Director28518550001
    SMITH, Garry John
    342 Eachelhurst Road
    B76 1ER Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    342 Eachelhurst Road
    B76 1ER Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCommercial Director55386980001
    STRINGER, Brian Mark
    Green Lane
    Eccleshall
    ST21 6BA Stafford
    11
    Staffordshire
    Administrateur
    Green Lane
    Eccleshall
    ST21 6BA Stafford
    11
    Staffordshire
    EnglandBritishChief Executive162771990001

    WIDNEY UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 déc. 2002
    Livré le 11 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The amount from time to time outstanding in respect of the variable rate loan stock 2004/2006 created by the company on or about the date of the debenture and issued to northern investors company PLC and northern 2 vct PLC ("the stockholders") and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Venture Managers Limited (As Security Trustee for the Stockholders)
    Transactions
    • 11 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 déc. 2002
    Livré le 11 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The amount from time to time outstanding in respect of the variable rate loan stock 2004/2006 and the variable rate loan stock 2002/2005 created by widney PLC on or about the date of the debenture ("the loan stock") and issued to joseph grimmond, graham errington and gerald cotterill ("the stockholders") and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Graham Errington (As Security Trustee for the Stockholders)
    Transactions
    • 11 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 déc. 2002
    Livré le 07 déc. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 12 déc. 1995
    Livré le 12 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One new cms pf-102 cnc machining centre,ser/no; 1366 with all chattels,plant/machinery thereon.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 12 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge to a debenture dated 29/1/1991
    Créé le 02 avr. 1991
    Livré le 04 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all patents inventions,trade marks,etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed chattels mortgage
    Créé le 02 avr. 1991
    Livré le 04 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on the items attached to the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 janv. 1991
    Livré le 12 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 sept. 1985
    Livré le 01 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 01 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 09 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 13 févr. 1985
    Livré le 20 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts all stocks, shares & other securities uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 20 févr. 1985Enregistrement d'une charge

    WIDNEY UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 oct. 2009Administration ended
    12 mars 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Toby Scott Underwood
    125 Colmore Row
    Brmingham
    B3 3sd
    practitioner
    125 Colmore Row
    Brmingham
    B3 3sd
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    2
    DateType
    29 janv. 2015Dissolved on
    17 oct. 2009Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Toby Scott Underwood
    125 Colmore Row
    Brmingham
    B3 3sd
    practitioner
    125 Colmore Row
    Brmingham
    B3 3sd
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Joanne Marie Wright
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Ian James Gould
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0