FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED

FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00955243
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED ?

    • Édition de journaux (58130) / Information et communication

    Où se situe FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o COMPANY SECRETARY
    Berkshire Media Group
    50-56 Portman Road
    RG30 1BA Reading
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Charles John Allwood en tant que directeur le 22 mai 2015

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 19 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes établis au 28 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Thomson Morrison le 01 févr. 2013

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham John Faulds le 01 mars 2013

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 29 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes établis au 01 oct. 2011

    6 pagesAA

    legacy

    9 pagesMG01

    Résolutions

    Resolutions
    28 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de William Shields Henderson en tant que directeur le 27 févr. 2012

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Graham John Faulds en tant qu'administrateur le 27 févr. 2012

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Charles John Allwood en tant qu'administrateur le 27 févr. 2012

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Graham Thomson Morrison en tant qu'administrateur le 27 févr. 2012

    3 pagesAP01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FAULDS, Graham John
    Danes Drive
    G14 9HX Glasgow
    61
    United Kingdom
    Secrétaire
    Danes Drive
    G14 9HX Glasgow
    61
    United Kingdom
    151592740001
    FAULDS, Graham John
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant63911030001
    MORRISON, Graham Thomson
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director58322450001
    LAWRANCE, Brenda Jane
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    Secrétaire
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    British10757530001
    ROMANES, Deirdre Mary Astrea
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    IrishCompany Director3206310002
    ALLWOOD, Charles John
    Charles Street
    HP4 3DG Berkhamsted
    3
    Hertfordshire
    Administrateur
    Charles Street
    HP4 3DG Berkhamsted
    3
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant35681240004
    HENDERSON, William Shields
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Accountant55090001
    LAWRANCE, Brenda Jane
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    Administrateur
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    BritishDirector10757530001
    LAWRANCE, Peter John
    Shears Bank
    HR8 1EE Ledbury
    .
    Herefordshire
    Uk
    Administrateur
    Shears Bank
    HR8 1EE Ledbury
    .
    Herefordshire
    Uk
    United KingdomBritishDirector10757540004
    MURES, Donald John
    61 Eastfield Road
    SL1 7EL Burnham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    61 Eastfield Road
    SL1 7EL Burnham
    Buckinghamshire
    BritishDirector11126210001
    ROMANES, Deirdre Mary Astrea
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Administrateur
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    United KingdomIrishCompany Director3206310002
    ROMANES, Iain Blair
    Hillside House
    Saline
    KY12 9TD Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    Hillside House
    Saline
    KY12 9TD Dunfermline
    Fife
    BritishDirector182800001

    FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 avr. 2012
    Livré le 25 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 06 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £500,000 loan facility as set out in a loan facility letter of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Brenda Lawrance
    • Peter John Lawrance
    Transactions
    • 06 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 25 janv. 1993
    Livré le 26 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 26 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 mars 1991
    Livré le 19 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book and other debts of the company present and future see form 395 (ref 218) and/or for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 19 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 08 mai 1990
    Livré le 09 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H units 3-5 phase 34 gillingham business park gillingham kent.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 mars 1989
    Livré le 19 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £341,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Property k/a units no.3-5 Phase 34 (valentine close) gillingham business park gillingham kent & also the full benefit of a building agreement.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 août 1981
    Livré le 27 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties. Fixed and floating chage over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 août 1981
    Livré le 27 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 courtlands avenue slough, berkshire title no: bm 1284. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 juil. 1980
    Livré le 23 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as 7 crown shopping centre slough, berkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0