BENCHMARK GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBENCHMARK GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00961142
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BENCHMARK GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BENCHMARK GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BENCHMARK GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GECC UK (BGL) LIMITED31 mai 200531 mai 2005
    BENCHMARK GROUP LIMITED02 juil. 200402 juil. 2004
    BENCHMARK GROUP PLC30 juin 198630 juin 1986
    MANSON FINANCE TRUST PUBLIC LIMITED COMPANY28 août 196928 août 1969

    Quels sont les derniers comptes de BENCHMARK GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BENCHMARK GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 déc. 2019

    10 pagesLIQ03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD02

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 28 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 déc. 2018

    LRESSP

    Modification des détails de Ge Capital Corporation (Investment Properties) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 août 2018

    2 pagesPSC05

    legacy

    7 pagesRP04CS01

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 oct. 2018

    • Capital: GBP 10
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Changement d'adresse du siège social de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT le 17 août 2018

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Zahra Peermohamed en tant que secrétaire le 19 juil. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Miss Zahra Peermohamed en tant que secrétaire le 01 mars 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que secrétaire le 28 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BENCHMARK GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARTER, Derek
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish225848070001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    BAMBER, Janine Margaret
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    Secrétaire
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    British117898690002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    NORMAN, Andrew Peter Livesay
    Little Pitts
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    Secrétaire
    Little Pitts
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    British76545500001
    PEERMOHAMED, Zahra
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secrétaire
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    243693990001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secrétaire
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    British55097590003
    WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Secrétaire
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    British85529340001
    WONG, Wing Yooi
    10 Bluebell Close
    SE26 6SN London
    Secrétaire
    10 Bluebell Close
    SE26 6SN London
    Malaysian1541370001
    ABRAMSON, Christoffer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Administrateur
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Swedish98463110005
    ARCHER, Peter Monahan
    Red Lion House
    Red Lion Hill, The Lee
    HP16 9NF Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Red Lion House
    Red Lion Hill, The Lee
    HP16 9NF Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish65693680001
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Administrateur
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    BOWDEN, Matthew Neville
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183344960001
    BURGER, Alec
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British And American83634080006
    CORDREY, Peter Graham
    Ockham End Old Lane
    KT11 1NF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Ockham End Old Lane
    KT11 1NF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish14661330001
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Administrateur
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    JACOBS, Philip
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish98827150004
    JACOBS, Philip
    8 Spring Grove
    W4 3NH London
    Administrateur
    8 Spring Grove
    W4 3NH London
    United KingdomBritish98827150004
    JEVNE, Anne
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    Administrateur
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    Norwegian126577610001
    JEVNE, Anne
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    Administrateur
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    Norwegian106807190001
    KARLOV, Damien Ivo
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrish202318870001
    KEMPNER, Nigel Justin
    Bix Field
    Bix
    RG9 6BW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Bix Field
    Bix
    RG9 6BW Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish170036770001
    KHATTAR, Sat Pal
    3-D Tanglin Hill
    FOREIGN Singapore
    248035
    Singapore
    Administrateur
    3-D Tanglin Hill
    FOREIGN Singapore
    248035
    Singapore
    SingaporeSingaporean75668250002
    KWEK, Leng Hai
    28a Middle Gap Road
    FOREIGN Hong Kong
    Administrateur
    28a Middle Gap Road
    FOREIGN Hong Kong
    Hong KongSingaporean29531280001
    MANCHANDA, Anupam
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United KingdomIndian196338510001
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United KingdomBritish183345010001
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish139855250001
    MUNTER, Jens Herman Balthazar
    Klampenborg 6a
    FOREIGN Klamenborg 2930
    Denmark
    Administrateur
    Klampenborg 6a
    FOREIGN Klamenborg 2930
    Denmark
    Danish28337740001
    NEWBIGGING, David Kennedy
    15 Old Bailey
    EC4M 7EF London
    Administrateur
    15 Old Bailey
    EC4M 7EF London
    British50153040004
    PALMER, Graham Frederick Boyd
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish170304850001
    PEARSON, William James
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    Administrateur
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    United KingdomBritish133539850001
    QUEK, Chee Hoon
    3 Dalvey Road
    FOREIGN Singapore 259502
    Administrateur
    3 Dalvey Road
    FOREIGN Singapore 259502
    Singapore Citizen59452810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BENCHMARK GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3958779
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BENCHMARK GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 25 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A subordination agreement dated 15 january 2002 (as defined therein)
    Créé le 15 janv. 2002
    Livré le 25 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company as an original subordinated creditor under the subordination deed has undertaken to the security trustee that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the subordinated liabilities or the company receives all or any amount in cash or in kind of the subordinated liabilities the company will hold the same upon trust for the security trustee for application in or towards payment of all the senior liabilities and will promptly pay the same to the agent. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Ag Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined Therein)
    Transactions
    • 25 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of shares
    Créé le 02 juin 2000
    Livré le 15 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to each finance party under each finance document (all as defined)
    Brèves mentions
    First legal mortgage all shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights; and first fixed charge its interest in all the shares and all related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft,London Branch
    Transactions
    • 15 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 oct. 1999
    Livré le 09 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land being 3 st james's square,city of westminster; t/no 168374 with all buildings/fixtures fixed plant machinery thereon; all rights gross rents licence fees and other monies; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subordination deed
    Créé le 27 juil. 1999
    Livré le 11 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the senior loan agreement dated 27TH july 1999 (as defined)
    Brèves mentions
    Any payment or distribution in cash or kind in respect of or on account of any of the junior liabilities (as defined) and any other benefit thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Meespierson N.V.,London Branch (The "Senior Creditor")
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of shares
    Créé le 17 nov. 1998
    Livré le 26 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to each finance party under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    100 ordinary shares of £1 each in benchmark capital limited together with all dividends and interest payable in relation thereto and any rights money pr property accruing by way of bonus redemption option etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 26 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First legal mortgage over l/h land being 63 & 64 south molton street in the city of westminster t/n-305210 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery; first .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mars 1998
    Livré le 20 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    L/H land being 32 brook street and 65 south molton street in the city of westminster t/no: 341996; f/h land being 11 buckingham gate in the city of westminster t/no: 366496 f/h land being 12 buckingham gate in the city of westminster t/no: 288318 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 29 sept. 1997
    Livré le 01 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due pursuant to the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    Floating charge over the company's undertaking property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 31 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 1997
    Livré le 01 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due pursuant to the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    21 properties the first three of which are 1.f/h land k/a 34 kensington square kensington t/no.LN179272. 2.L/h land k/a 1 derry street kensington t/no. BGL7932 and 3.l/h land k/a 99 to 121 (odd numbers) kensington high street t/no.BGL7915 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery. All gross rents licence fees and other monies receivable, all rights under any contracts or agreements. .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 31 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1997
    Livré le 02 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or the deed or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 49 and 50 poland street and 45 fouberts place W1 t/nos. LN169961, NGL22570 and LN169962 with good l/h (save in the case of NGL22570 which is title absoulute) and all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all rights easements and privileges appurtenant to or benefiting the same. All plant and machinery of the above property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transactions
    • 02 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1997
    Livré le 27 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the facility agreement (as defined)
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 11, 12, 13, 13A, 14&14A grafton street and 164 new bond street london t/n NGL711570 together with all buildings fixtures fitting fixed plant and machinery thereon the benefit of all warranties etc any insurance payable any rental and any other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transactions
    • 27 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 1997
    Livré le 27 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the facility agreement (as defined)
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 4 and 5 preinc's gate knightsbridge westminster london t/n NGL678785 together with all buildings and fixtures fittings fixed plant and machinery thereon the benefit of all warranties etc any insurance payable any rental and all other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transactions
    • 27 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 avr. 1997
    Livré le 29 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility agreement (as defined) and/or this deed on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a rivermill (number 151) and rivermill house (number 152) grosvenor road london t/no: NGL360247 and all buildings, fixtures (including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all rights, easements and privileges appurtenant to, or benefiting, the same. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transactions
    • 29 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 1997
    Livré le 06 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 06 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A legal charge
    Créé le 23 déc. 1996
    Livré le 02 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility agreement dated 3RD october 1996 (as amended by a letter dated 4TH october 1996 and a supplemental agreement dated 23RD december 1996)
    Brèves mentions
    F/H and l/h property k/a 99/121 kensington high street and 1 derry street london t/nos: LN179272; BGL7932; BGL7915; NGL391961 and NGL445163 and all buidlings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery, all insurances and all income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transactions
    • 02 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 23 déc. 1996
    Livré le 02 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility agreement dated 3RD october 1996 (as amended by a letter dated 4TH october 1996 and a supplemental agreement dated 23RD december 1996)
    Brèves mentions
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transactions
    • 02 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of subordination
    Créé le 10 août 1987
    Livré le 12 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £4,000.000 and all other monies due or to become due from the company peter metchley holdings limited to the chargee
    Brèves mentions
    Loan of £2,300,000 by the company to peter methley holdings limited and any other loans to them for time to time.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handetsbanker PLC
    Transactions
    • 12 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 16 oct. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BENCHMARK GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 déc. 2018Commencement of winding up
    30 déc. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0