WOODCHESTER CREDIT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWOODCHESTER CREDIT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00962324
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WOODCHESTER CREDIT LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe WOODCHESTER CREDIT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WOODCHESTER CREDIT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WOODCHESTER CREDIT LYONNAIS LIMITED15 janv. 199315 janv. 1993
    WOODCHESTER BANK U.K. P.L.C.31 mai 199131 mai 1991
    MOORGATE MERCANTILE HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY19 sept. 196919 sept. 1969

    Quels sont les derniers comptes de WOODCHESTER CREDIT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour WOODCHESTER CREDIT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 déc. 2019

    10 pagesLIQ03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 28 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 déc. 2018

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    État du capital au 16 août 2018

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share premium account 09/08/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Tilly Lang en tant que directeur le 02 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Tilly Lang en tant que secrétaire le 02 juil. 2018

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    19 pagesAA

    Nomination de Tilly Lang en tant que secrétaire le 19 juil. 2017

    2 pagesAP03

    Nomination de Tilly Lang en tant qu'administrateur le 19 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kalpna Shah en tant que secrétaire le 19 juil. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Paul David Hurd en tant que directeur le 10 mars 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon James Palmer en tant que directeur le 10 mars 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Stewart Girling en tant qu'administrateur le 10 mars 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de WOODCHESTER CREDIT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    CRICHTON, Susan Elizabeth
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    British69358970001
    DRAZIN, Shirley
    4 St Lawrence Close
    HA8 6RB Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    4 St Lawrence Close
    HA8 6RB Edgware
    Middlesex
    British2457320001
    GREEN, Peter Harvey
    7 Lower Park Road
    CH4 7BB Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    7 Lower Park Road
    CH4 7BB Chester
    Cheshire
    British123086060001
    HAYES, Daniel Edward Laurence
    Alpine Cottage 6 Old Brandon Lane
    Shadwell
    LS17 8HP Leeds
    Yorkshire
    Secrétaire
    Alpine Cottage 6 Old Brandon Lane
    Shadwell
    LS17 8HP Leeds
    Yorkshire
    British78253650001
    LANG, Tilly
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secrétaire
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    236206390001
    OWENS, Jennifer Anne
    Flat A
    55 Agate Road
    W6 0AL London
    Secrétaire
    Flat A
    55 Agate Road
    W6 0AL London
    British113688770001
    RYAN, Gerard Jude
    28 Pilrig Street
    EH6 5AJ Edinburgh
    Secrétaire
    28 Pilrig Street
    EH6 5AJ Edinburgh
    Irish32962580002
    SHAH, Kalpna
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Secrétaire
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    199403630001
    FN SECRETARY LIMITED
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    88740300002
    BARKER, John Ian
    1 Codrington Court
    243 Rotherhithe Street
    SE16 1FT London
    Administrateur
    1 Codrington Court
    243 Rotherhithe Street
    SE16 1FT London
    British62310010002
    BARR, Ciaran Joseph, Mr.
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    IrelandIrish240977080001
    BELLIER, Michael Marie Dominique
    29 Melton Court
    Old Brompton Road
    SW7 3JQ London
    Administrateur
    29 Melton Court
    Old Brompton Road
    SW7 3JQ London
    French43528920001
    BELLISSEN, Jean Francois
    Strada Delle Terrazze 56/12
    10133 Turin
    Italy
    Administrateur
    Strada Delle Terrazze 56/12
    10133 Turin
    Italy
    French59736090001
    BERRY, Duncan Gee
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107695600022
    BLACKBURN, Richard Martin
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish205472140001
    BONNET, Michel Maurice Denis
    29a Bolton Gardens
    SW5 0AQ London
    Administrateur
    29a Bolton Gardens
    SW5 0AQ London
    British53774780001
    BRUNYATE, John Maitland
    Winter Lodge 95 Middlemead
    Hook
    Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Winter Lodge 95 Middlemead
    Hook
    Basingstoke
    Hampshire
    British72740940001
    BUICK, Craig Anthony
    3 Durkar Court
    WF4 3QR Durkar
    West Yorkshire
    Administrateur
    3 Durkar Court
    WF4 3QR Durkar
    West Yorkshire
    Australian99910330001
    BULLOCH, Robert James Mackenzie
    The Toll House Watergate
    Cleish
    KY13 0LS Kinross
    Fife
    Administrateur
    The Toll House Watergate
    Cleish
    KY13 0LS Kinross
    Fife
    British65105210001
    CAMERON, Ewan Douglas
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    Administrateur
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    British122900270001
    CHESTERFIELD, Benjamin
    5 Frognal Close
    NW3 6YB London
    Administrateur
    5 Frognal Close
    NW3 6YB London
    United KingdomBritish67381990001
    CULLEN, Michael
    35 Palmerston Road
    6 Dublin
    Administrateur
    35 Palmerston Road
    6 Dublin
    Irish50973410002
    DARMAYAN, Bernard Louis Gabriel
    32 Tite Street
    Chelsea
    SW3 4JA London
    Administrateur
    32 Tite Street
    Chelsea
    SW3 4JA London
    French40134730001
    DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131081660001
    DODDRELL, Paul Derek
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    IrelandBritish166226140001
    DRAVET, Antoine
    7 Bis Rue Dufetel
    78150 Le Chesnay 78150
    FOREIGN
    France
    Administrateur
    7 Bis Rue Dufetel
    78150 Le Chesnay 78150
    FOREIGN
    France
    French12115930001
    EVANS, Kellie Victoria
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167417000001
    FERGUSON, Ian George
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133318850001
    FLORENCE, Duncan Paul Marsden
    6 High Drive
    KT3 3UG New Malden
    Surrey
    Administrateur
    6 High Drive
    KT3 3UG New Malden
    Surrey
    United KingdomBritish40499260001
    FLYNN, William John
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British99330320002
    GARDEN, Robert James
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152764360001
    GASKIN, Richard
    32 Farrer Lane
    Oulton
    LS26 8JJ Leeds
    Administrateur
    32 Farrer Lane
    Oulton
    LS26 8JJ Leeds
    British97088460001
    GEORGEU, Peter
    209 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2BA St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    209 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2BA St Albans
    Hertfordshire
    British38549410001
    GILLIGAN, Brendan Edward
    8 Thormanbay Lodge
    IRISH Howth
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    8 Thormanbay Lodge
    IRISH Howth
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish227641150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WOODCHESTER CREDIT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ashley Road
    3rd Floor
    WA14 2DT Altrincham
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Ashley Road
    3rd Floor
    WA14 2DT Altrincham
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueGe Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02849023
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WOODCHESTER CREDIT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 09 juil. 1980
    Livré le 15 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Agreements for rental hire purchase and credit sale more particularly detailed in the schedule attached to doc M77.
    Personnes ayant droit
    • Bank Hapoalim B.M.
    Transactions
    • 15 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    Charge over agreements
    Créé le 06 juin 1980
    Livré le 17 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Various hire purchase agreements.
    Personnes ayant droit
    • Keysen William Limited
    Transactions
    • 17 juin 1980Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 29 avr. 1980
    Livré le 07 mai 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Agreements for rental, hire purchase, and credit sale more particularly detailed in schedule annexed. (For details see doc m/75).
    Personnes ayant droit
    • Bank Hapoalim B.M.
    Transactions
    • 07 mai 1980Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 16 avr. 1980
    Livré le 21 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1) the hire purchase agreements 2) all agreements for rental hire purchase credit sale, conditional sale or under wich the purchase price of goods sold is payable by instalments of for personal credit & all present & future agreements of a like nature now or hereafter entered into by the company as are from time to time deposted with the bank. 3) the property & assets comprised in or the subject of any such agreement as referred to in 1 and 2 above.
    Personnes ayant droit
    • Bank Hapoalim B.M.
    Transactions
    • 21 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 mars 1980
    Livré le 02 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company and priestgate properties limited
    Brèves mentions
    F/H property known as 312 high road, tottenham, london botough of harihgey title no. Mx 467743.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 02 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 11 mars 1980
    Livré le 21 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits & interest of the company whatsoever present & future in respect of the property or assets comprised in both agreements particuldrs of which are set out in the schedule annoced to the charge.
    Personnes ayant droit
    • Bank British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 21 mars 1980Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 26 févr. 1980
    Livré le 06 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights, title, benefits and interests of the company is respect of certain agreements scheduled to the charge and those present 8 future agreements affered by the company to the bank as security (for full details see doc M71).
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 mars 1980Enregistrement d'une charge

    WOODCHESTER CREDIT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 déc. 2018Commencement of winding up
    14 juil. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0