WHITTAKER ELLIS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WHITTAKER ELLIS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00962635 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WHITTAKER ELLIS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Building 4 Clearwater Lingley Green Avenue Great Sankey WA5 3UZ Warrington Cheshire United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WHITTAKER ELLIS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WHITTAKER ELLIS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2024 |
Quels sont les derniers dépôts pour WHITTAKER ELLIS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Modification des détails de United Living (North) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 sept. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de Media House Azalea Drive Swanley Kent BR8 8HU à Building 4 Clearwater Lingley Green Avenue Great Sankey Warrington Cheshire WA5 3UZ le 09 sept. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 2 pages | AA | ||
Nomination de Ole Pugholm en tant qu'administrateur le 01 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Ryan John Brennan en tant que directeur le 31 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Patrick Armstrong le 23 mars 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 2 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Timothy Nicholas Wood en tant que directeur le 10 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de David Masters en tant que directeur le 30 avr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019 | 2 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Stuart Wilson Laird en tant que directeur le 18 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Satisfaction de la charge 009626350006 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Nomination de Mr Ryan John Brennan en tant qu'administrateur le 19 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Neil Patrick Armstrong en tant qu'administrateur le 19 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Ian George Burnett en tant que directeur le 19 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de WHITTAKER ELLIS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMSTRONG, Neil Patrick | Administrateur | Lingley Green Avenue Great Sankey WA5 3UZ Warrington Building 4 Clearwater Cheshire United Kingdom | England | Irish | 104897110015 | |||||
| PUGHOLM, Ole | Administrateur | Lingley Green Avenue Great Sankey WA5 3UZ Warrington Building 4 Clearwater Cheshire United Kingdom | United Kingdom | Danish | 293277960001 | |||||
| CANE, Michael Geoffrey | Secrétaire | c/o C/O Bulock Construction Ltd Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | British | 148321570001 | ||||||
| COX, Anthony | Secrétaire | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | British | 108052270001 | ||||||
| HOOPER KEELEY, Paul | Secrétaire | 12 Denyer Court Fradley WS13 8TQ Lichfield Staffordshire | British | 97457690001 | ||||||
| HORROCKS, Paul John | Secrétaire | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | 161988430001 | |||||||
| MAXWELL, Keith Richard | Secrétaire | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | British | 136377740001 | ||||||
| MAXWELL, Keith Richard | Secrétaire | 1 Butts Close Norton Canes WS11 9PW Cannock Staffordshire | British | 89012970001 | ||||||
| MOBBERLEY, Paul | Secrétaire | 26 Leaholme Gardens Pedmore DY9 0XX Stourbridge West Midlands | British | 10175170001 | ||||||
| VITTY, Martyn John | Secrétaire | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | 164479590001 | |||||||
| MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED | Secrétaire | 39 Cornhill EC3V 3NU London | 41291250009 | |||||||
| BRENNAN, Ryan John | Administrateur | Azalea Drive BR8 8HU Swanley Media House Kent | England | British | 225659980001 | |||||
| BURNETT, Ian George | Administrateur | Azalea Drive BR8 8HU Swanley Media House Kent England | United Kingdom | British | 184314320002 | |||||
| CANE, Michael Geoffrey | Administrateur | c/o C/O Bulock Construction Ltd Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | England | British | 148317910001 | |||||
| CAREY, Peter Damian | Administrateur | Azalea Drive BR8 8HU Swanley Media House Kent United Kingdom | England | British | 151427560001 | |||||
| COX, Kevin Alan | Administrateur | Bullock Construction Ltd Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | England | British | 114778650001 | |||||
| FEAST, Roger | Administrateur | 43 Merchant Court 61 Wapping Wall E1W 3SJ London | British | 66800550001 | ||||||
| GAFFNEY, John Sherwood | Administrateur | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall | British | 46027710003 | ||||||
| HOOPER KEELEY, Paul | Administrateur | 12 Denyer Court Fradley WS13 8TQ Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | 97457690001 | |||||
| LAIRD, Stuart Wilson | Administrateur | Azalea Drive BR8 8HU Swanley Media House Kent England | England | British | 60742240002 | |||||
| MASTERS, David | Administrateur | Azalea Drive BR8 8HU Swanley Media House Kent | England | British | 243976070001 | |||||
| MAXWELL, Keith Richard | Administrateur | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | United Kingdom | British | 136377740001 | |||||
| MOBBERLEY, Paul | Administrateur | 26 Leaholme Gardens Pedmore DY9 0XX Stourbridge West Midlands | British | 10175170001 | ||||||
| SAUL, Andrew William | Administrateur | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall England | England | British | 167511670001 | |||||
| SHERRINGTON, Roger William | Administrateur | 2 Gisborne Close Yoxall DE13 8NU Burton On Trent Staffordshire | England | British | 55880890001 | |||||
| SUTHON, Richard Paul | Administrateur | WS9 8TU Aldridge Northgate Walsall | England | British | 156986090001 | |||||
| TILBROOK, George William | Administrateur | Out Of Bounds 26 Moor Hall Drive Four Oaks B75 6LR Sutton Coldfield West Midlands | British | 10175180002 | ||||||
| VITTY, Martyn John | Administrateur | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall | United Kingdom | British | 165550340001 | |||||
| WEBB, Thomas Edward | Administrateur | 3 Vicarage Close Church Walk CV9 1QT Atherstone Warwickshire | British | 30459540001 | ||||||
| WILLIAMS, Duncan Richard | Administrateur | Northgate Aldridge WS9 8TU Walsall West Midlands | England | British | 184314910001 | |||||
| WOOD, Timothy Nicholas | Administrateur | Azalea Drive BR8 8HU Swanley Media House Kent England | England | British | 105458160001 | |||||
| MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED | Administrateur | 39 Cornhill EC3V 3NU London | 41291250009 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHITTAKER ELLIS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Living (North) Limited | 06 avr. 2016 | Lingley Green Avenue Great Sankey WA5 3UZ Warrington Building 4 Clearwater United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0