BELLA REALISATIONS 2 LIMITED

BELLA REALISATIONS 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBELLA REALISATIONS 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00964194
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BELLA REALISATIONS 2 LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration

    Où se situe BELLA REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BELLA REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BELLA ITALIA RESTAURANTS LIMITED16 mai 200616 mai 2006
    BRIGHTREASONS RESTAURANTS LIMITED20 avr. 199420 avr. 1994
    PIZZALAND INTERNATIONAL LIMITED 16 mai 199116 mai 1991
    PIZZALAND LIMITED21 févr. 199121 févr. 1991
    ASSOCIATED RESTAURANTS LIMITED17 oct. 196917 oct. 1969

    Quels sont les derniers comptes de BELLA REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 mai 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BELLA REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    37 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Nomination d'un administrateur

    pagesAM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10

    Démission d'un administrateur

    4 pagesAM15

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Nomination d'un administrateur

    pagesAM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    44 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    46 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    5 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    66 pagesAM10

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 009641940034

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 009641940032

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 009641940035

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 009641940033

    11 pagesMR05

    Changement d'adresse du siège social de 8th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WB à Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU le 11 nov. 2020

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Adrian Rowland Walker en tant que directeur le 08 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Forrester Spragg en tant que directeur le 08 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bella italia restaurants LIMITED\certificate issued on 15/10/20
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    9 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    5 pagesAM06

    Qui sont les dirigeants de BELLA REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUXTON SMITH, Maria Rita
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    Secrétaire
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    British39442340002
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Secrétaire
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    237559750001
    FENTON, Nicola Jane
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    Secrétaire
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    BritishCommercial Lawyer31440290005
    FRANKLIN, Robert Norman Carew
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    Secrétaire
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    British37258120002
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Secrétaire
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    BritishFinance Director64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Secrétaire
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    BritishDirector49107830002
    SIMS, Robin Edward
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    British52343580001
    ASPEL, Edward
    2 Christ Church Cottages
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    2 Christ Church Cottages
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    BritishDirector62933370001
    BAKER, Ian Stewart
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Director67628330002
    BAKER, Ian Stewart
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Director67628330002
    BARBOUR, Niel Paterson
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    Administrateur
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    BritishGroup Operation Director71423490001
    CLEWLEY, Robert Richard
    Sunfield House
    Tonbridge Road
    TN15 9AR Ightham
    Kent
    Administrateur
    Sunfield House
    Tonbridge Road
    TN15 9AR Ightham
    Kent
    United KingdomBritishExecutive85729830001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Administrateur
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritishAccountant187907210001
    DAVIS, Samantha Clare
    14 Links Drive
    WD6 3PS Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Links Drive
    WD6 3PS Elstree
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector125626320001
    DERKACH, John
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Administrateur
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    United KingdomBritishCeo113885080002
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    DUDLEY, Stuart
    1 The Old Vicarage
    OX17 1SA Wardington
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 The Old Vicarage
    OX17 1SA Wardington
    Oxfordshire
    BritishPurchasing Director66322690001
    EVANS, John Stephen David
    Courtyard Cottage
    4 The Toft
    WA16 9EH Toft Road Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Courtyard Cottage
    4 The Toft
    WA16 9EH Toft Road Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishCaterer92401670001
    FERNANDEZ, Sara Kathryn
    31 Theobalds Way
    Frimley
    GU16 5RF Camberley
    Surrey
    Administrateur
    31 Theobalds Way
    Frimley
    GU16 5RF Camberley
    Surrey
    BritishSales Dir43206820001
    GREEN, Christopher David
    Springfield Barn
    The Avenue, Barnsdale
    LE15 8AH Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Springfield Barn
    The Avenue, Barnsdale
    LE15 8AH Oakham
    Rutland
    EnglandEnglishMarketing Director100789790001
    GUTHRIE, Garth Michael
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director51714120001
    HANNA, Chaker
    61 Longlands Road
    DA15 7LQ Sidcup
    Kent
    Administrateur
    61 Longlands Road
    DA15 7LQ Sidcup
    Kent
    BritishOperations Director43872760001
    HENFREY, Anthony William, Dr
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    Administrateur
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    EnglandBritishCompany Director42207200001
    JOHNSON, Michael Andrew
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    Administrateur
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director98243170001
    JOHNSON, Rowland Christopher
    3 Duck End Lane
    MK45 2DL Maulden
    Bedfordshire
    Administrateur
    3 Duck End Lane
    MK45 2DL Maulden
    Bedfordshire
    BritishDirector71910140001
    LESTER, Jeremy William
    24 Hillview
    2-4 Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    Administrateur
    24 Hillview
    2-4 Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    BritishAccountant50628960002
    LONG, Jeremy Paul Warwick
    31 Alwyne Road
    Islington
    N1 2HW London
    Administrateur
    31 Alwyne Road
    Islington
    N1 2HW London
    BritishCompany Director7764450001
    LUDBROOK, Michael Sydney
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    Administrateur
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    BritishCompany Director60035400001
    LUDBROOK, Michael Sydney
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    Administrateur
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    BritishCompany Director60035400001
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Administrateur
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritishCompany Director64318140002
    MANSIGANI, Mohan
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    Administrateur
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    United KingdomBritishFinance Director64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Administrateur
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    BritishDirector49107830002
    PARSONS, James
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector98887110002
    PENNY, Michael William Harrison
    6 Guildcroft
    GU1 2JU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    6 Guildcroft
    GU1 2JU Guildford
    Surrey
    BritishFinance Director22553680001
    RICHARDS, Stephen
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector187618040002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BELLA REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02521829
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BELLA REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 janv. 2020
    Livré le 16 janv. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transactions
    • 16 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2018
    Livré le 31 août 2018
    En cours
    Brève description
    The charged property (as defined under the supplemental debenture). For more details please refer to the supplemental debenture, the security agreement (as defined in the supplemental debenture) and the chargor's deed of accession thereto.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transactions
    • 31 août 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2018
    Livré le 21 août 2018
    En cours
    Brève description
    None at the date of the charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 21 août 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 05 févr. 2016
    Livré le 09 févr. 2016
    En cours
    Brève description
    The security document enclosed with this form MR01 includes a fixed charge or a fixed security over land and intellectual property, including the basement and ground floor premises at 25 argyll street and 1 little argyll street, london. For more details of the land and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 09 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 20 juil. 2015
    Livré le 07 août 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    "Bella pasta pasta cafe (stylised)" trademark, registration number 394040880, 39404088. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 07 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 mai 2015
    Livré le 15 mai 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    German trademark bella pasta pasta cafe (stylised) 394040880 and 39404088 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S.Bank Trustees Limited (In Its Capacity as Seurity Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 sept. 2014
    Livré le 03 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 03 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security document
    Créé le 25 juil. 2007
    Livré le 31 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in and to the assigned contracts all insurances and a fixed charge on all present and future real property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 31 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security document
    Créé le 22 janv. 2007
    Livré le 26 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the assigned contracts, all insurances and a fixed charge present and future real property and other assets. Floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 26 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 mai 2006
    Livré le 09 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All property,first fixed charge all other property,all licences,all computers,vehicles,office equipment and other equipment,the benefit of all contracts,licences and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC the "Security Agent"
    Transactions
    • 09 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit G40B, lowry centre, salford. L/h property k/a units 3 and 5 longmarket, canterbury. L/h property k/a unit 1 derry's cross, plymouth. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC 'Security Agent'
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and amendment
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 10 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A grant of security over all security interests and disposistions and are created with a full title guarantee and are continuing security for payment of all of the secured obligations. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC ( the Security Agent)
    Transactions
    • 10 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 janv. 2005
    Livré le 29 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Properties k/a argyll street, london-25 argyll street; birmingham-103-104 the charters new street t/no WM412377; bournemouth-84 old christchurch road. For details of further properties charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 29 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 11 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    20A winchester street basingstoke; unit 1 bishops wharf 39 and 49 parkgate road; 296/298 high street berkhamsted t/nos: HP536633 TGL104043 HD351012. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 12 oct. 1995
    Livré le 19 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture and loan agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mercury Asset Management PLC
    Transactions
    • 19 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 11 sept. 1995
    Livré le 19 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself, the arranger and each bank (as defined in the facility agreement dated 20 february 1991) and the governor and company of the bank of scotland as overdraft bank, under the terms of the financing documents (as defined in the facility agreement) or any of them
    Brèves mentions
    All and whole that area of land at aviemore in the united parish of duthil and rothiemurchus and county of inverness and highland region extending to one hundred and seventy five decimal parts of an hectare or thereby (0.175HA) ...... see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transactions
    • 19 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1994
    Livré le 21 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the finance documents (as defined) and/or this deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 21 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 23 févr. 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined)
    Brèves mentions
    Ground floor premises at 5 frederick street edinburgh midlothian.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee as Defined
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 23 févr. 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and each bank
    Brèves mentions
    The basement restaurant 15A castle street and ground mezzanine and first floors of 15 castle street edinburgh.see frm 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 23 févr. 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to samuel montagu & co.limited as agent and trustee for itself and each bank as defined
    Brèves mentions
    100-112 renfield street and 47-59 sauchiehall street glasgow.see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co.Limitedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 23 févr. 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and each of the banks as defined
    Brèves mentions
    Ground floor and basement of 13-15 saint vincent place glasgow.see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co.Limited Definedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank As
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 23 févr. 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and each bank as defined
    Brèves mentions
    Ground floor and first basement 23 north bridge edinburgh.see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co.Limited Definedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank As
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 23 févr. 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co.limited as agent and trustee for itself and each bank as defined
    Brèves mentions
    53/55 port street stirling see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for Itself and the Banks as Defined
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 18 févr. 1993
    Livré le 10 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from each obligor to the chargee under each of the finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co as Agent and Trustee for Itself, Itself as Arranger and Each Bank and Theoverdraft Bank
    Transactions
    • 10 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mezzanine debenture
    Créé le 18 févr. 1993
    Livré le 10 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from each obligor to the chargee under each of the financing documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee for Itself and Each Lender
    Transactions
    • 10 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BELLA REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2014Date of meeting to approve CVA
    22 juil. 2016Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DateType
    02 juil. 2020Administration started
    29 juin 2023Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Clare Kennedy
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Daniel Imison
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0