PSL RUNOFF LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PSL RUNOFF LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00969374 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PSL RUNOFF LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Frp Advisory Llp 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PSL RUNOFF LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour PSL RUNOFF LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mars 2023 | 6 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mars 2022 | 6 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mars 2020 | 6 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mars 2020 | 6 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de One Creechurch Place London EC3A 5AF United Kingdom à C/O Frp Advisory Llp 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ le 20 mars 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William David Bloomer le 02 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Howden Broking Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 16 Eastcheap London EC3M 1BD England à One Creechurch Place London EC3A 5AF le 01 janv. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 009693740006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr William David Bloomer en tant qu'administrateur le 15 août 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Timothy Bastow en tant que directeur le 15 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Keith Tyler en tant que directeur le 30 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2017 | 24 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Howden Broking Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mai 2017 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Perkins Slade Forrest Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mai 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2016 | 30 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PSL RUNOFF LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Andrew John | Secrétaire | 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Llp | 215225990001 | |||||||
| BLOOMER, William David | Administrateur | 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Llp | United Kingdom | British | 214179860002 | |||||
| BLAKE, Matt | Secrétaire | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | 201173480001 | |||||||
| DICKIE, Charles George | Secrétaire | The Malthouse Folley Road Ackleton WV6 7JL Wolverhampton West Midlands | British | 7608010001 | ||||||
| ISMAIL, Aslam | Secrétaire | 51-53 Hagley Road B16 8TP Birmingham Tricorn House England | 155849420001 | |||||||
| TAMBLYN, Nicholas John | Secrétaire | Kinnersley House Kinnersley WR8 9JR Worcester Worcestershire | British | 27427340003 | ||||||
| TIPPLE, Michael Roger | Secrétaire | 50 Elizabeth Road Moseley B13 8QJ Birmingham West Midlands | British | 11808160001 | ||||||
| BASTOW, Andrew Timothy | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | United Kingdom | British | 197611070001 | |||||
| BRIGHT, Stephen Michael | Administrateur | The Ferns Histons Hill Codsall WV8 2EY Wolverhampton West Midlands | England | British | 7817150001 | |||||
| DEACON, Anthony David | Administrateur | 18 Ascot Close WS14 9XX Lichfield Staffordshire | British | 60017620001 | ||||||
| DORAN, Paul Damien | Administrateur | 62 Highbridge Road B73 5QE Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 57649000003 | |||||
| DOUBLEDAY, Richard John, Mr. | Administrateur | 18 Manor Fields Alrewas DE13 7DA Burton-On-Trent Naseby Barn Staffordshire England | England | British | 127986450002 | |||||
| EVANS, Christopher Peter Richard | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | United Kingdom | British | 180284840002 | |||||
| FORD, Mark | Administrateur | 3 Broadway Broad Street B15 1BQ Birmingham | United Kingdom | British | 165853550002 | |||||
| FORREST, Ronald William | Administrateur | 18 Ladywood Road B74 2SW Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 177160002 | |||||
| HULTON-HARROP, Julia Margaret | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | United Kingdom | British | 85461210001 | |||||
| ISMAIL, Aslam | Administrateur | 51-53 Hagley Road B16 8TP Birmingham Tricorn House England | United Kingdom | British | 165851840002 | |||||
| JACKSON, Michael, Doctor | Administrateur | Ivy Cottage Strawmoor Lane WV8 2HY Oaken Wolverhampton | British | 89250950001 | ||||||
| LLOYD, Nigel Christopher | Administrateur | Maiden Farm House Crossway Green DY13 9SQ Stourport On Severn Worcestershire | British | 11808140002 | ||||||
| LOVE, Stuart Charles | Administrateur | 79 The Worcestershire St. Andrews Road WR9 8DW Droitwich Worcestershire | British | 125553040001 | ||||||
| MAXTED, Laurence Eric | Administrateur | Brunswick Villa Church Street CO5 9AH Kelvedon Essex | British | 90707980001 | ||||||
| MORRIS, Nigel Andrew | Administrateur | 18 Clifford Close WR9 8UT Droitwich Spa Worcestershire | British | 55580980002 | ||||||
| OCONNOR, Michael Joseph | Administrateur | 307 Boxley Road ME14 2HL Maidstone Kent | American | 29324990001 | ||||||
| POLLARD, Anthony | Administrateur | 1 Wollescote Drive The Spinney B91 3YN Solihull West Midlands | British | 4153910001 | ||||||
| REED, John Geofrey | Administrateur | 74 Parkhurst Fields Churt GU10 2PQ Farnham Surrey | United Kingdom | British | 67916430002 | |||||
| REID, Stephen David | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | United Kingdom | British | 182719200001 | |||||
| RICHARDSON, Ian | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | United Kingdom | British | 197592500001 | |||||
| ROBERTSON, Wayne Leroy | Administrateur | Juniper Cottage Old Mill Lane Sheet GU31 4DA Petersfield Hampshire | England | British | 11808170001 | |||||
| ROOTHAM, Stuart Paul | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | England | British | 201171760001 | |||||
| ROWE, Darren | Administrateur | 3 Broadway Broad Street B15 1BQ Birmingham | United Kingdom | British | 166369090001 | |||||
| SLADE, David Michael | Administrateur | Rydal Mount 16 Kidderminster Road B61 7JW Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | 11808130001 | |||||
| SMITH, Peter David | Administrateur | Eastcheap EC3M 1BD London 16 England | United Kingdom | British | 201889340001 | |||||
| SMYTH, Andrew Laurence Cockcroft | Administrateur | Galliards Churt Road GU10 2NZ Churt Surrey | British | 106990910001 | ||||||
| TAMBLYN, Nicholas John | Administrateur | Kinnersley House Kinnersley WR8 9JR Worcester Worcestershire | England | British | 27427340003 | |||||
| TIPPLE, Michael Roger | Administrateur | 50 Elizabeth Road Moseley B13 8QJ Birmingham West Midlands | British | 11808160001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PSL RUNOFF LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howden Broking Group Limited | 08 mai 2017 | EC3A 5AF London One Creechurch Place United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Perkins Slade Forrest Holdings Limited | 06 juin 2016 | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PSL RUNOFF LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 09 févr. 2016 Livré le 19 févr. 2016 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 27 janv. 2004 Livré le 05 févr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 28 juin 1994 Livré le 06 juil. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 31 déc. 1991 Livré le 17 janv. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £750,000 12 % secured fixed rate loan stock note together with all monies due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 03 déc. 1990 Livré le 13 déc. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti £500,000 due from the company to the chargee. | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee debenture | Créé le 28 avr. 1986 Livré le 08 mai 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or perkins slade sayer limited. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
PSL RUNOFF LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0