S.KAYE & SON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéS.KAYE & SON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00973958
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de S.KAYE & SON LIMITED ?

    • Activités de la médecine générale (86210) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe S.KAYE & SON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Peterwood Way
    CR0 4UQ Croydon
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de S.KAYE & SON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour S.KAYE & SON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Nicholas Robert Kaye en tant que directeur le 13 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 009739580012, créée le 23 janv. 2017

    9 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2016

    5 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 28 févr. 2017 au 31 mars 2017

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 29 févr. 2016 au 28 févr. 2016

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente prolongée du 30 janv. 2016 au 29 févr. 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2016 au 30 janv. 2016

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Kirit Chimanbhai Patel Junior en tant que directeur le 16 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kirit Chimanbhai Patel en tant que directeur le 16 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Lion House Red Lion Street London WC1R 4GB à 2 Peterwood Way Croydon Surrey CR0 4UQ le 11 mai 2016

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Nomination de Mr Jayanti Chimanbhai Patel Junior en tant qu'administrateur le 01 mars 2016

    3 pagesAP01

    Nomination de Kirit Chimanbhai Patel Junior en tant qu'administrateur le 01 mars 2016

    3 pagesAP01

    Nomination de Mrs Heena Patel en tant qu'administrateur le 01 mars 2016

    3 pagesAP01

    Nomination de Ameetkumar Ramananbhai Patel en tant que secrétaire le 01 mars 2016

    3 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de S.KAYE & SON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PATEL, Ameetkumar Ramananbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    Secrétaire
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    207033150001
    PATEL, Heena
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish62369320002
    PATEL JUNIOR, Jayanti Chimanbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    EnglandBritish174158560001
    KAYE, Elizabeth Nellie Bryant
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    Secrétaire
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    British18327260001
    KAYE, Robert Barson
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    Secrétaire
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    British18327270001
    KAYE, Elizabeth Nellie Bryant
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    Administrateur
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    British18327260001
    KAYE, Nicholas Robert
    Narrowcliff
    TR7 2QF Newquay
    Narrowcliff Surgery
    Cornwall
    United Kingdom
    Administrateur
    Narrowcliff
    TR7 2QF Newquay
    Narrowcliff Surgery
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish64748100004
    KAYE, Nicholas Robert
    Bedowan Meadows
    Tretherras
    TR7 2TB Newquay
    138
    Cornwall
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedowan Meadows
    Tretherras
    TR7 2TB Newquay
    138
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish64748100004
    KAYE, Robert Barson
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    Administrateur
    59 Trevean Way
    TR7 1TW Newquay
    Cornwall
    United KingdomBritish18327270001
    KERSH, Lloyd Gary
    Narrowcliff
    TR7 2QF Newquay
    Narrowcliff Surgery
    Cornwall
    United Kingdom
    Administrateur
    Narrowcliff
    TR7 2QF Newquay
    Narrowcliff Surgery
    Cornwall
    United Kingdom
    EnglandBritish154040230001
    PATEL, Kirit Chimanbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    EnglandBritish11545120001
    PATEL JUNIOR, Kirit Chimanbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    EnglandBritish101281110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur S.KAYE & SON LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peterwood Way
    CR0 4UQ Croydon
    2
    Surrey
    England
    06 avr. 2016
    Peterwood Way
    CR0 4UQ Croydon
    2
    Surrey
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07372866
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    S.KAYE & SON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 janv. 2017
    Livré le 25 janv. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 25 janv. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 07 juil. 2014
    Livré le 09 juil. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 déc. 2013
    Livré le 23 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 nov. 2013
    Livré le 27 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 févr. 2011
    Livré le 25 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 1994
    Livré le 06 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a pearces chemist 1 bank street newquay cornwall. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mai 1993
    Livré le 08 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 2 st thomas road newquay cornwall. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 mars 1992
    Livré le 06 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises being 2,cliff road newquay cornwall tog with all fixtures and fittings and the benefit of all rights licences and the goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & hereditaments being:- 6, east street, newquay cornwall.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & hereditanents being:- 8, east street, newquay, cornwall.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 déc. 1983
    Livré le 22 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises being 10 east street newquay cornwall.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 08 mars 1978
    Livré le 15 mars 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over undertaking and all property present and future including uncalled capital (see doc M16).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1978Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0