HUNTING PLC
Vue d'ensemble
Nom de la société | HUNTING PLC |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
Numéro de société | 00974568 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HUNTING PLC ?
Adresse du siège social | 5th Floor 30 Panton Street SW1Y 4AJ London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HUNTING PLC ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUNTING PLC ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 11 juil. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour HUNTING PLC ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées du secrétaire David Benjamin Willey le 03 avr. 2013 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Catherine Lee Krajicek en tant qu'administrateur le 03 mars 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Annell Russell Bay en tant que directeur le 01 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Inscription de la charge 009745680015, créée le 16 oct. 2024 | 31 pages | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Arthur James Johnson le 01 nov. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023 | 256 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de John Frederick Glick en tant que directeur le 17 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Dr Margaret Mary Amos en tant qu'administrateur le 10 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022 | 260 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nomination de Stuart Michael Brightman en tant qu'administrateur le 03 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Highdown House Yeoman Way West Sussex BN99 3HH England à Highdown House Yeoman Way West Sussex BN99 3HH | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Equiniti Limited Aspect House, Spencer Road the Causeway Worthing West Sussex BN99 6DA United Kingdom à Highdown House Yeoman Way West Sussex BN99 3HH | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 5 Hanover Square London W1S 1HQ England à 5th Floor 30 Panton Street London SW1Y 4AJ le 24 juin 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2021 | 236 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Ms Paula Harris en tant qu'administrateur le 20 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Hugh Hunting en tant que directeur le 20 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Inscription de la charge 009745680014, créée le 07 févr. 2022 | 65 pages | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2020 | 220 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de HUNTING PLC ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLEY, David Benjamin, Dr | Secrétaire | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | 174160750001 | |||||||
AMOS, Margaret Mary, Dr | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United Kingdom | British | Accountant | 317934600001 | ||||
BRIGHTMAN, Stuart Michael | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United States | American | Director | 303818230001 | ||||
CHESNEY, Ellen Carol | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United Kingdom | American | Director | 245763660001 | ||||
FERGUSON, Bruce Hill | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | Scotland | British | Finance Director | 268910010001 | ||||
HARRIS, Paula | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United States | American | Director | 294986830001 | ||||
JOHNSON, Arthur James | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United States | American | Chief Executive | 75507380003 | ||||
KRAJICEK, Catherine Lee | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United States | American | Director | 213188620001 | ||||
LOUGH, Keith Geddes | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United Kingdom | British | Director | 101630860001 | ||||
CLARK, Dennis Leslie | Secrétaire | Green Hollow 4 Camden Park Road BR7 5HG Chislehurst Kent | British | 1261970001 | ||||||
ROSE, Peter | Secrétaire | Cockspur Street SW1Y 5BQ London 3 England | British | Accountant | 44786670001 | |||||
BARR, David Heckman | Administrateur | Cockspur Street SW1Y 5BW London 3 England | England | Us Citizen | Director | 156764430001 | ||||
BAY, Annell Russell | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United States | American | Director | 194628800002 | ||||
BENSLY, Bernard Robert | Administrateur | Rathgale South Road Hale WA14 3HT Altrincham Cheshire | British | Non-Executive Director | 810940003 | |||||
BROWN, Austen Patrick, Sir | Administrateur | Great House Cottage Hambledon Road GU8 4DR Hambledon Godalming | British | Director | 58782860001 | |||||
CLARK, Dennis Leslie | Administrateur | 3 Cockspur Street SW1Y 5BQ London | United Kingdom | British | Finance Director | 1261970004 | ||||
FRYER, Alan Richmond | Administrateur | Hampton Barn Snitterfield Road CV35 8AU Hampton Lucy Warwickshire | British | Company Director | 9290001 | |||||
GLICK, John Frederick | Administrateur | 30 Panton Street SW1Y 4AJ London 5th Floor England | United States | American | Chairman | 194629920003 | ||||
GOMKE, Terry William | Administrateur | 315 Parkvalley Drive Se Calgary Alberta T2j 4v2 Canada | Canadian | Director | 71060430001 | |||||
GRIEVSON, Thomas Lloyd | Administrateur | Oxleaze Thornborough Road Nash MK17 0ET Milton Keynes Buckinghamshire | British | Director | 33786860001 | |||||
HELLAND, George Archibald | Administrateur | Cockspur Street SW1Y 5BQ London 3 England | American | Consultant | 78221670002 | |||||
HOFMEISTER, John Daniel | Administrateur | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United States | American | Director | 140543270001 | ||||
HUNTING, Lindsay Clive | Administrateur | April Cottage Alderbourne Fulmer SL3 6JB Slough Berkshire | British | Director | 35560320001 | |||||
HUNTING, Richard Hugh | Administrateur | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | Director | 19556470001 | ||||
MCFADYEN, Hector John | Administrateur | 3411 8a Street Sw Calgary Alberta T2t 3b3 Canada | Canadian | Business Executive | 84186660001 | |||||
MILLER, Kenneth William | Administrateur | South Cottage The Street Compton GU3 1EB Guildford Surrey | United Kingdom | British | Deputy Chairman | 1261980001 | ||||
NICHOLAS, John Edward | Administrateur | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | Director | 41940050004 | ||||
PATERSON, Iain Stayton | Administrateur | Court Farm House Church Road Overton RG25 3HF Basingstoke Hampshire | England | British | Director | 12566780001 | ||||
PROCTOR, Dennis Lee | Administrateur | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United States, Texas | Us Citizen | Chief Executive | 70643240004 | ||||
ROSE, Peter | Administrateur | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United Kingdom | British | Accountant | 44786670001 | ||||
SZESCILA, Andrew John | Administrateur | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United States | Us Citizen | Director | 163449220001 | ||||
TRANT, Richard, Sir | Administrateur | 5 Exeter House Putney Heath SW15 3SU London | British | Director | 12388320001 | |||||
TREACHER, Roy Ernest | Administrateur | Cobbetts Burnt Oak Road High Hurstwood TN22 4AE Uckfield East Sussex | British | Company Director | 5732990001 | |||||
WATERSTONE, David George Stuart | Administrateur | 1 Prior Park Buildings Prior Park Road BA2 4NP Bath | England | British | Director | 52485170002 | ||||
WHYSALL, Roger James | Administrateur | Lime House Lime Street MK46 5BA Olney Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 112096580001 |
HUNTING PLC a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 16 oct. 2024 Livré le 21 oct. 2024 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 07 févr. 2022 Livré le 08 févr. 2022 | En cours | ||
Brève description Trade mark with registration number UK00001544079. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 august 1991 | Créé le 07 mai 2004 Livré le 22 mai 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 25 août 1987 Livré le 05 sept. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company and/or new england developments limited to friesch-groningsche hypotheebank nv. | |
Brèves mentions Leasehold 29 and 30 st james's street and 25, 26 and 27 bury street title no ngl 423610. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 08 avr. 1987 Livré le 08 avr. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the and/or fgh finance limited company to the chargee pursuant ato a facility letter dated 20/1/87 on any account whatsoever. | |
Brèves mentions L/H 29/30 st jame's street and 25, 26 and 27 bury street title no. Ngl 423610. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 17 févr. 1987 Livré le 17 févr. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 22 janv. 1987 Livré le 22 janv. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 21 janv. 1987 Livré le 27 janv. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or fgh finance limited and pursuant to a facility letter dated 20.1.87. to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions L/H property comprised in a lease dated 5.3.82 & made between H.M. the queen (1) the crown estate commissioners (2) sowant investments limited (3) and known as 29/30 st. James's street and 25, 26 and 27 bury street title no. Ngl 423610. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 10 juil. 1985 Livré le 17 juil. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti Securing £10,000,000 due from the company and/or new england properties PLC to the chargee pursuant to the principal deed dated 30TH may 1984 and deeds supplemental thereto. | |
Brèves mentions Numbers 29 and 30 st james's street and 28 to 27 bury street london S.W.1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 30 mai 1984 Livré le 15 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or new england properties PLC to the chargee not exceeding £8,500,000 under the terms of an agreement dated 30/5/84 | |
Brèves mentions L/H land and buildings 29 and 30 st. James's street and 25, 26 and 27 bury street london demised by a lease dated 5 march 19829 title no. Ngl 423610. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 15 févr. 1984 Livré le 23 févr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land at junction of plaintree cres. Poplar way & felthambrook way, feltham hounslow, middx tn ngl 475949. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 23 mai 1983 Livré le 08 juin 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti £6,525,000 due or to become due from the company and charles booth public limited company to the chargee. | |
Brèves mentions L/H land in the city of westminster together with buildings erected thereon and k/a 29 & 30 st james's st. & 25, 26, 27 bury st london SW9 t n ngl 423610. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 22 oct. 1982 Livré le 26 oct. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and charles booth public limited company to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions L/H land in westminster together with 29 & 30 st.james st and 25, 26 & 27 bury st london see doc M42 for details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Pledge agreement | Créé le 08 juin 1977 Livré le 29 juin 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the westfield shipping company LTD. To the chargee under the terms of a conditional sale agreement dated 8TH june 1977 | |
Brèves mentions The initially pledged shares being £10,000 ordinary shares of £1 each of westfield beneficially owned by the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0