HUNTING PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUNTING PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00974568
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUNTING PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HUNTING PLC ?

    Adresse du siège social
    5th Floor 30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUNTING PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HUNTING GIBSON PLC22 déc. 198822 déc. 1988
    HUNTING GROUP PLC12 août 198512 août 1985
    HUNTING GIBSON P.L.C.13 mars 197013 mars 1970

    Quels sont les derniers comptes de HUNTING PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUNTING PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au27 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HUNTING PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Modification des coordonnées du secrétaire David Benjamin Willey le 03 avr. 2013

    1 pagesCH03

    Nomination de Catherine Lee Krajicek en tant qu'administrateur le 03 mars 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Annell Russell Bay en tant que directeur le 01 févr. 2025

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 009745680015, créée le 16 oct. 2024

    31 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Arthur James Johnson le 01 nov. 2023

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023

    256 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Re: authorisation for the directors to call a general meeting of the company, other than an agm, on not less than 14 clear days' notice. 17/04/2024
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Cessation de la nomination de John Frederick Glick en tant que directeur le 17 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Margaret Mary Amos en tant qu'administrateur le 10 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022

    260 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Nomination de Stuart Michael Brightman en tant qu'administrateur le 03 janv. 2023

    2 pagesAP01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Highdown House Yeoman Way West Sussex BN99 3HH England à Highdown House Yeoman Way West Sussex BN99 3HH

    1 pagesAD02

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Equiniti Limited Aspect House, Spencer Road the Causeway Worthing West Sussex BN99 6DA United Kingdom à Highdown House Yeoman Way West Sussex BN99 3HH

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 5 Hanover Square London W1S 1HQ England à 5th Floor 30 Panton Street London SW1Y 4AJ le 24 juin 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2021

    236 pagesAA

    Nomination de Ms Paula Harris en tant qu'administrateur le 20 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Hugh Hunting en tant que directeur le 20 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 009745680014, créée le 07 févr. 2022

    65 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2020

    220 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HUNTING PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLEY, David Benjamin, Dr
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Secrétaire
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    174160750001
    AMOS, Margaret Mary, Dr
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishAccountant317934600001
    BRIGHTMAN, Stuart Michael
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United StatesAmericanDirector303818230001
    CHESNEY, Ellen Carol
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United KingdomAmericanDirector245763660001
    FERGUSON, Bruce Hill
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    ScotlandBritishFinance Director268910010001
    HARRIS, Paula
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United StatesAmericanDirector294986830001
    JOHNSON, Arthur James
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United StatesAmericanChief Executive75507380003
    KRAJICEK, Catherine Lee
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United StatesAmericanDirector213188620001
    LOUGH, Keith Geddes
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishDirector101630860001
    CLARK, Dennis Leslie
    Green Hollow
    4 Camden Park Road
    BR7 5HG Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    Green Hollow
    4 Camden Park Road
    BR7 5HG Chislehurst
    Kent
    British1261970001
    ROSE, Peter
    Cockspur Street
    SW1Y 5BQ London
    3
    England
    Secrétaire
    Cockspur Street
    SW1Y 5BQ London
    3
    England
    BritishAccountant44786670001
    BARR, David Heckman
    Cockspur Street
    SW1Y 5BW London
    3
    England
    Administrateur
    Cockspur Street
    SW1Y 5BW London
    3
    England
    EnglandUs CitizenDirector156764430001
    BAY, Annell Russell
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United StatesAmericanDirector194628800002
    BENSLY, Bernard Robert
    Rathgale South Road
    Hale
    WA14 3HT Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Rathgale South Road
    Hale
    WA14 3HT Altrincham
    Cheshire
    BritishNon-Executive Director810940003
    BROWN, Austen Patrick, Sir
    Great House Cottage
    Hambledon Road
    GU8 4DR Hambledon
    Godalming
    Administrateur
    Great House Cottage
    Hambledon Road
    GU8 4DR Hambledon
    Godalming
    BritishDirector58782860001
    CLARK, Dennis Leslie
    3 Cockspur Street
    SW1Y 5BQ London
    Administrateur
    3 Cockspur Street
    SW1Y 5BQ London
    United KingdomBritishFinance Director1261970004
    FRYER, Alan Richmond
    Hampton Barn
    Snitterfield Road
    CV35 8AU Hampton Lucy
    Warwickshire
    Administrateur
    Hampton Barn
    Snitterfield Road
    CV35 8AU Hampton Lucy
    Warwickshire
    BritishCompany Director9290001
    GLICK, John Frederick
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    30 Panton Street
    SW1Y 4AJ London
    5th Floor
    England
    United StatesAmericanChairman194629920003
    GOMKE, Terry William
    315 Parkvalley Drive Se
    Calgary
    Alberta T2j 4v2
    Canada
    Administrateur
    315 Parkvalley Drive Se
    Calgary
    Alberta T2j 4v2
    Canada
    CanadianDirector71060430001
    GRIEVSON, Thomas Lloyd
    Oxleaze Thornborough Road
    Nash
    MK17 0ET Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oxleaze Thornborough Road
    Nash
    MK17 0ET Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector33786860001
    HELLAND, George Archibald
    Cockspur Street
    SW1Y 5BQ London
    3
    England
    Administrateur
    Cockspur Street
    SW1Y 5BQ London
    3
    England
    AmericanConsultant78221670002
    HOFMEISTER, John Daniel
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United StatesAmericanDirector140543270001
    HUNTING, Lindsay Clive
    April Cottage Alderbourne
    Fulmer
    SL3 6JB Slough
    Berkshire
    Administrateur
    April Cottage Alderbourne
    Fulmer
    SL3 6JB Slough
    Berkshire
    BritishDirector35560320001
    HUNTING, Richard Hugh
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritishDirector19556470001
    MCFADYEN, Hector John
    3411 8a Street Sw
    Calgary
    Alberta T2t 3b3
    Canada
    Administrateur
    3411 8a Street Sw
    Calgary
    Alberta T2t 3b3
    Canada
    CanadianBusiness Executive84186660001
    MILLER, Kenneth William
    South Cottage The Street
    Compton
    GU3 1EB Guildford
    Surrey
    Administrateur
    South Cottage The Street
    Compton
    GU3 1EB Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDeputy Chairman1261980001
    NICHOLAS, John Edward
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritishDirector41940050004
    PATERSON, Iain Stayton
    Court Farm House Church Road
    Overton
    RG25 3HF Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Court Farm House Church Road
    Overton
    RG25 3HF Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishDirector12566780001
    PROCTOR, Dennis Lee
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United States, TexasUs CitizenChief Executive70643240004
    ROSE, Peter
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritishAccountant44786670001
    SZESCILA, Andrew John
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United StatesUs CitizenDirector163449220001
    TRANT, Richard, Sir
    5 Exeter House
    Putney Heath
    SW15 3SU London
    Administrateur
    5 Exeter House
    Putney Heath
    SW15 3SU London
    BritishDirector12388320001
    TREACHER, Roy Ernest
    Cobbetts Burnt Oak Road
    High Hurstwood
    TN22 4AE Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Cobbetts Burnt Oak Road
    High Hurstwood
    TN22 4AE Uckfield
    East Sussex
    BritishCompany Director5732990001
    WATERSTONE, David George Stuart
    1 Prior Park Buildings
    Prior Park Road
    BA2 4NP Bath
    Administrateur
    1 Prior Park Buildings
    Prior Park Road
    BA2 4NP Bath
    EnglandBritishDirector52485170002
    WHYSALL, Roger James
    Lime House
    Lime Street
    MK46 5BA Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Lime House
    Lime Street
    MK46 5BA Olney
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector112096580001

    HUNTING PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 oct. 2024
    Livré le 21 oct. 2024
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 21 oct. 2024Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 07 févr. 2022
    Livré le 08 févr. 2022
    En cours
    Brève description
    Trade mark with registration number UK00001544079.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 08 févr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 august 1991
    Créé le 07 mai 2004
    Livré le 22 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1987
    Livré le 05 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company and/or new england developments limited to friesch-groningsche hypotheebank nv.
    Brèves mentions
    Leasehold 29 and 30 st james's street and 25, 26 and 27 bury street title no ngl 423610.
    Personnes ayant droit
    • Friesch-Groningsche Hypotheebank Nv.
    Transactions
    • 05 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 21 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 1987
    Livré le 08 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the and/or fgh finance limited company to the chargee pursuant ato a facility letter dated 20/1/87 on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    L/H 29/30 st jame's street and 25, 26 and 27 bury street title no. Ngl 423610.
    Personnes ayant droit
    • Friesch-Groninsche Hypotheek Bank N.V.
    Transactions
    • 08 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 févr. 1987
    Livré le 17 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 22 janv. 1987
    Livré le 22 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 janv. 1987
    Livré le 27 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or fgh finance limited and pursuant to a facility letter dated 20.1.87. to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    L/H property comprised in a lease dated 5.3.82 & made between H.M. the queen (1) the crown estate commissioners (2) sowant investments limited (3) and known as 29/30 st. James's street and 25, 26 and 27 bury street title no. Ngl 423610.
    Personnes ayant droit
    • Friesch-Groninsche Hypotheek Bank N.V.
    Transactions
    • 27 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 21 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juil. 1985
    Livré le 17 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £10,000,000 due from the company and/or new england properties PLC to the chargee pursuant to the principal deed dated 30TH may 1984 and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    Numbers 29 and 30 st james's street and 28 to 27 bury street london S.W.1.
    Personnes ayant droit
    • F.G.H. Finance Limited
    Transactions
    • 17 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 mai 1984
    Livré le 15 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or new england properties PLC to the chargee not exceeding £8,500,000 under the terms of an agreement dated 30/5/84
    Brèves mentions
    L/H land and buildings 29 and 30 st. James's street and 25, 26 and 27 bury street london demised by a lease dated 5 march 19829 title no. Ngl 423610.
    Personnes ayant droit
    • Fgh Finance Limited
    Transactions
    • 15 juin 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 15 févr. 1984
    Livré le 23 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at junction of plaintree cres. Poplar way & felthambrook way, feltham hounslow, middx tn ngl 475949.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 23 mai 1983
    Livré le 08 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £6,525,000 due or to become due from the company and charles booth public limited company to the chargee.
    Brèves mentions
    L/H land in the city of westminster together with buildings erected thereon and k/a 29 & 30 st james's st. & 25, 26, 27 bury st london SW9 t n ngl 423610.
    Personnes ayant droit
    • Fgh Finance Limited
    Transactions
    • 08 juin 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 oct. 1982
    Livré le 26 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and charles booth public limited company to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    L/H land in westminster together with 29 & 30 st.james st and 25, 26 & 27 bury st london see doc M42 for details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    Pledge agreement
    Créé le 08 juin 1977
    Livré le 29 juin 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the westfield shipping company LTD. To the chargee under the terms of a conditional sale agreement dated 8TH june 1977
    Brèves mentions
    The initially pledged shares being £10,000 ordinary shares of £1 each of westfield beneficially owned by the company.
    Personnes ayant droit
    • Thamesfield Shipping Company LTD
    Transactions
    • 29 juin 1977Enregistrement d'une charge
    • 30 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0