DAVID CONRAD (SALES) LIMITED

DAVID CONRAD (SALES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDAVID CONRAD (SALES) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00975554
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 nov. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    6 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2015

    État du capital au 11 juin 2015

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2014

    10 pagesAA

    Nomination de Mr Scott Richard Mccabe en tant qu'administrateur le 19 août 2014

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Sheffield United Fc Bramall Lane Sheffield Yorkshire S2 4SU à Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ le 19 août 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Malachy Brannigan en tant que directeur le 19 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Malachy Brannigan en tant qu'administrateur le 08 août 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Burns en tant que directeur le 08 août 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juin 2014

    État du capital au 19 juin 2014

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Nomination de Esplanade Director Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Craig Burns en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Esplanade Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Craig Burns en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Julian Winter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    7 pagesAA

    Nomination de Craig Burns en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish151895310001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6133267
    123430390001
    BURNS, Craig
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Secrétaire
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    167993930001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Secrétaire
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    British118147580002
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    HARROP, David
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Secrétaire
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    153054090001
    LIGHTBURN, Trevor
    75 Grosvenor Avenue
    Hartford
    CW8 1RP Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    75 Grosvenor Avenue
    Hartford
    CW8 1RP Northwich
    Cheshire
    British27731500001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    WHETTON, Barry Newton
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    Secrétaire
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    British14277000002
    BAMFORD, Alan Maxwell
    53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GY Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GY Sheffield
    South Yorkshire
    British82114720001
    BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish2883500001
    BIRCH, Trevor
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Administrateur
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    UkBritish160667800001
    BRANNIGAN, Malachy
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Administrateur
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandIrish110939170001
    BURNS, Craig
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Administrateur
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish167991320001
    CAPPER, David
    5 Wychwood Glen
    Sothall
    S20 2QL Sheffield
    Administrateur
    5 Wychwood Glen
    Sothall
    S20 2QL Sheffield
    British61833820001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Administrateur
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish118147580002
    EDELSON, John Michael
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    Administrateur
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    EnglandBritish28353840001
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    GREEN, Charles Alexander
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    Administrateur
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    British75952680002
    HARROP, David Anthony
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Administrateur
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish160187290001
    HAWTHORNE, Philip
    11 Avondale Road
    Swinley
    WN1 2BE Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    11 Avondale Road
    Swinley
    WN1 2BE Wigan
    Lancashire
    British79740350001
    LYONS, Jonathan Howard
    The Gables
    Rossmill Lane
    WA15 0AH Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    The Gables
    Rossmill Lane
    WA15 0AH Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish12396450001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Administrateur
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Administrateur
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MCDONALD, Anthony Michael
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    British51141710003
    ROBINSON, Terence James
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    Administrateur
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    EnglandBritish107314140001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Administrateur
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish111427410006
    THURMAN, John Lythall
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    British41580370003
    TOWNSEND, Ian
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    Administrateur
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    United KingdomBritish26617400002
    WHETTON, Barry Newton
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    Administrateur
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    British14277000002
    WINTER, Julian
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Administrateur
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish163637880001
    WOOD, Peter Philip
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    British59507480001

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 juil. 1997
    Livré le 29 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 juin 1992
    Livré le 24 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Argent Credit Corporation PLC
    Transactions
    • 24 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Group cross guarantee industry and debenture.
    Créé le 19 déc. 1990
    Livré le 04 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
    Transactions
    • 04 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 29 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 27 juil. 1990
    Livré le 08 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 11 déc. 1981
    Livré le 18 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A fixed charge over all book & other debts and fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts except above uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1981Enregistrement d'une charge

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 nov. 2015Commencement of winding up
    17 août 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0