CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00981659
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RENTCO NATIONWIDE LIMITED09 juin 197009 juin 1970

    Quels sont les derniers comptes de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Divers

    Form AD03/historic register/members
    2 pagesMISC

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de , 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT à 1 More London Place London SE1 2AF le 12 janv. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 déc. 2017

    LRESSP

    Notification de Ge Ese Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 28 déc. 2017

    2 pagesPSC09

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Joseph Preston Swithenbank en tant que directeur le 11 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Campbell Smith en tant que directeur le 14 juin 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Jonathan Lawrence John Gatt en tant qu'administrateur le 30 mars 2017

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Deuxième dépôt pour la nomination de Neil Smith en tant qu'administrateur

    6 pagesRP04AP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Joseph Preston Swithenbank le 31 août 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Joseph Preston Swithenbank le 31 août 2016

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 04 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of captial redemption reserve 19/02/2016
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomMaltese228824220001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secrétaire
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secrétaire
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Administrateur
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Administrateur
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Administrateur
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Administrateur
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    Administrateur
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    EnglandBritish79328330001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Administrateur
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Administrateur
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Administrateur
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790002
    FREDHOLM, James William
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    Administrateur
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    American33092100001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Administrateur
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Administrateur
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Administrateur
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Administrateur
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Administrateur
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Administrateur
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Administrateur
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomUs Citizen183236480004
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1329406
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    31 oct. 201601 déc. 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 juil. 1996
    Livré le 30 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 30 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 14 août 1995
    Livré le 01 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease agreement dated 29TH december 1989 (as defined),as amended by supplemental agreements dated 31ST december 1991 and 14TH august 1995
    Brèves mentions
    The trailers as described in the attached schedule with all accessories,components,parts......etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trinity (Jersey) Limited
    Transactions
    • 01 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 mars 1994
    Livré le 21 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13TH february 1994) on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 21 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 30 sept. 1988
    Livré le 19 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the first agreements of various dates
    Brèves mentions
    All the company's right title & interest in the monies then or thereafterpayable to the company by the sub-leases pursuant to the terms of the sub-lease agreements.
    Personnes ayant droit
    • Mdfc Industrial Finance Limtied.
    Transactions
    • 19 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 21 juil. 1988
    Livré le 11 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sub lease agreements (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Svenska Finans (UK) Limited.
    Transactions
    • 11 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 28 juin 1988
    Livré le 18 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of the first agreements and under the terms of the c harge.
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sublease agreements (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Ball Leasing Limited.
    Transactions
    • 18 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 1988
    Livré le 07 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 3 badminton court church street amersham buckinghamshire title no. Bm 86544.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 22 févr. 1988
    Livré le 25 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms or by virtue of all conditional sale, hire purchase leas ing and/or bailment contracts under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in and to all agreements entered into or to be entered into by the company with third parties (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific Eurofinance Inc
    Transactions
    • 25 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 1988
    Livré le 25 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents of even date
    Brèves mentions
    Floating charge all its undertaking and all property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific Eurofinance, Inc.
    Transactions
    • 25 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 déc. 1987
    Livré le 12 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Any agreement entered into whether before on or after the date hereof b etween the company and a person to whom the company lets or agrees to let goods. (For full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Midland Mortgage Leasing Limited
    Transactions
    • 12 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 déc. 2017Commencement of winding up
    10 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0