REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED

REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00986376
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gotham Road
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Leicestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WIRELINE INVESTMENTS LIMITED01 avr. 199401 avr. 1994
    BPB INSTRUMENTS INTERNATIONAL LIMITED24 mars 198624 mars 1986
    ISLE OF ELY PAPER SACKS LIMITED07 août 197007 août 1970

    Quels sont les derniers comptes de REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination de Mr Neil Alexander Macleod en tant qu'administrateur le 28 août 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Jones en tant que directeur le 28 août 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juil. 2014

    État du capital au 10 juil. 2014

    • Capital: GBP 10,007,490
    SH01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Nomination de Ms Julie Mary Thomson en tant qu'administrateur le 27 août 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Gemma Rose-Garvie en tant que secrétaire le 27 août 2013

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Brian Moncur en tant que secrétaire le 27 août 2013

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Brian Moncur en tant que directeur le 05 août 2013

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Euan Robertson Prentice en tant qu'administrateur le 04 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Gray Fulton en tant que directeur le 04 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Jones le 22 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William Gray Fulton le 22 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Brian Moncur le 22 juin 2011

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de Gotham Road East Leake Loughborough Leicestershire LE12 6JX le 16 mai 2011

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROSE-GARVIE, Gemma
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    180875850001
    MACLEOD, Neil Alexander
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    Administrateur
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    ScotlandBritish177581770001
    PRENTICE, Euan Robertson
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Administrateur
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    ScotlandBritish168927430001
    THOMSON, Julie Mary
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    ScotlandBritish171856740001
    ATKIN, James Reginald
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    British55311660001
    ATKIN, James Reginald
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    British55311660001
    FULTON, William Gray
    2
    Lawson Drive Dyce
    AB21 0DR Aberdeen
    Weatherford House
    United Kingdom
    Secrétaire
    2
    Lawson Drive Dyce
    AB21 0DR Aberdeen
    Weatherford House
    United Kingdom
    British138793410001
    HYDE, Robin Anthony
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    British14363830002
    MONCUR, Brian
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    146420320001
    WROOT, Richard Wilson
    25 Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    Secrétaire
    25 Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    British73604700002
    BECKETT, Michael Ernest
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    Administrateur
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    British118661100001
    BOYES, John Stewart
    Cosford Hall Farm
    Cosford
    CV21 1HT Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    Cosford Hall Farm
    Cosford
    CV21 1HT Rugby
    Warwickshire
    UkBritish10479120001
    FULTON, William Gray
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139048390001
    HYDE, Robin Anthony
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    British14363830002
    JONES, Ian
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish57632040002
    MARTIN, Burt Michael
    4817 Welford
    77401 Bellaire
    Texas
    Administrateur
    4817 Welford
    77401 Bellaire
    Texas
    United States74615750001
    MCNULTY, Michael Joseph
    1121 Wentworth View S.W.
    Calgary
    Alberta
    T3h 5k3
    Canada
    Administrateur
    1121 Wentworth View S.W.
    Calgary
    Alberta
    T3h 5k3
    Canada
    Canadian100108550001
    MONCUR, Brian
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish118915490001
    REEVES, Donald Richard
    Lindum House Grantham Road
    Whatton
    NG13 9EU Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Lindum House Grantham Road
    Whatton
    NG13 9EU Nottingham
    Nottinghamshire
    British14037750001
    SPENCER, Michael Charles
    Cleeve House
    Melton Road Hickling Pastures
    LE14 3QG Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Cleeve House
    Melton Road Hickling Pastures
    LE14 3QG Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish14363850002
    SYDNEY-SMITH, Peter Edward
    Laundry House Laundry Lane
    Heckfield
    RG27 0LF Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Laundry House Laundry Lane
    Heckfield
    RG27 0LF Basingstoke
    Hampshire
    British13962530002
    WHATMOUGH, Michael John
    41 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    41 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    British13032520001

    REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 déc. 1998
    Livré le 06 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 11 juil. 1995
    Livré le 28 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including (without limitation) pursuant to the facilities agreement
    Brèves mentions
    The company as security for the obligations assigns mortgages charges hypoothecates and pladges to the bank the shares. The charge provides that the pledged shares shall include any substitution therefor, additions thereto or proceeds thereof, arising out of any consolidation, subdivision, reclassification, stock dividend or similar increase or decrease in or alteration of the capital of the issuer of thepledged shares (the "issuer") or any other event.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 28 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 11 juil. 1995
    Livré le 21 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever including but not limited to under the facilities agreement dated 11TH july 1995
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 21 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 sept. 2014Commencement of winding up
    13 avr. 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ewen R. Alexander
    Bishops Court 29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Aberdeenshire
    practitioner
    Bishops Court 29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Aberdeenshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0