WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED

WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00989348
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED ?

    • Extraction de gaz naturel (06200) / Exploitation de mines et carrières

    Où se situe WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROC OIL (CEL) LTD21 juil. 199921 juil. 1999
    CAMBRIAN EXPLORATION LIMITED15 sept. 197015 sept. 1970

    Quels sont les derniers comptes de WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Building 3 Chiswick Business Park 566 Chiswick High Road London W4 5YA à Fairview House Victoria Place Carlisle Cumbria CA1 1HP le 25 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 janv. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration de confirmation établie le 26 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 oct. 2015

    État du capital au 26 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,220,824
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 nov. 2014

    État du capital au 21 nov. 2014

    • Capital: GBP 1,220,824
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Nomination de Mr Peter Gordon Adams en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Fraser Ashman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 oct. 2013

    État du capital au 29 oct. 2013

    • Capital: GBP 1,220,824
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Nomination de Mr Helmut Conrad Cordes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Joachim Hobrecker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stephen Dewald en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Nomination de Mr Joachim Hobrecker en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ADAMS, Peter Gordon
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    Secrétaire
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    189076600001
    CORDES, Helmut Conrad
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    Administrateur
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    United KingdomGerman171814320001
    ASHMAN, Fraser Lionel
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    Secrétaire
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    British73535420002
    BUTLER, Neil
    Crop House
    Main Street, Upton
    NG23 5TE Newark
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Crop House
    Main Street, Upton
    NG23 5TE Newark
    Nottinghamshire
    British65804260001
    CAINES, Christine Edith
    15 Millfield Avenue
    Saxilby
    LN1 2QN Lincoln
    Lincolnshire
    Secrétaire
    15 Millfield Avenue
    Saxilby
    LN1 2QN Lincoln
    Lincolnshire
    British85981610001
    COMBES, Michael Patrick
    36 Fairway
    GU1 2XN Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    36 Fairway
    GU1 2XN Guildford
    Surrey
    British102888420001
    CUMMING, Robert Cameron
    6 Carding Hill
    AB41 8BG Ellon
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    6 Carding Hill
    AB41 8BG Ellon
    Aberdeenshire
    British35356450001
    SANDERS, Jan
    Danes Cottage
    Navestock Side
    CM14 5SE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Danes Cottage
    Navestock Side
    CM14 5SE Brentwood
    Essex
    British98651250001
    STEVENSON, Rosalind Jane
    58 Pump Hollow Lane
    Forest Town
    NG19 0AS Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    58 Pump Hollow Lane
    Forest Town
    NG19 0AS Mansfield
    Nottinghamshire
    British65556130001
    ATKINSON, John Paul
    The Orangery
    Burton
    LN1 2RD Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Orangery
    Burton
    LN1 2RD Lincoln
    Lincolnshire
    British64084360001
    BAINES, Edgar
    18 Winnowsty Lane
    LN2 5RZ Lincoln
    Administrateur
    18 Winnowsty Lane
    LN2 5RZ Lincoln
    British68877560002
    BRAATEN, Peter Alfred
    4 Fair Fields
    Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    Administrateur
    4 Fair Fields
    Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    Canadian30784310002
    BUTLER, Neil
    Crop House
    Main Street, Upton
    NG23 5TE Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Crop House
    Main Street, Upton
    NG23 5TE Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish65804260001
    COLBURNE, Stewart Ancil
    24 Vardell Place Nw
    T3A 0BD Calgary
    Canada
    Administrateur
    24 Vardell Place Nw
    T3A 0BD Calgary
    Canada
    British48097870001
    DEBONI, Walter
    127 Oakside Close
    T2V 4T9 Calgary
    Alberta
    Canada
    Administrateur
    127 Oakside Close
    T2V 4T9 Calgary
    Alberta
    Canada
    CanadaCanadian43590580001
    DEWALD, Stephen, Dr
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    Administrateur
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    GermanyGerman135676420001
    DORAN, John, Dr
    30 Cranbrook Road
    Bellevue Hill
    New South Wales
    2023
    Australia
    Administrateur
    30 Cranbrook Road
    Bellevue Hill
    New South Wales
    2023
    Australia
    British65503190003
    GIBSON SMITH, Christopher Shaw, Dr
    Lansdowne
    White Lane
    GU4 8PR Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Lansdowne
    White Lane
    GU4 8PR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish76355430001
    HOBRECKER, Joachim
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    Administrateur
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    United KingdomGerman156428510001
    KLINGENBERGER, Peter, Dr
    37 A Zum Berggarten
    Kassel
    34130
    Germany
    Administrateur
    37 A Zum Berggarten
    Kassel
    34130
    Germany
    German102888350002
    LEHMANN, Thomas
    8a Park Road
    Twickenham
    TW1 2PX Middx
    Tw1 2px
    Administrateur
    8a Park Road
    Twickenham
    TW1 2PX Middx
    Tw1 2px
    German102888260002
    LUNDIN, Ian
    Jadaf Shipyard
    PO BOX 9211 Dubai
    United Arab Emigrants
    Administrateur
    Jadaf Shipyard
    PO BOX 9211 Dubai
    United Arab Emigrants
    Swedish58813850001
    MCCUE, Nigel Robert
    PO BOX 9211
    Dubai
    FOREIGN United Arab Emirates
    Administrateur
    PO BOX 9211
    Dubai
    FOREIGN United Arab Emirates
    British35135170001
    MORRIS, Robin Dale
    Netherton Of Glenboig Farm
    Fintry
    G63 0YH Stirlingshire
    Administrateur
    Netherton Of Glenboig Farm
    Fintry
    G63 0YH Stirlingshire
    UkBritish34878230001
    STEVENSON, Rosalind Jane
    58 Pump Hollow Lane
    Forest Town
    NG19 0AS Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    58 Pump Hollow Lane
    Forest Town
    NG19 0AS Mansfield
    Nottinghamshire
    British65556130001
    TAUCHNITZ, Frank, Dr
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    Administrateur
    Building 3
    Chiswick Business Park
    W4 5YA 566 Chiswick High Road
    London
    EnglandGerman135521180002
    VAN DEN BRINK, Giksbertus Wilhelmus
    4 Tring Avenue
    Ealing
    W5 3QA London
    Administrateur
    4 Tring Avenue
    Ealing
    W5 3QA London
    Dutch119737090001
    WOOD, David Anthony, Dr
    25 Badgers Oak
    Bassingham
    LN5 9JP Lincoln
    Administrateur
    25 Badgers Oak
    Bassingham
    LN5 9JP Lincoln
    EnglandBritish35340490002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Russian Federation
    Federal Agency For State Property Mangement
    Nikolskaya Lane, 9
    Moscow
    C/O
    Russia
    06 avr. 2016
    Federal Agency For State Property Mangement
    Nikolskaya Lane, 9
    Moscow
    C/O
    Russia
    Non
    Forme juridiqueGovernment Department
    Autorité légaleRussian
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental debenture supplemental to an original guarantee and debenture referred to in the restated credit agreement dated 14 july 1993 as amended and restated by a deed of amendment of guarantee and debenture dated 4 july 1997
    Créé le 31 janv. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the agent, the arranger, the banks and the swap bank (or any of them) under each of the finance documents (as defined) to which such obligor is a party together with all costs charges and expenses incurred by the agent, the arranger or any bank in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture dated 14TH july 1993 as amended and restated by a deed of amendment of guarantee and debenture between mmrl (UK) limited, cambrian exploration limited, candecca resources limited and barclays bank PLC as agent and trustee (the agent) for itself and each bank (as defined)
    Créé le 04 juil. 1997
    Livré le 25 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the agent, the arranger, the banks and the swap bank (or any of them) under each of the finance documents (as defined) to which such obligor is a party together with all costs charges and expenses incurred by the agent, the arranger or any bank in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 14 juil. 1993
    Livré le 30 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Secured guarantee
    Créé le 15 juin 1982
    Livré le 19 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from candecca resources PLC under the terms of the facility letter dated 28.5.82
    Brèves mentions
    All bookdebts & other debts now & from time to time owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • First National Bank in Dallas
    Transactions
    • 19 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Operating agreement
    Créé le 07 déc. 1977
    Livré le 28 déc. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All rights & interests of the company under the licences referred to in the operating agreement with all equipment & materials acquired under the operating agreement (see doc M35).
    Personnes ayant droit
    • Carless Exploration Limited
    • Marinex Petroleum Limited
    • Hudson Oil UK Onshore Limited
    Transactions
    • 28 déc. 1977Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Operating agreement
    Créé le 07 déc. 1977
    Livré le 28 déc. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All rights & interests of the company under the licences referred to in the operating agreement with all equipment & materials acquired under the operating agreement. (See doc M34).
    Personnes ayant droit
    • Hudson Oil U.K. Onshore LTD.
    • Carless Exploration Limited
    • Marinex Petroleum Limited
    Transactions
    • 28 déc. 1977Enregistrement d'une charge
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 janv. 2017Commencement of winding up
    05 déc. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Christian Kienlen
    3rd Floor 10 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    3rd Floor 10 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    West Yorkshire
    Daryl Warwick
    Armstrong Watson Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria
    practitioner
    Armstrong Watson Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0