CROMWELL LAND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROMWELL LAND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00989850
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROMWELL LAND LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CROMWELL LAND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    12 Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CROMWELL LAND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CROMWELL LAND SECURITIES LIMITED06 déc. 199006 déc. 1990
    CROMWELL LAND SECURITY LIMITED19 nov. 199019 nov. 1990
    CITYLAND PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED15 févr. 198915 févr. 1989
    CITYLAND HOTELS LIMITED22 sept. 197022 sept. 1970

    Quels sont les derniers comptes de CROMWELL LAND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CROMWELL LAND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    État du capital au 11 oct. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 févr. 2016

    État du capital au 24 févr. 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 54 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 53 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 52 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Iain Douglas Bond en tant que directeur le 30 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2015

    État du capital au 12 janv. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    20 pagesAA

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Divers

    Aud res sec 519
    1 pagesMISC

    Divers

    Sect 519
    2 pagesMISC

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 janv. 2014

    État du capital au 10 janv. 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    21 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Sharon Kerridge en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CROMWELL LAND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WYLLIE, Alison
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Secrétaire
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    British107811220001
    HUXTABLE, Christopher John
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Banker156351910001
    THORP, Timothy Geoffrey
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    EnglandBritishChartered Accountant66923730003
    BANDEL, Martin Howard
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary37249220002
    COLE, Jennifer
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    Secrétaire
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    British74489480002
    FORSTER, Helen
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    British106129360001
    JENKINSON, Louisa Jane
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    Secrétaire
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    British106060330002
    LYON, Karen
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Secrétaire
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Other140536930001
    MILLER, Philip
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    Secrétaire
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    British121053850001
    POOLE, Rebecca Louise
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    Secrétaire
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    British92013940001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Secrétaire
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    British5463920001
    PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    Secrétaire
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    76827740001
    ALLPORT, Howard Coplestone
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    Administrateur
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    BritishCo Director3356770001
    BANDEL, Martin Howard
    Flat 6
    1/2 Alma Square St Johns Wood
    NW8 9QD London
    Administrateur
    Flat 6
    1/2 Alma Square St Johns Wood
    NW8 9QD London
    BritishChartered Accountant37249220003
    BOND, Iain Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United KingdomBritishProperty Director68687180001
    DESAI, Arunkumar Bhilalbhai
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Administrateur
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    United KingdomBritishGroup Accountant84225840001
    DESAI, Arunkumar Bhilalbhai
    12 Cherry Close
    SM5 2BW Carshalton
    Surrey
    Administrateur
    12 Cherry Close
    SM5 2BW Carshalton
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Accountant84225840001
    EDWARDS, Dylan Crocker
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    Administrateur
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    BritishSurveyor5965630001
    GLEDHILL, Sarah Louise
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant131963100002
    GLOVER, Edward Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishMerchant Banker121380002
    HAYES, Laurence Edwin
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Administrateur
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    United KingdomBritishAccountant192784770001
    HOLBROOK, Carolyn
    5 Croftside
    CO8 5LL Bures St Mary
    Suffolk
    Administrateur
    5 Croftside
    CO8 5LL Bures St Mary
    Suffolk
    United KingdomBritishProperty Management165098780001
    KERRIDGE, Sharon Diana Mandy
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker128267610003
    MOFFAT, Andrew David John
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Administrateur
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    EnglandBritishMerchant Banker34399870003
    RAWLINS, Richard Denis
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    Administrateur
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    United KingdomBritishSurveyor56889050001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Administrateur
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    BritishAccountant5463920001
    SZPIRO, Toby Nicholas Maximilian
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    Administrateur
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    United KingdomBritishCompany Director76573230001
    THORP, Timothy Geoffrey
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant66923730003

    CROMWELL LAND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over bank accounts
    Créé le 21 juin 2011
    Livré le 30 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge the charged balance and charged accounts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transactions
    • 30 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 juin 2011
    Livré le 22 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Raglan court empire way wembley t/n P137078, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transactions
    • 22 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 2011
    Livré le 22 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Flat 8 raglan court empire way wembley t/n NGL782443, flat 19 raglan court empire way wembley t/n NGL782442, flat 20 raglan court empire way wembley t/n NGL782441, for details of further properties charged, please refer to form MG01, together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, the goodwill of any business carried on at the property, the benefit of all licences & registration required in the running of such a business (see image for full details).
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transactions
    • 22 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 juil. 1996
    Livré le 31 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 mars 1996
    Livré le 12 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land situated at 3, 5 and 7 whitegate road and 2, 4 and 6 warrior square, southend on sea t/no. EX171106 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    49 atlanta street, fulham, together with the benefit of all rights licences and covenants affecting the property, fixed charge over all plant and other machinery,fixtures and fittings ,furniture and equipment ,implements and utensils etc... the present and future goodwill of any business carried on at or about the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge.
    Créé le 30 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    6 to 18 tudor court , russell hill. Purley,croydon. London together with all covenants and rightrs affecting or concerning the property , the plant and machinery and fixtures and fittings furniture, equipment implements and utensils, of the company now and in the future at the property ,the present and future goodwill of any business carried on at or about the property. Please see doc for further details,.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge.
    Créé le 30 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 to 66 kensington mansions, trebovir road, kensington and chelsea, together with the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property , all plant and other machinery fixtures and fittings ,furniture equipment ,implements and utensils. The present and future goodwill of any business carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 30 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 to 10A purley parade ,(excluding no .3 ) high street, purley. Fixed charge over all covenants and rights affecting or concerning the property, the plant ,machinery , and fixtures and fittings ,furniture, equipment ,implements utensils,of the company now and in the future at the property. The present and future goodwill of the business carried on at the property .
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 27 sept. 1990
    Livré le 05 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee of evendate.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 12 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1988
    Livré le 30 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    141, finborough road, london SW10. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 30 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 août 1988
    Livré le 16 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    91, bere hill crescent, andover, hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 16 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1988
    Livré le 22 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First and fixed legal charge over property k/as 67 penge road london SE 25.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 22 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 avr. 1988
    Livré le 03 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge 103A westbourne grove london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 03 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 1988
    Livré le 23 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H courtfield rd london SW7 t/no ngl 599654 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Swordheath Properties Limited
    Transactions
    • 23 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 1988
    Livré le 02 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over:- 3 north street, horsham west sussex and,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 02 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 août 1987
    Livré le 04 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 30, downland place, adastral road, canford heath, poole, dorset title no: dt 105678 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 04 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge registered pursuant to a statutory declaration dated 11/9/87
    Créé le 18 août 1987
    Livré le 03 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-69 denmark hill, camberwell, london SE5 T.no:- sgl 279325. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 03 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 mai 1987
    Livré le 09 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    42, finborough rd; london SW10. Floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 09 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 1987
    Livré le 08 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    106 church rd, richmond surrey floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 08 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 janv. 1987
    Livré le 07 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 37, courtfield road, london SW7 title no ngl 455035 inc fixtures fittings plant, machinery, implements,utensils furniture & equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 07 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 août 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat e, angel house, pentonville road, london N1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 juin 1986
    Livré le 28 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property 338 south norwood hill, london SE25 and floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transactions
    • 28 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 janv. 1986
    Livré le 10 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 4, 15 whitworth road, london SE25.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 janv. 1986
    Livré le 10 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    41 ronelean road, folworth r b of kingston upon thames.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0