TEESSIDE SPORTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TEESSIDE SPORTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00993053 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TEESSIDE SPORTS LIMITED ?
Adresse du siège social | 440-450 Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton Northamptonshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TEESSIDE SPORTS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 26 févr. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour TEESSIDE SPORTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Derrick Beacham en tant que secrétaire le 03 févr. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Julia Reynolds en tant que directeur le 03 févr. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant que directeur le 03 févr. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Derrick Beacham en tant que directeur le 03 févr. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Marcello Lombardo en tant que directeur le 16 déc. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant qu'administrateur le 21 nov. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 févr. 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Ms Julia Reynolds en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Mark Derrick Beacham en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Hitt en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 févr. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Mark Derrick Beacham le 01 oct. 2009 | 3 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Marcello Lombardo le 01 oct. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard John Hitt le 01 oct. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 39 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||
Comptes établis au 28 févr. 2009 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TEESSIDE SPORTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEACHAM, Mark Derrick | Secrétaire | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire | British | 135313320001 | ||||||
BENNETT, Terry | Secrétaire | Randolph Avenue W9 1BG London 72d | British | 135196530001 | ||||||
DAWSON, Mary Louise | Secrétaire | 57 Elms Road SW4 9EP London | British | 68983920002 | ||||||
HOLDSWORTH, Cheryl Irene | Secrétaire | 26 Chelveston AL7 2PW Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 48354260001 | ||||||
MURRAY, Philip John | Secrétaire | 44 Hauxley Drive Waldridge Park DH2 3TE Chester Le Street County Durham | British | Group Finance Manager | 79329620001 | |||||
O'KEEFFE, Mark John | Secrétaire | 5 Fowey Close NN8 5WW Wellingborough Northamptonshire | British | Accountant | 57880430001 | |||||
PILLAY, Paul Vijayasingam | Secrétaire | 69 Lilleshall Avenue Monkston MK10 9HU Milton Keynes | Other | Head Of Finance & Company Secr | 79416150001 | |||||
PLANT, William Allan | Secrétaire | 10 The Parks Riverside DH3 3QX Chester Le Street County Durham | British | 87465680001 | ||||||
WILKINSON, John Richard | Secrétaire | Abbey Cottage 1 Elm Lane Well End SL8 5PF Bourne End Buckinghamshire | British | 2545190001 | ||||||
BEACHAM, Mark Derrick | Administrateur | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 160095260001 | ||||
BENTLEY, Simon Anthony | Administrateur | Glen Wood House 5 Cedars Close NW4 1TR London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 3007630001 | ||||
CROSLAND, Roy Nicholson | Administrateur | 35 Addison Avenue W11 4QS London | British | Director | 30882970002 | |||||
FLEMING, Keith | Administrateur | Brookmead House The Warren, East Horsley KT24 5RH Leatherhead Surrey | England | British | Director | 112723440002 | ||||
HALL, Andrew James | Administrateur | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | Finance Director | 30306840002 | ||||
HARDY, Russell Stephen Mons | Administrateur | The Reddings Langley Road, Claverdon CV35 8P Warwick Warwickshire | England | British | Chief Executive | 45844210003 | ||||
HARTLEY, Peter Christopher | Administrateur | 17 Jacobean Lane Knowle B93 9LP Solihull | United Kingdom | British | Finance Director | 96458190001 | ||||
HITT, Richard John | Administrateur | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire | United Kingdom | British | Business Analyst & Insight | 127468180001 | ||||
KNIGHT, Thomas William | Administrateur | 6 Beechfield Road Gosforth NE3 4DR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Director | 11423040005 | |||||
LAURELS, David Andrew Gordon | Administrateur | The Laurels Main Street Wysall NG12 5QS Nottingham | British | Company Director | 50203880001 | |||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Administrateur | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire | United Kingdom | British | Finance Director | 137285750001 | ||||
LOMBARDO, Marcello | Administrateur | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire | England | British | Finance Director | 135699240001 | ||||
MALONE, Desmond Philip | Administrateur | 1 Morpeth B77 1JF Tamworth Staffordshire | England | British | Director | 87170450001 | ||||
REYNOLDS, Julia | Administrateur | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire | England | British | Chief Executive | 127468460001 | ||||
SPURLING, Anthony James | Administrateur | Park Cottage 49 Park St Lane Park Street AL2 2JA St Albans Hertfordshire | British | Company Director | 5224490001 | |||||
WILKINSON, John Richard | Administrateur | Abbey Cottage 1 Elm Lane Well End SL8 5PF Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Director | 2545190001 |
TEESSIDE SPORTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 29 sept. 1987 Livré le 08 oct. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Brèves mentions 2 alston road pattinson north industrial estate washington tyne & wear. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 25 avr. 1983 Livré le 29 avr. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Lease/hold units 3 and 4 hill street shopping centre hill street, middlesborough cleveland and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 22 sept. 1982 Livré le 27 sept. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all leasehold and freehold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge as undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & the benefit of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0